TROCADERO HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTROCADERO HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02924372
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TROCADERO HOLDINGS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe TROCADERO HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Novus Leisure Limited Third Floor Clareville House
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TROCADERO HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BURFORD (1994) LIMITED24 mai 199424 mai 1994
    SPEED 4334 LIMITED29 avr. 199429 avr. 1994

    Quels sont les derniers comptes de TROCADERO HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour TROCADERO HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 6

    5 pagesMR05
    L6HCF5BU

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    L6G8ENE2

    legacy

    1 pagesSH20
    L6FJ1EO3

    État du capital au 22 sept. 2017

    • Capital: USD 1
    3 pagesSH19
    L6FJ1EOB

    legacy

    1 pagesCAP-SS
    L6FJ1EOJ

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01
    X67KWHQJ

    Cessation de la nomination de Gregor Grant en tant que secrétaire le 30 sept. 2016

    1 pagesTM02
    X5KTYIPM

    Cessation de la nomination de Gregor Grant en tant que directeur le 30 sept. 2016

    1 pagesTM01
    X5JT4SFV

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    8 pagesAA
    L5GHWKRS

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 mai 2016

    État du capital au 24 mai 2016

    • Capital: GBP 2
    • Capital: USD 23,443,641.88
    SH01
    X57NXKIW

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    9 pagesAA
    L4H19V74

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 juin 2015

    État du capital au 01 juin 2015

    • Capital: GBP 2
    • Capital: USD 23,443,641.88
    SH01
    X48N40E0

    Nomination de Mr Toby Coultas Smith en tant qu'administrateur le 30 oct. 2014

    2 pagesAP01
    X3L4N2FF

    Cessation de la nomination de Timothy Edward Cullum en tant que directeur le 10 oct. 2014

    1 pagesTM01
    X3L4N1A9

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    9 pagesAA
    A3HHVNZL

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 mai 2014

    État du capital au 28 mai 2014

    • Capital: GBP 2
    • Capital: USD 23,443,641.88
    SH01
    X38UWWJ4

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    9 pagesAA
    A2I06W9V

    Nomination de Mr Gregor Grant en tant que secrétaire

    1 pagesAP03
    X2BWRTMQ

    Cessation de la nomination de Linda Bulloch en tant que secrétaire

    1 pagesTM02
    X2BWRTAH

    Nomination de Mr Timonty Edward Cullum en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01
    X2BH9SSJ

    Cessation de la nomination de Stephen Richards en tant que directeur

    1 pagesTM01
    X2BH8PJK

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Annotations
    DateAnnotation
    13 janv. 2022Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 13/01/2022 under section 1088 of the Companies Act 2006
    X26T0237

    Qui sont les dirigeants de TROCADERO HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMITH, Toby Coultas
    Third Floor Clareville House
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    C/O Novus Leisure Limited
    Administrateur
    Third Floor Clareville House
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    C/O Novus Leisure Limited
    United KingdomBritishDirector192861090001
    BULLOCH, Linda
    Third Floor Clareville House
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    C/O Novus Leisure Limited
    Secrétaire
    Third Floor Clareville House
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    C/O Novus Leisure Limited
    172734710001
    GARDNER, Malcolm William
    18 Elm Grove Road
    Ealing
    W5 3JJ London
    Secrétaire
    18 Elm Grove Road
    Ealing
    W5 3JJ London
    BritishCompany Director101769350001
    GLEEK, Julian
    47 Gloucester Square
    W2 2TQ London
    Secrétaire
    47 Gloucester Square
    W2 2TQ London
    BritishAccountant112192210001
    GRANT, Gregor
    Third Floor Clareville House
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    C/O Novus Leisure Limited
    Secrétaire
    Third Floor Clareville House
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    C/O Novus Leisure Limited
    179569970001
    HOLBROOK, Jane Susan
    The White House
    Ibstone
    HP14 3XT High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    The White House
    Ibstone
    HP14 3XT High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishDirector89924290002
    KENDALL, Andrew
    Third Floor Clareville House
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    C/O Novus Leisure Limited
    Secrétaire
    Third Floor Clareville House
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    C/O Novus Leisure Limited
    160701430001
    PALMER, Steven Mark
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    Secrétaire
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    BritishDirector63240980001
    SHERRINGTON, James David
    Third Floor Clareville House
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    C/O Novus Leisure Limited
    Secrétaire
    Third Floor Clareville House
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    C/O Novus Leisure Limited
    150303150001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    CAMPBELL, Andrew Maxwell
    Third Floor Clareville House
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    C/O Novus Leisure Limited
    Administrateur
    Third Floor Clareville House
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    C/O Novus Leisure Limited
    United KingdomBritishDirector79519110001
    COHEN, Robert Digby Paul
    West Cottage
    Woodhall Lane
    SL5 9QW Sunningdale
    Berkshire
    Administrateur
    West Cottage
    Woodhall Lane
    SL5 9QW Sunningdale
    Berkshire
    BritishDirector81094700002
    CONLAN, John Oliver
    Sunnydale
    Bellingdon
    HP5 2XU Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Sunnydale
    Bellingdon
    HP5 2XU Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector9020510001
    CULLUM, Timothy Edward
    Third Floor Clareville House
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    C/O Novus Leisure Limited
    Administrateur
    Third Floor Clareville House
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    C/O Novus Leisure Limited
    EnglandUkCompany Director179429160001
    DONOVAN, Patrick Anthony
    83 Earlsfield Road
    Wandsworth
    SW18 3DA London
    Administrateur
    83 Earlsfield Road
    Wandsworth
    SW18 3DA London
    BritishMarketing Director43756830001
    GARDNER, Malcolm William
    18 Elm Grove Road
    Ealing
    W5 3JJ London
    Administrateur
    18 Elm Grove Road
    Ealing
    W5 3JJ London
    EnglandBritishCompany Director101769350001
    GLEEK, Julian
    47 Gloucester Square
    W2 2TQ London
    Administrateur
    47 Gloucester Square
    W2 2TQ London
    EnglandBritishAccountant112192210001
    GRANT, Gregor
    Third Floor Clareville House
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    C/O Novus Leisure Limited
    Administrateur
    Third Floor Clareville House
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    C/O Novus Leisure Limited
    EnglandBritishDirector177579630001
    HOLBROOK, Jane Susan
    The White House
    Ibstone
    HP14 3XT High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The White House
    Ibstone
    HP14 3XT High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector89924290002
    LESLAU, Nicholas Mark
    Romneys House 5 Holly Bush Hill
    Hampstead Village
    NW3 6SH London
    Administrateur
    Romneys House 5 Holly Bush Hill
    Hampstead Village
    NW3 6SH London
    BritishChartered Surveyor6815470006
    PALMER, Steven Mark
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    Administrateur
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    EnglandBritishDirector63240980001
    RICHARDS, Stephen
    CV32
    Administrateur
    CV32
    EnglandBritishDirector187618040002
    TAMBLYN, Nicholas
    Clouds Hill Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Clouds Hill Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Surrey
    EnglandBritishDirector27144350003
    WRAY, Nigel William
    20 Thayer Street
    W1M 6DD London
    Administrateur
    20 Thayer Street
    W1M 6DD London
    BritishCompany Director45400750002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TROCADERO HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Trocadero No.2 Limited
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    Third Floor Clareville House
    England
    06 avr. 2016
    26-27 Oxendon Street
    SW1Y 4EL London
    Third Floor Clareville House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.

    TROCADERO HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 27 juil. 2012
    Livré le 10 août 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Haymarket Financial LLP
    Transactions
    • 10 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 oct. 2017Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    Deed of accession
    Créé le 27 juil. 2009
    Livré le 01 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due of each present or future member of the group to the security trustee and/or the other secured parties (or any of them)on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First legal mortgage , the real property, first fixed charge, all other real property all licences all other agreements relating to land see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of accession
    Créé le 25 juin 2009
    Livré le 09 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Schedules - A3D2 limited - abacuse g/f and basement 24 cornhill london t/no. NGL828941, the abbey st clare house 30-33 minories london t/nos. NGL803593 & NGL893971, agenda builidng no. 1 minster court 3 mincing lane london t/no. NGL694560 for details of further properties please see form 395 with full title guarantee in accordance with the law of property as continuing security for payment of the secured obligations see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Accession deed to a debenture dated 8 september 2005 and
    Créé le 28 déc. 2005
    Livré le 13 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 13 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 09 juil. 1998
    Livré le 11 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0