FAVERMEAD INVESTMENTS LIMITED

FAVERMEAD INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFAVERMEAD INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02929415
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FAVERMEAD INVESTMENTS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe FAVERMEAD INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Nour House
    2 Old Burlington Street
    W1S 3AD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de FAVERMEAD INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour FAVERMEAD INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 20 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Nasser David Khalili en tant que directeur le 11 mai 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Benjamin Henri Khalili en tant qu'administrateur le 01 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Raphael Rene Khalili en tant qu'administrateur le 01 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Marion Sophie Khalili en tant que secrétaire le 31 janv. 2017

    1 pagesTM02

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2016

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 mai 2016

    État du capital au 27 mai 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 juin 2015

    État du capital au 30 juin 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Marion Sophie Khalili le 01 janv. 2015

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Professor Nasser David Khalili le 01 janv. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 mai 2014

    État du capital au 27 mai 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2009

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de FAVERMEAD INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KHALILI, Benjamin Henri
    2 Old Burlington Street
    W1S 3AD London
    Nour House
    Administrateur
    2 Old Burlington Street
    W1S 3AD London
    Nour House
    EnglandBritishCompany Director115894400005
    KHALILI, Raphael Rene
    2 Old Burlington Street
    W1S 3AD London
    Nour House
    Administrateur
    2 Old Burlington Street
    W1S 3AD London
    Nour House
    EnglandBritishCompany Director122865890003
    KHALILI, Marion Sophie
    2 Old Burlington Street
    W1S 3AD London
    Nour House
    Secrétaire
    2 Old Burlington Street
    W1S 3AD London
    Nour House
    British56877660001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    KHALILI, Nasser David, Professor
    2 Old Burlington Street
    W1S 3AD London
    Nour House
    Administrateur
    2 Old Burlington Street
    W1S 3AD London
    Nour House
    EnglandEnglishConsultant18545230004
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FAVERMEAD INVESTMENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Miss Esther Iseppi
    2 Old Burlington Street
    W1S 3AD London
    Nour House
    06 avr. 2016
    2 Old Burlington Street
    W1S 3AD London
    Nour House
    Non
    Nationalité: Swiss
    Pays de résidence: Channel Isles
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une fiducie, et les fiduciaires de cette fiducie (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    FAVERMEAD INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 16 oct. 1998
    Livré le 28 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under pursuant or in connection with the sterling term loan agreement dated 13 october 1998 together with any subsequent amendments thereto replacements thereof and supplemental agreements in relation thereto agreed between such parties together with any other sums defined as "secured obligations" in the mortgage debenture
    Brèves mentions
    F/H property k/a the quintins centre hailsham east sussex t/n ESX165903. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Westfalische Hypothekenbank A.G.
    Transactions
    • 28 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of rent account
    Créé le 16 oct. 1998
    Livré le 28 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of the sterling term loan agreement dated 13 october 1998 together with any other sums defined as "secured obligations" in the assignment of rent account
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the monies paid into and/or standing to the credit of natwest bank PLC branch sort code 56-00-25 account number 07024940.
    Personnes ayant droit
    • Westfalische Hypothekenbank A.G.
    Transactions
    • 28 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment by way of charge
    Créé le 02 juil. 1997
    Livré le 22 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union mortgage finance limited and any company which is or becomes a holding company of any such company or subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Assigns all rights titles benefits and interest in all monies due under the occupational lease/s in respect of 116-118 clerkenwell road and 18-19 clerkenwell green finsbury islington other than sums due by way of insurance rent or service charge or any vat payable thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transactions
    • 22 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of legal charge
    Créé le 02 juil. 1997
    Livré le 22 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union mortgage finance limited and any company which is or becomes a holding company of any such company or subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 116-118 clerkenwell road and 18-19 clerkenwell green london EC1 t/n NGL327061, together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fitting thereon and all improvements and additions thereto and all easements rights and licences appurtenant thereto, all monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the deed, floating charge the whole property, assets, rights and revenues including uncalled share capital (if any).
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transactions
    • 22 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 févr. 1996
    Livré le 21 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the legal charge
    Brèves mentions
    F/Hold property - st nicholas arcades,gt.john street,lancaster; la 728493 with all fixtures/fittings,plant,machinery thereon.......all rents/chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Ag
    Transactions
    • 21 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 14 févr. 1996
    Livré le 21 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the legal charge
    Brèves mentions
    F/Hold property - princes mead shopping centre,farnborough; hp 396289 and st nicholas arcades,gt john street,lancaster; la 728493 and la 739304; all buildings,fixtures/fittings,fixed plant,machinery thereon.......all other rights out of patents,trade service and other marks......etc ; all book/other debts and all shares,stocks,bonds.....etc......see form 395. undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Ag
    Transactions
    • 21 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 févr. 1996
    Livré le 21 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the legal charge
    Brèves mentions
    F/Hold property - princes mead shopping centre,farnborough; hp 396289; all fixtures/fittings,plant,equipment thereon.......all rents/chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Ag
    Transactions
    • 21 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 févr. 1996
    Livré le 21 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the legal charge
    Brèves mentions
    Land forming part of access platform area/stairway,st nicholas arcades,gt john street,lancaster; la 739304 with all fixtures/fittings,plant and equipment thereon; all rents,the chattels.......etc. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Ag
    Transactions
    • 21 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Bank account security deed
    Créé le 14 févr. 1996
    Livré le 21 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the facility agreement,the bank security,the guarantee,the debenture,the legal charges and the share mortgage
    Brèves mentions
    The bank accounts with national westminster bank PLC from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Ag
    Transactions
    • 21 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0