FAVERMEAD INVESTMENTS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | FAVERMEAD INVESTMENTS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02929415 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe FAVERMEAD INVESTMENTS LIMITED ?
Adresse du siège social | Nour House 2 Old Burlington Street W1S 3AD London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de FAVERMEAD INVESTMENTS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour FAVERMEAD INVESTMENTS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nasser David Khalili en tant que directeur le 11 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Benjamin Henri Khalili en tant qu'administrateur le 01 févr. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Raphael Rene Khalili en tant qu'administrateur le 01 févr. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Marion Sophie Khalili en tant que secrétaire le 31 janv. 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Marion Sophie Khalili le 01 janv. 2015 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Professor Nasser David Khalili le 01 janv. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2012 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2011 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2010 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2009 | 5 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de FAVERMEAD INVESTMENTS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHALILI, Benjamin Henri | Administrateur | 2 Old Burlington Street W1S 3AD London Nour House | England | British | Company Director | 115894400005 | ||||
KHALILI, Raphael Rene | Administrateur | 2 Old Burlington Street W1S 3AD London Nour House | England | British | Company Director | 122865890003 | ||||
KHALILI, Marion Sophie | Secrétaire | 2 Old Burlington Street W1S 3AD London Nour House | British | 56877660001 | ||||||
HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
KHALILI, Nasser David, Professor | Administrateur | 2 Old Burlington Street W1S 3AD London Nour House | England | English | Consultant | 18545230004 | ||||
HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Administrateur désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FAVERMEAD INVESTMENTS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
---|---|---|---|
Miss Esther Iseppi | 06 avr. 2016 | 2 Old Burlington Street W1S 3AD London Nour House | Non |
Nationalité: Swiss Pays de résidence: Channel Isles | |||
Nature du contrôle
|
FAVERMEAD INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Créé le 16 oct. 1998 Livré le 28 oct. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under pursuant or in connection with the sterling term loan agreement dated 13 october 1998 together with any subsequent amendments thereto replacements thereof and supplemental agreements in relation thereto agreed between such parties together with any other sums defined as "secured obligations" in the mortgage debenture | |
Brèves mentions F/H property k/a the quintins centre hailsham east sussex t/n ESX165903. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignment of rent account | Créé le 16 oct. 1998 Livré le 28 oct. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of the sterling term loan agreement dated 13 october 1998 together with any other sums defined as "secured obligations" in the assignment of rent account | |
Brèves mentions All right title and interest in and to the monies paid into and/or standing to the credit of natwest bank PLC branch sort code 56-00-25 account number 07024940. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignment by way of charge | Créé le 02 juil. 1997 Livré le 22 juil. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union mortgage finance limited and any company which is or becomes a holding company of any such company or subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever | |
Brèves mentions Assigns all rights titles benefits and interest in all monies due under the occupational lease/s in respect of 116-118 clerkenwell road and 18-19 clerkenwell green finsbury islington other than sums due by way of insurance rent or service charge or any vat payable thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of legal charge | Créé le 02 juil. 1997 Livré le 22 juil. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union mortgage finance limited and any company which is or becomes a holding company of any such company or subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a 116-118 clerkenwell road and 18-19 clerkenwell green london EC1 t/n NGL327061, together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fitting thereon and all improvements and additions thereto and all easements rights and licences appurtenant thereto, all monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the deed, floating charge the whole property, assets, rights and revenues including uncalled share capital (if any). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 14 févr. 1996 Livré le 21 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the legal charge | |
Brèves mentions F/Hold property - st nicholas arcades,gt.john street,lancaster; la 728493 with all fixtures/fittings,plant,machinery thereon.......all rents/chattels. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 14 févr. 1996 Livré le 21 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the legal charge | |
Brèves mentions F/Hold property - princes mead shopping centre,farnborough; hp 396289 and st nicholas arcades,gt john street,lancaster; la 728493 and la 739304; all buildings,fixtures/fittings,fixed plant,machinery thereon.......all other rights out of patents,trade service and other marks......etc ; all book/other debts and all shares,stocks,bonds.....etc......see form 395. undertaking and all property and assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 14 févr. 1996 Livré le 21 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the legal charge | |
Brèves mentions F/Hold property - princes mead shopping centre,farnborough; hp 396289; all fixtures/fittings,plant,equipment thereon.......all rents/chattels. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 14 févr. 1996 Livré le 21 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the legal charge | |
Brèves mentions Land forming part of access platform area/stairway,st nicholas arcades,gt john street,lancaster; la 739304 with all fixtures/fittings,plant and equipment thereon; all rents,the chattels.......etc. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Bank account security deed | Créé le 14 févr. 1996 Livré le 21 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the facility agreement,the bank security,the guarantee,the debenture,the legal charges and the share mortgage | |
Brèves mentions The bank accounts with national westminster bank PLC from time to time. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0