RUDGE NEWBY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRUDGE NEWBY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02930014
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RUDGE NEWBY LIMITED ?

    • (2742) /
    • (2744) /
    • (2751) /
    • (3663) /

    Où se situe RUDGE NEWBY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Aspect Court
    4 Temple Row
    B2 5HG Birmingham
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RUDGE NEWBY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RUDGE LITTLEY LIMITED02 sept. 199402 sept. 1994
    FLIPTOP LIMITED18 mai 199418 mai 1994

    Quels sont les derniers comptes de RUDGE NEWBY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 1999

    Quels sont les derniers dépôts pour RUDGE NEWBY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    pagesGAZ1

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Roy Everett en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    1 pages288b

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    3 pages3.6

    legacy

    1 pages405(2)

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 19 avr. 2001

    3 pages1.3

    Déclaration des affaires en administration judiciaire suite au rapport aux créanciers

    14 pages3.3

    Rapport du séquestre administratif

    9 pages3.10

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    1 pages405(1)

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 30 juin 1999

    22 pagesAA

    legacy

    10 pages363s
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    annual-return05 juil. 2000

    legacy

    363(288)

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de RUDGE NEWBY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COWLEY, Stephen Robert
    12 Canterbury Drive
    WS7 9JX Burntwood
    Staffordshire
    Administrateur
    12 Canterbury Drive
    WS7 9JX Burntwood
    Staffordshire
    BritishFinance Director70032670001
    DELFINO RICE, Peter John
    107 Clarence Avenue
    NN2 6NY Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    107 Clarence Avenue
    NN2 6NY Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector71634970001
    JOHNSON, Richard Charles
    Burrs Cottage
    Great Hucklow
    SK17 8RF Buxton
    Derbyshire
    Administrateur
    Burrs Cottage
    Great Hucklow
    SK17 8RF Buxton
    Derbyshire
    BritishConsultant59372090002
    BANNISTER, Clare Patricia
    74 Compton Road
    DY9 0TH Stourbridge
    West Midlands
    Secrétaire
    74 Compton Road
    DY9 0TH Stourbridge
    West Midlands
    BritishSolicitor33394020001
    FAHEY, Patrick Joseph
    7 Stonelea Close
    Stone Cross
    B71 2LT West Bromwich
    West Midlands
    Secrétaire
    7 Stonelea Close
    Stone Cross
    B71 2LT West Bromwich
    West Midlands
    British35344460002
    KINDER, Andrew Nicholas
    291 Foley Road West
    Streetly
    B74 3NU Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    291 Foley Road West
    Streetly
    B74 3NU Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishDirector77155950001
    BALL, Julian Alastair
    58 Highgrove Road
    Trent Vale
    ST4 5PD Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    58 Highgrove Road
    Trent Vale
    ST4 5PD Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishTrainee Solicitor44731960002
    BANNISTER, Clare Patricia
    74 Compton Road
    DY9 0TH Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    74 Compton Road
    DY9 0TH Stourbridge
    West Midlands
    BritishSolicitor33394020001
    CRANE, John Michael
    Flat 3 The Cedars
    Wych Elm Close
    Worcester
    Administrateur
    Flat 3 The Cedars
    Wych Elm Close
    Worcester
    BritishCompany Director26183730003
    EVERETT, Roy Geoffrey
    15 Ledwych Gardens
    WR9 9LL Droitwich
    Worcestershire
    Administrateur
    15 Ledwych Gardens
    WR9 9LL Droitwich
    Worcestershire
    EnglandBritishCompany Director7912650001
    GILES, William Michael
    52 Fredas Grove
    Harborne
    B17 0SY Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    52 Fredas Grove
    Harborne
    B17 0SY Birmingham
    West Midlands
    BritishSolicitor39602220001
    KINDER, Andrew Nicholas
    291 Foley Road West
    Streetly
    B74 3NU Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    291 Foley Road West
    Streetly
    B74 3NU Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishFinance Director77155950001
    MARTIN, Brian
    24 Hopkins Drive
    Off Pennyhill Lane
    B71 3RT West Bromwich
    West Midlands
    Administrateur
    24 Hopkins Drive
    Off Pennyhill Lane
    B71 3RT West Bromwich
    West Midlands
    BritishCompany Director26183710001
    NEWBY, Richard Cannock
    Lynn House
    Lynn
    WS14 0ER Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    Lynn House
    Lynn
    WS14 0ER Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Director16029120001
    PITCHER, Alan Victor
    21 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    21 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    BritishOperations Director57191510001
    PURCELL, Dennis Anthony
    2 Buttermere Close
    Chadsmoor
    WS11 2EE Cannock
    Staffordshire
    Administrateur
    2 Buttermere Close
    Chadsmoor
    WS11 2EE Cannock
    Staffordshire
    BritishCompany Director40050030001
    SHARP, Keith
    Harewood House
    4 Spa Crescent
    TF5 0DH Admaston
    Shropshire
    Administrateur
    Harewood House
    4 Spa Crescent
    TF5 0DH Admaston
    Shropshire
    EnglandBritishCompany Director77395770001
    SPROSTON, Chris
    1 Elmwood Close
    Gnosall
    ST20 0RR Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    1 Elmwood Close
    Gnosall
    ST20 0RR Stafford
    Staffordshire
    BritishCompany Director64088280001
    WILLETTS, John
    Blenheim Court
    Alsager
    ST7 2BY Stoke On Trent
    19
    Staffordshire
    Administrateur
    Blenheim Court
    Alsager
    ST7 2BY Stoke On Trent
    19
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director172402590001

    RUDGE NEWBY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 15 juil. 1999
    Livré le 21 juil. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bny International Limited
    Transactions
    • 21 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 août 2000Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
    • 15 juil. 2003Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (405 (2))
      • Numéro de dossier 2
    Equipment mortgage
    Créé le 15 juil. 1999
    Livré le 21 juil. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to this mortgage
    Brèves mentions
    The equipment: see attached list. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bny International Limited
    Transactions
    • 21 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Chattel mortgage
    Créé le 15 avr. 1999
    Livré le 30 avr. 1999
    En cours
    Montant garanti
    £500,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage
    Brèves mentions
    The equipment and any part thereof the first three items of which are a transformers & rectifiers 1685KVA 11000V/2 x 575V transformer s/no.TG9597, a cy electrical 2 tonne x 36FT eot crane twin beam pendant and radio control with magnet facility s/no.1164, A demag 10 tonne x 50FT eot crane twin beam pendant and radio control s/no.dmh 8114-97. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transactions
    • 30 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 04 juin 1998
    Livré le 10 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transactions
    • 10 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 03 nov. 1997
    Livré le 07 nov. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All assets located at rudge littley limited, swan village, west bromwich, west midlands (see schedules attached to form M395 for full details) the plant machinery chattels or other equipment, benefit of any guarantee , warranty or other obligation, agreements, copyrights, patents, trademarks, insurances etc.. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 02 juil. 1996
    Livré le 04 juil. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 04 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Chattel mortgage
    Créé le 02 sept. 1994
    Livré le 22 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £400,000 due from the company to the chargee pursuant to the terms of a sale and purchase agreement dated 2 september 1994
    Brèves mentions
    The fixed and moveable plant equipment accquired by the company on 2 september 1994 from fliptop limited co. Number 106260 together with all spare parts replacements and modifications in favour of the mortgagee. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Edward Williams Holdings Limited
    Transactions
    • 22 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 sept. 1994
    Livré le 22 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Edward Williams Holdings Limited
    Transactions
    • 22 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    RUDGE NEWBY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 avr. 2000Date of meeting to approve CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    William John Kelly
    10th Floor 1 Temple Row
    B2 5HG Birmingham
    practitioner
    10th Floor 1 Temple Row
    B2 5HG Birmingham
    Gurpil Singh Johal
    Kroll Limited
    Aspect Court
    B2 5HG 4 Temple Row
    Birmingham
    practitioner
    Kroll Limited
    Aspect Court
    B2 5HG 4 Temple Row
    Birmingham
    2
    DateType
    15 juil. 1999Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    William John Kelly
    10th Floor 1 Temple Row
    B2 5HG Birmingham
    practitioner
    10th Floor 1 Temple Row
    B2 5HG Birmingham
    Andrew Gordon Stoneman
    Kroll Buchler Phillips
    Aspect Court
    B2 5HG 4 Temple Row
    Birmingham
    practitioner
    Kroll Buchler Phillips
    Aspect Court
    B2 5HG 4 Temple Row
    Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0