XCESS PROPERTY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéXCESS PROPERTY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02935446
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de XCESS PROPERTY LIMITED ?

    • (7012) /

    Où se situe XCESS PROPERTY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BAKER TILLY
    6th Floor 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de XCESS PROPERTY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WHOLESALE DIRECT LIMITED03 juin 199403 juin 1994

    Quels sont les derniers comptes de XCESS PROPERTY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au02 juil. 2005

    Quels sont les derniers dépôts pour XCESS PROPERTY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    1 pages4.43

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:Liquidator's Progress Report 25/07/2011
    13 pagesLIQ MISC

    Changement d'adresse du siège social de 5 Old Bailey London Ec4M 7a7 le 29 nov. 2010

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur

    6 pages4.31

    Changement d'adresse du siège social de Pricewaterhousecoopers Llp Plumtree Court London EC4A 4HT le 01 sept. 2010

    2 pagesAD01

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    1 pagesCOCOMP

    Cessation de la nomination de Paul Sellars en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    1 pagesCOCOMP

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de réimmatriculation

    RES02

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    10 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    10 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    15 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    22 pages2.24B

    legacy

    1 pages287

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    68 pages2.17B

    Déclaration des affaires

    6 pages2.16B

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    2 pages363a

    Qui sont les dirigeants de XCESS PROPERTY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LAWSON, Timothy David
    Brompton House
    School Lane Stadhampton
    OX44 7TR Oxford
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Brompton House
    School Lane Stadhampton
    OX44 7TR Oxford
    Oxfordshire
    British111902410001
    LAWSON, Timothy David
    Brompton House
    School Lane Stadhampton
    OX44 7TR Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Brompton House
    School Lane Stadhampton
    OX44 7TR Oxford
    Oxfordshire
    British111902410001
    LITTLE, Mark John James
    Farringford
    Harlestone Road
    NN6 8AU Church Brampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Farringford
    Harlestone Road
    NN6 8AU Church Brampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish149016530001
    KHOSLA, Anil
    71 Osidge Lane
    Southgate
    N14 5JL London
    Secrétaire
    71 Osidge Lane
    Southgate
    N14 5JL London
    British39033980001
    LAWSON, Catherine Jane
    Abbey Farm
    Ravensden Road
    MK41 0LA Renhold
    Bedfordshire
    Secrétaire
    Abbey Farm
    Ravensden Road
    MK41 0LA Renhold
    Bedfordshire
    British40256810004
    GUFFOGG, Milton Ivan
    14 Clifton House Close
    SG17 5EQ Clifton
    Bedfordshire
    Administrateur
    14 Clifton House Close
    SG17 5EQ Clifton
    Bedfordshire
    EnglandBritish185891060001
    LAWSON, Simon James
    Abbey Farm
    Ravensden Road
    MK41 0LA Renhold
    Bedfordshire
    Administrateur
    Abbey Farm
    Ravensden Road
    MK41 0LA Renhold
    Bedfordshire
    United KingdomUnited Kingdom40209540005
    SELLARS, Paul
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    Administrateur
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    EnglandBritish50761250001
    THANDI, Satnam Singh
    94 Midland Road
    LU2 0BL Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    94 Midland Road
    LU2 0BL Luton
    Bedfordshire
    British39249400001

    XCESS PROPERTY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 20 mai 2003
    Livré le 29 mai 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to any security beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Marine mortgage
    Créé le 01 août 2002
    Livré le 08 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    64/64 shares in the ship 2002 princess 56- GMPPT610H102 heidissa - on 905843 and in its appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 08 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Marine mortgage
    Créé le 15 mars 2002
    Livré le 19 mars 2002
    En cours
    Montant garanti
    £480,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    2002 princess 56 GBMPPT6107H102.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 19 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage deed
    Créé le 14 nov. 2001
    Livré le 15 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property 26 sun street waltham abbey t/no;-EX201493. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 15 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 25 juin 2001
    Livré le 03 juil. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 4 & 5 marquis business centre royston road baldock herts. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage
    Créé le 26 mars 2001
    Livré le 29 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property k/a 26 sun street, waltham, abbey, london EN9 1EJ, title number EX201493. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 05 sept. 2000
    Livré le 16 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as 1 hitchin street biggleswade bedfordshire title number BD168386. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 05 sept. 2000
    Livré le 16 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as 124 shirley high street southampton title number HP566045. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 05 sept. 2000
    Livré le 16 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The leasehold property known as unit 8 woodside industrial estate works road letchworth herts. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 juin 1998
    Livré le 27 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 8 woodside industrial park works road letchworth herts. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 12 sept. 1995
    Livré le 18 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    XCESS PROPERTY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 janv. 2007Administration started
    06 févr. 2008Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Michael John Andrew Jervis
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Mark Nicholas Cropper
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    2
    DateType
    27 juil. 2012Conclusion of winding up
    10 mai 2010Petition date
    23 juin 2010Commencement of winding up
    01 nov. 2012Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    practitioner
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    The Official Receiver Or Manchester
    2nd Floor, 3 Piccadilly Place
    London Road
    M1 3BN Manchester
    practitioner
    2nd Floor, 3 Piccadilly Place
    London Road
    M1 3BN Manchester
    Geoffrey Lambert Carton-Kelly
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    practitioner
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0