MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED

MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02936861
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED ?

    • Collecte, traitement et distribution d'eau (36000) / Approvisionnement en eau, assainissement, gestion des déchets et activités de dépollution

    Où se situe MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED ?

    Adresse du siège social
    6 Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    Kent
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MAPLIN ENVIRONMENTAL LIMITED08 juin 199408 juin 1994

    Quels sont les derniers comptes de MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    A5JHMX2O

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 juin 2016

    État du capital au 24 juin 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01
    X59RT0H4

    Changement d'adresse du siège social de 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP à 6 Stirling Park Laker Road Rochester Kent ME1 3QR le 15 juin 2016

    1 pagesAD01
    X596UDXT

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2015

    3 pagesAA
    X57DJO00

    Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2015 au 31 août 2015

    1 pagesAA01
    X4EN8JMP

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 juin 2015

    État du capital au 26 juin 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01
    X4AB22BF

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Unit 2 Derwent Close Warndon Worcester WR4 9TY England à 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP

    1 pagesAD02
    X4AB21ZT

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP

    1 pagesAD04
    X4AB2201

    Nomination de Mr Hugh Francis Edmonds en tant que secrétaire le 14 mai 2015

    2 pagesAP03
    X47HFP5K

    Cessation de la nomination de John William Charles Charlton en tant que secrétaire le 30 avr. 2015

    1 pagesTM02
    X47HE0ZE

    Cessation de la nomination de John William Charles Charlton en tant que directeur le 30 avr. 2015

    1 pagesTM01
    X47HE0R7

    Changement d'adresse du siège social de Unit 2 Derwent Close Warndon Worcester WR4 9TY à 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP le 01 avr. 2015

    1 pagesAD01
    X44DG6JL

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    7 pagesAA
    A3N3PCW1

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2014

    État du capital au 15 juin 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01
    X3A33Y8W

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    7 pagesAA
    A2OF2IBD

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04
    A2J2PT7E

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    X2BH6CYY

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012

    8 pagesAA
    A239GGG2

    Cessation de la nomination de John Prowse en tant que directeur

    1 pagesTM01
    X1ZZ7P9L

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    X1B0SM4Y

    Modification des coordonnées du secrétaire John William Charles Charlton le 07 juin 2012

    2 pagesCH03
    X1B0SM3V

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 7-11 Nelson Street Southend on Sea Essex SS1 1EH

    1 pagesAD02
    X1B0SM4I

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Hodgson le 07 juin 2012

    2 pagesCH01
    X1B0SM4B

    Qui sont les dirigeants de MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EDMONDS, Hugh Francis
    Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    6
    Kent
    England
    Secrétaire
    Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    6
    Kent
    England
    197706140001
    HODGSON, Richard George
    Gunnersbury Crescent
    W3 9AA London
    13
    Administrateur
    Gunnersbury Crescent
    W3 9AA London
    13
    EnglandBritishFinance Director155847280001
    BETTS, Andrew Graham
    89 Essex Way
    SS7 1LR Southend
    Essex
    Secrétaire
    89 Essex Way
    SS7 1LR Southend
    Essex
    British74184230002
    BUTLER, Christopher John
    Roughwood Hill Farm
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    Secrétaire
    Roughwood Hill Farm
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    BritishSales Director94118060001
    CHARLTON, John William Charles
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    British151170420001
    DEDMAN, David Francis
    Little Haven
    2 Trefoil Close
    RG27 8TS Hartley Wintney
    Hampshire
    Secrétaire
    Little Haven
    2 Trefoil Close
    RG27 8TS Hartley Wintney
    Hampshire
    BritishAccountant43888390002
    HOLLAND, James Lindsay
    14 Kingsley Lane
    SS7 3TU Thundersley
    Essex
    Secrétaire
    14 Kingsley Lane
    SS7 3TU Thundersley
    Essex
    British71288860001
    NICHOLLS, Craig Lewis
    18 Bishopsteighton
    Shoeburyness
    SS3 8AF Southend On Sea
    Secrétaire
    18 Bishopsteighton
    Shoeburyness
    SS3 8AF Southend On Sea
    British41940890001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BUTLER, Christopher John
    Roughwood Hill Farm
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    Administrateur
    Roughwood Hill Farm
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    EnglandBritishSales Director94118060001
    BUTLER, Christopher John
    Roughwood Hill Farm
    Hassall
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    Administrateur
    Roughwood Hill Farm
    Hassall
    CW11 4XX Sandbach
    Cheshire
    EnglandBritishDirector94118060001
    CHARLTON, John William Charles
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    Administrateur
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector - Shared Services119598150002
    DEDMAN, David Francis
    Little Haven
    2 Trefoil Close
    RG27 8TS Hartley Wintney
    Hampshire
    Administrateur
    Little Haven
    2 Trefoil Close
    RG27 8TS Hartley Wintney
    Hampshire
    EnglandBritishAccountant43888390002
    FAULDS, Alistair
    Flat 2 Wilow Court
    Rosewood Lane
    SS3 9EW Shoeburyness
    Essex
    Administrateur
    Flat 2 Wilow Court
    Rosewood Lane
    SS3 9EW Shoeburyness
    Essex
    BritishWater Services Contractor39299610002
    HOLLAND, James Lindsay
    Claremont
    Private Road
    CM2 8TH Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Claremont
    Private Road
    CM2 8TH Chelmsford
    Essex
    BritishCompany Director71288860002
    HOLLAND, Mabel Grace
    22 Rowan Way
    Canewdon
    SS4 3PD Rochford
    Essex
    Administrateur
    22 Rowan Way
    Canewdon
    SS4 3PD Rochford
    Essex
    BritishCompany Secretary41940950001
    LEE, Michael William
    Fern Cottage
    Dark Lane, Bliss Gate
    DY14 9YN Rock Nr. Bewdley
    Worcestershire
    Administrateur
    Fern Cottage
    Dark Lane, Bliss Gate
    DY14 9YN Rock Nr. Bewdley
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector66729790001
    NICHOLLS, Craig Lewis
    18 Wambrook
    Shoeburyness
    SS3 8BW Southend On Sea
    Essex
    Administrateur
    18 Wambrook
    Shoeburyness
    SS3 8BW Southend On Sea
    Essex
    BritishContract Manager41940890002
    PROWSE, John
    Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    317
    Essex
    Administrateur
    Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    317
    Essex
    EnglandBritishChief Executive Officer96786510001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 avr. 2010
    Livré le 12 mai 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 15 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 août 2000
    Livré le 31 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 31 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 04 août 2000
    Livré le 05 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 05 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 10 août 1998
    Livré le 27 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and pursuant to or in connection with a financing agreement (as therein defined) and on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 27 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 mars 1998
    Livré le 25 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 19 sirdar road raylthe goodwill of the business and the proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 mars 1998
    Livré le 11 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security interest agreement
    Créé le 02 mars 1998
    Livré le 10 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All sums now and in the future credited to account number/designation Q999-1 held by the company with the royal bank of scotland international limited or any account which derives in whole or in part from such account.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Créé le 26 août 1997
    Livré le 05 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debts or debts which were then or thereafter owing to the company on the account or accounts number 7125695 and all interest (if any). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 05 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 29 avr. 1997
    Livré le 03 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 03 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0