MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02936861 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED ?
Adresse du siège social | 6 Stirling Park Laker Road ME1 3QR Rochester Kent England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 août 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP à 6 Stirling Park Laker Road Rochester Kent ME1 3QR le 15 juin 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2015 | 3 pages | AA | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2015 au 31 août 2015 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Unit 2 Derwent Close Warndon Worcester WR4 9TY England à 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP | 1 pages | AD04 | ||||||||||
Nomination de Mr Hugh Francis Edmonds en tant que secrétaire le 14 mai 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John William Charles Charlton en tant que secrétaire le 30 avr. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John William Charles Charlton en tant que directeur le 30 avr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Unit 2 Derwent Close Warndon Worcester WR4 9TY à 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP le 01 avr. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013 | 7 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 9 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012 | 8 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Prowse en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 08 juin 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire John William Charles Charlton le 07 juin 2012 | 2 pages | CH03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 7-11 Nelson Street Southend on Sea Essex SS1 1EH | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Hodgson le 07 juin 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMONDS, Hugh Francis | Secrétaire | Stirling Park Laker Road ME1 3QR Rochester 6 Kent England | 197706140001 | |||||||
HODGSON, Richard George | Administrateur | Gunnersbury Crescent W3 9AA London 13 | England | British | Finance Director | 155847280001 | ||||
BETTS, Andrew Graham | Secrétaire | 89 Essex Way SS7 1LR Southend Essex | British | 74184230002 | ||||||
BUTLER, Christopher John | Secrétaire | Roughwood Hill Farm CW11 4XX Sandbach Cheshire | British | Sales Director | 94118060001 | |||||
CHARLTON, John William Charles | Secrétaire | Neata Farm Greet GL54 5BL Cheltenham Rowan Lodge Gloucestershire | British | 151170420001 | ||||||
DEDMAN, David Francis | Secrétaire | Little Haven 2 Trefoil Close RG27 8TS Hartley Wintney Hampshire | British | Accountant | 43888390002 | |||||
HOLLAND, James Lindsay | Secrétaire | 14 Kingsley Lane SS7 3TU Thundersley Essex | British | 71288860001 | ||||||
NICHOLLS, Craig Lewis | Secrétaire | 18 Bishopsteighton Shoeburyness SS3 8AF Southend On Sea | British | 41940890001 | ||||||
WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
BUTLER, Christopher John | Administrateur | Roughwood Hill Farm CW11 4XX Sandbach Cheshire | England | British | Sales Director | 94118060001 | ||||
BUTLER, Christopher John | Administrateur | Roughwood Hill Farm Hassall CW11 4XX Sandbach Cheshire | England | British | Director | 94118060001 | ||||
CHARLTON, John William Charles | Administrateur | Neata Farm Greet GL54 5BL Cheltenham Rowan Lodge Gloucestershire | England | British | Director - Shared Services | 119598150002 | ||||
DEDMAN, David Francis | Administrateur | Little Haven 2 Trefoil Close RG27 8TS Hartley Wintney Hampshire | England | British | Accountant | 43888390002 | ||||
FAULDS, Alistair | Administrateur | Flat 2 Wilow Court Rosewood Lane SS3 9EW Shoeburyness Essex | British | Water Services Contractor | 39299610002 | |||||
HOLLAND, James Lindsay | Administrateur | Claremont Private Road CM2 8TH Chelmsford Essex | British | Company Director | 71288860002 | |||||
HOLLAND, Mabel Grace | Administrateur | 22 Rowan Way Canewdon SS4 3PD Rochford Essex | British | Company Secretary | 41940950001 | |||||
LEE, Michael William | Administrateur | Fern Cottage Dark Lane, Bliss Gate DY14 9YN Rock Nr. Bewdley Worcestershire | England | British | Director | 66729790001 | ||||
NICHOLLS, Craig Lewis | Administrateur | 18 Wambrook Shoeburyness SS3 8BW Southend On Sea Essex | British | Contract Manager | 41940890002 | |||||
PROWSE, John | Administrateur | Ongar Road CM15 9HP Brentwood 317 Essex | England | British | Chief Executive Officer | 96786510001 | ||||
WATERLOW NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
MAPLIN A DIVISION OF WATERCHEM LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 30 avr. 2010 Livré le 12 mai 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 21 août 2000 Livré le 31 août 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed charge on purchased debts which fail to vest | Créé le 04 août 2000 Livré le 05 août 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise | |
Brèves mentions By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 10 août 1998 Livré le 27 août 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee and pursuant to or in connection with a financing agreement (as therein defined) and on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 18 mars 1998 Livré le 25 mars 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The f/h property k/a 19 sirdar road raylthe goodwill of the business and the proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 06 mars 1998 Livré le 11 mars 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Security interest agreement | Créé le 02 mars 1998 Livré le 10 mars 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All sums now and in the future credited to account number/designation Q999-1 held by the company with the royal bank of scotland international limited or any account which derives in whole or in part from such account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deposit agreement to secure own liabilities | Créé le 26 août 1997 Livré le 05 sept. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All such rights to the repayment of the deposit meaning the debts or debts which were then or thereafter owing to the company on the account or accounts number 7125695 and all interest (if any). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture deed | Créé le 29 avr. 1997 Livré le 03 mai 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0