VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED

VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02939633
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    3175 Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SHAFTON ENGINEERING SERVICES LIMITED11 juil. 199411 juil. 1994
    SOUNDTEST LIMITED16 juin 199416 juin 1994

    Quels sont les derniers comptes de VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    5 pagesDS01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    resolution

    Résolution de capitalisation ou d'émission d'actions gratuites

    The sum of £24604 be capitalised 13/07/2023
    RES14

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution de capitalisation ou d'émission d'actions gratuites

    Capitalise sum of £31564 12/07/2023
    RES14
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    État du capital au 14 juil. 2023

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital après une attribution d'actions au 13 juil. 2023

    • Capital: GBP 24,605
    3 pagesSH01

    État du capital au 13 juil. 2023

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital après une attribution d'actions au 12 juil. 2023

    • Capital: GBP 31,565
    3 pagesSH01

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2022

    5 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Renew Corporate Director Limited le 01 oct. 2019

    1 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Renew Nominees Limited le 01 oct. 2019

    1 pagesCH04

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2021

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2020

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175 Century Way
    England
    Secrétaire
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175 Century Way
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement02939633
    41291250014
    SCOTT, Paul
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175
    England
    Administrateur
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175
    England
    EnglandBritish63708460003
    WILSON, Gordon Ian
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175
    England
    Administrateur
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175
    England
    United KingdomBritish263424170001
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175 Century Way
    England
    Administrateur
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175 Century Way
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement4843611
    91993060004
    BARKER, Roger Winston
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    British59419910001
    GREASLEY, Antony Frederick
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    British69165360001
    LITTLEHALES, Richard
    10 Oaklands Avenue
    Adel
    LS16 8NR Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    10 Oaklands Avenue
    Adel
    LS16 8NR Leeds
    West Yorkshire
    British57288230001
    PARKINSON, John
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    British10307790002
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire désigné
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BARKER, Roger Winston
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    British59419910001
    FEAST, Roger
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    Administrateur
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    British66800550001
    GREASLEY, Antony Frederick
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish69165360001
    LITTLEHALES, Richard
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    British57288230002
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Administrateur
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    British1571200002
    PARKINSON, John
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish10307790002
    PEARSON, Valerie
    Phoenix House
    Hawthorn Park
    LS14 1PQ Leeds
    Administrateur
    Phoenix House
    Hawthorn Park
    LS14 1PQ Leeds
    British82999480006
    SAMUEL, John William Young Strachan
    Charnwood Easby Drive
    LS29 9AZ Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Charnwood Easby Drive
    LS29 9AZ Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish3909060002
    STIFF, Stephen
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175
    England
    Administrateur
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175
    England
    United KingdomBritish111161720001
    THOMSON, Brian Malcolm
    Amber Manor Farm
    Alice Head Road Stonedge
    S45 0DQ Ashover
    Derbyshire
    Administrateur
    Amber Manor Farm
    Alice Head Road Stonedge
    S45 0DQ Ashover
    Derbyshire
    British5774340006
    UNDERWOOD, Philip John
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Administrateur
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    British59420330011
    WALDRON, Brian Geoffrey
    Fir Tree Cottage 4 Chapel Lane
    Billingley
    S72 0HZ Barnsley
    South Yorkshire
    Administrateur
    Fir Tree Cottage 4 Chapel Lane
    Billingley
    S72 0HZ Barnsley
    South Yorkshire
    GibraltarBritish4324630001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur désigné
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    Yew Trees
    West Yorkshire
    United Kingdom
    01 août 2016
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    Yew Trees
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1457182
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 03 oct. 2007
    Livré le 19 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mars 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 05 janv. 2005
    Livré le 20 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 02 juil. 1996
    Livré le 09 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £237,222 and all other sums due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The items set out in the schedule to form 395 together with all accessories spare parts component parts and all improvements and renewals thereof and all books manuals and handbooks.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transactions
    • 09 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 juin 1996
    Livré le 13 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land on the east side of engine lane shafton near barnsley south yorks and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 21 sept. 1995
    Livré le 27 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the plant machinery chattels or other equipment listed in the scedule to the form 395 inclusive of kue ken 114 serial no. M819, kue ken 114 serial no. M4820 and kue ken 120 serial no. M4839 together with any parts thereof and all additions and alterations etc. thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 27 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 06 juil. 1995
    Livré le 11 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £584,676 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Various goods including all books manuals handbooks technical date drawings etc belonging to the goods as set out in the schedule to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transactions
    • 11 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 sept. 1994
    Livré le 06 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 sept. 1994
    Livré le 06 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/as shafton workshops, shafton, barnsley, south yorkshire t/no SYK44893.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0