GUINNESS PEAT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | GUINNESS PEAT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02943282 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GUINNESS PEAT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED ?
Adresse du siège social | 4 Longwalk Road Stockley Park UB11 1FE Uxbridge England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GUINNESS PEAT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour GUINNESS PEAT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Claire Thompson en tant que directeur le 06 nov. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 12 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew James Stockwell en tant que directeur le 27 sept. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mrs Claire Thompson en tant qu'administrateur le 27 sept. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Allied Mutual Insurance Services Limited en tant que secrétaire le 27 sept. 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Nomination de Mr James Douglas Gunningham en tant qu'administrateur le 27 sept. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Allied Mutual Insurance Services Limited le 12 juin 2019 | 1 pages | CH04 | ||||||||||||||
Modification des détails de Gpg (Uk) Holdings Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 juin 2019 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Coats Group Plc 1 the Square Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1TD à 4 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1FE le 14 juin 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 03 oct. 2018
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 30 juil. 2018
| 4 pages | SH01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 2 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Mr Nicholas James Kidd en tant qu'administrateur le 28 févr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Charles Frederick Barlow en tant que directeur le 28 févr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Notification de Gpg (Uk) Holdings Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de GUINNESS PEAT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNNINGHAM, James Douglas | Administrateur | Longwalk Road Stockley Park UB11 1FE Uxbridge 4 England | England | British | Director | 204284950001 | ||||||||
KERMALLI, Arif | Administrateur | Longwalk Road Stockley Park UB11 1FE Uxbridge 4 England | England | British | Director | 203519190001 | ||||||||
KIDD, Nicholas James | Administrateur | Longwalk Road Stockley Park UB11 1FE Uxbridge 4 England | England | British | Company Director | 189356380001 | ||||||||
HEALY, Christopher William | Secrétaire | c/o Prism Cosec Limited Margaret Street W1W 8RL London 10 England | 186618640001 | |||||||||||
RUSSELL, James Richard | Secrétaire | Pall Mall SW1Y 5ES London 78 England | British | Chartered Secretary | 904390002 | |||||||||
SYMONDS, Graham Leslie | Secrétaire | 4 Wrensfield Boxmoor HP1 1RN Hemel Hempstead Hertfordshire | British | Cs | 5516290001 | |||||||||
ALLIED MUTUAL INSURANCE SERVICES LIMITED | Secrétaire | Longwalk Road Stockley Park UB11 1FE Uxbridge 4 England |
| 126889420001 | ||||||||||
BARLOW, Charles Frederick | Administrateur | c/o Coats Group Plc The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 Middlesex | United Kingdom | British | Director | 151336790001 | ||||||||
BURRELL, Richard Mitchell | Administrateur | Pall Mall SW1Y 5ES London 78 England | England | British | Chartered Accounta | 71175730001 | ||||||||
ENGLAND, Alison | Administrateur | First Floor Times Place 45 Pall Mall SW1Y 5GP London | England | British | Director | 162283960001 | ||||||||
GLEAVE, Clinton John Raymond | Administrateur | 14 Kenneth Crescent Willesden Green NW2 4PT London | England | British | Accountant | 48349150003 | ||||||||
HOWES, Richard David | Administrateur | c/o Coats Group Plc The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 Middlesex England | England | British | Company Director | 265695690001 | ||||||||
NIXON, Blake Andrew | Administrateur | Southwood Furze Field Oxshott KT22 0UR Leatherhead Surrey | New Zealander | Executive Director | 5872150001 | |||||||||
RUSSELL, James Richard | Administrateur | Pall Mall SW1Y 5ES London 78 England | England | British | Chartered Secretary | 904390002 | ||||||||
STOCKWELL, Andrew James | Administrateur | Longwalk Road Stockley Park UB11 1FE Uxbridge 4 England | England | British | Director | 79587890002 | ||||||||
SYMONDS, Graham Leslie | Administrateur | 4 Wrensfield Boxmoor HP1 1RN Hemel Hempstead Hertfordshire | British | Company Secretary | 5516290001 | |||||||||
TARN, Nicholas James | Administrateur | c/o Prism Cosec Limited Margaret Street W1W 8RL London 10 England | England | British | Accountant | 113629970001 | ||||||||
TAYLOR, Kevin Rohan | Administrateur | c/o Coats Group Plc The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 Middlesex | England | British | Company Director | 197540030001 | ||||||||
THOMPSON, Claire | Administrateur | Longwalk Road Stockley Park UB11 1FE Uxbridge 4 England | United Kingdom | British | Director | 236781440001 | ||||||||
ALLIED MUTUAL INSURANCE SERVICES LIMITED | Administrateur | c/o Coats Group Plc The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 Middlesex England |
| 126889420001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GUINNESS PEAT OVERSEAS HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gpg (Uk) Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Longwalk Road Stockley Park UB11 1FE Uxbridge 4 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0