MCA PARTNERSHIP HOUSING LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MCA PARTNERSHIP HOUSING LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02944313 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MCA PARTNERSHIP HOUSING LIMITED ?
| Adresse du siège social | Gate House Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Buckinghamshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MCA PARTNERSHIP HOUSING LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MCA PARTNERSHIP HOUSING LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 02 nov. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 16 nov. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 02 nov. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MCA PARTNERSHIP HOUSING LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Jennifer Canty en tant que directeur le 30 sept. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Jennifer Canty en tant que secrétaire le 30 sept. 2025 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Sara Hollowell en tant qu'administrateur le 01 oct. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Sara Hollowell en tant que secrétaire le 01 oct. 2025 | 2 pages | AP03 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2024 | 5 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Michael Andrew Lonnon en tant que directeur le 09 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant qu'administrateur le 09 déc. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023 | 5 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant que directeur le 24 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant que secrétaire le 24 avr. 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Jennifer Canty en tant qu'administrateur le 24 avr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Jennifer Canty en tant que secrétaire le 24 avr. 2024 | 2 pages | AP03 | ||
Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant qu'administrateur le 09 oct. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant que directeur le 09 oct. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 5 pages | AA | ||
Nomination de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant que secrétaire le 15 juin 2023 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant que secrétaire le 15 juin 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 5 pages | AA | ||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH | 1 pages | AD03 | ||
Qui sont les dirigeants de MCA PARTNERSHIP HOUSING LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLOWELL, Sara | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | 340977400001 | |||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 330353690001 | |||||
| HOLLOWELL, Sara | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | United Kingdom | British | 200486170001 | |||||
| ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | 310356140001 | |||||||
| CANTY, Jennifer | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | 322325930001 | |||||||
| CARR, Peter Anthony | Secrétaire | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | Other | 135438270002 | ||||||
| HASTIE, Nicola Amanda Eleanor | Secrétaire | 97 Yew Tree Lane Tettenhall WV6 8UN Wolverhampton | British | 76844970003 | ||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 219951590001 | |||||||
| JORDAN, James John | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||
| MILLS, Stanley | Secrétaire | Whitegates Wixford B49 6DA North Alcester Warwickshire | British | 573140004 | ||||||
| PHILLIPS, James | Secrétaire | Stallworth 6 Wood Road Tettenhall WV6 8LS Wolverhampton West Midlands | British | 8364990001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Administrateur | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | England | British | 193735640001 | |||||
| AMATO, Silvano | Administrateur | 43 Tadorne Road KT20 5TF Tadworth Surrey | United Kingdom | British | 156018520002 | |||||
| ANDREW, Peter Robert | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 113503830003 | |||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 175715660001 | |||||
| BURTON, Anthony William Rawes | Administrateur | Foxs Hangout Mislingford Road SO32 2QD Swanmore Hampshire | England | British | 75468170001 | |||||
| CANTY, Jennifer | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | United Kingdom | British | 322288120001 | |||||
| CARNEY, Christopher | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 125216670001 | |||||
| CARR, Peter Anthony | Administrateur | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | England | British | 130306120001 | |||||
| CARR-LOCKE, Andrew Charles Phillip | Administrateur | High Ridge Pains Hill RH8 0RB Limpsfield Oxted Surrey | United Kingdom | British | 2567850002 | |||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 9684390001 | |||||
| COX, Ian Douglas | Administrateur | The Slade Charlbury OX7 3SJ Chipping Norton Ticknell Corner Oxon | United Kingdom | British | 140224510001 | |||||
| CUDD, John Charles | Administrateur | 4 Walnut Tree Walk BN20 9BP Eastbourne East Sussex | England | British | 113934990001 | |||||
| CUSHEN, Keith Morgan | Administrateur | Buddleia Cottage High Street TW12 2SX Hampton Middlesex | British | 37763770002 | ||||||
| DOCKERY, Joseph Edward | Administrateur | Steephurst Harestone Hill CR3 6BG Caterham Surrey | British | 6201520001 | ||||||
| GAYTON, Paul | Administrateur | 47 Chase Ridings EN2 7QE Enfield Middlesex | British | 48301230001 | ||||||
| GOULSTON, Stephen | Administrateur | 39 Sutton Road BH9 1RW Bournemouth Dorset | British | 81458630001 | ||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 257671040002 | |||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 34521340004 | |||||
| MALONE, Gerald Philip | Administrateur | Wheelgates Loudhams Wood Lane HP8 4AR Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 42187440001 | ||||||
| MILLS, Stanley | Administrateur | Whitegates Wixford B49 6DA North Alcester Warwickshire | British | 573140004 | ||||||
| PERRY, Roy | Administrateur | 3 Thornbury Heights Chandlers Ford SO53 5DQ Eastleigh Hampshire | British | 47603170001 | ||||||
| PETERS, Stephen William | Administrateur | 13 Broomfield Road KT5 9AZ Surbiton Surrey | United Kingdom | British | 65745290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MCA PARTNERSHIP HOUSING LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Wimpey Limited | 06 avr. 2016 | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0