VARDY MARKETING LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | VARDY MARKETING LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02946713 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe VARDY MARKETING LIMITED ?
Adresse du siège social | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de VARDY MARKETING LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour VARDY MARKETING LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 28 mai 2021
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 sept. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 oct. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 12 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Philip Herbert en tant que directeur le 30 juin 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Mark Simon Willis en tant qu'administrateur le 08 avr. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Mark Philip Herbert en tant qu'administrateur le 01 avr. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Paul Holden en tant que directeur le 31 mars 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Trevor Garry Finn en tant que directeur le 31 mars 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 oct. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 oct. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Hilary Claire Sykes en tant que secrétaire le 01 janv. 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Hilary Claire Sykes en tant que directeur le 01 janv. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Trevor Garry Finn le 18 oct. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 oct. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de VARDY MARKETING LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALONEY, Richard James | Secrétaire | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | British | Solicitor | 110894220002 | |||||
CASHA, Martin Shaun | Administrateur | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | Director | 41114490010 | ||||
WILLIS, Mark Simon | Administrateur | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | England | British | Director | 229010610001 | ||||
BRINE, Jason Andrew | Secrétaire | The Old Granary South Farm Court Sandhutton YO7 4RY Thirsk North Yorkshire | British | 67811740002 | ||||||
GOODMAN, Graham Lionel | Secrétaire | Park Corner House Basingstoke Road Heckfield RG27 0LJ Basingstoke Hampshire | British | 63691460001 | ||||||
LAUGHLIN, Fiona Elizabeth | Secrétaire | 23 The Crescent NE26 2JG Whitley Bay Tyne & Wear | British | Company Secretary | 1417030001 | |||||
MESSIDER, Neil | Secrétaire | 64 Hedgerley OX9 4TJ Chinnor Oxfordshire | British | 39528400001 | ||||||
RAWNSLEY, Patrick James | Secrétaire | Stonecroft, 2 Lakeside Close Ilkley LS29 0AG Leeds West Yorkshire | British | Company Secretary | 108571170001 | |||||
SYKES, Hilary Claire | Secrétaire | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | British | Director | 41559790001 | |||||
WILLIAMS, Julie Suzanne | Secrétaire | 14 Nightingale Close Spinnakers Reach TS26 0HL Hartlepool Cleveland | British | 105112860001 | ||||||
FINN, Trevor Garry | Administrateur | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | Director | 2652610013 | ||||
FORRESTER, Robert Thomas | Administrateur | 38 Moor Crescent Gosforth NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | Financial Director | 76716700002 | ||||
FORSYTH, David Robertson | Administrateur | Scotland Cottage Melbourne DE73 1BH Derby | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 55127120002 | ||||
GOODMAN, Graham Lionel | Administrateur | 22 Moor End Holyport SL6 2YW Maidenhead Berkshire | British | Director | 63691460006 | |||||
GOODMAN, Margaret Elizabeth | Administrateur | Chateau De La Mothe 24400 Les Leches | British | Director | 92447910001 | |||||
HERBERT, Mark Philip | Administrateur | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | England | British | Director | 123285980005 | ||||
HOLDEN, Timothy Paul | Administrateur | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | England | British | Chartered Accountant | 148034310003 | ||||
MCALOON, William Gerard | Administrateur | 10 Jacks View West Kilbride KA23 9HX Ayshire Ayrshire | British | Finance Director | 108756350001 | |||||
MURRAY, Gerard Thomas | Administrateur | 9 Southlands NE30 2QS Tynemouth Tyne & Wear | British | Company Director | 87695440001 | |||||
POTTS, Graeme John | Administrateur | Ashleigh Ashbrooke Range SR2 7TP Sunderland Tyne & Wear | British | Company Director | 916400001 | |||||
SYKES, Hilary Claire | Administrateur | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | England | British | Director | 41559790001 | ||||
VARDY, Peter, Sir | Administrateur | Rainton House Middle Rainton DH4 6PJ Houghton Le Spring Tyne & Wear | England | British | Company Director | 12048420003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur VARDY MARKETING LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reg Vardy Limited | 06 avr. 2016 | Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Loxley House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
VARDY MARKETING LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A security agreement | Créé le 13 mai 2009 Livré le 21 mai 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 28 févr. 1995 Livré le 01 mars 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions All those monies which may from time to time be owing to the company from the chargee in respect of refunds of monies paid by or by the direction of the company to the chargee by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of charge | Créé le 25 janv. 1995 Livré le 01 févr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The benefit of all rights of the company under or by virtue of a building contract dated 14 december 1994. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 25 janv. 1995 Livré le 01 févr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H property forming part of the kingston centre milton keynes. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0