FREEWAY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFREEWAY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02956037
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FREEWAY LIMITED ?

    • Octroi de crédit par les établissements financiers non-dépositaires et autres octroyeurs spécialisés de crédit à la consommation (64921) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe FREEWAY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de FREEWAY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour FREEWAY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pagesLIQ13

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Charterhall House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN à 1 More London Place London SE1 2AF le 13 déc. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 16 nov. 2017

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Cessation de la nomination de Kevin Francis Dunne en tant que directeur le 27 juin 2017

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr David Dermot Hennessey en tant que secrétaire le 11 janv. 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Paul Gittins en tant que secrétaire le 11 janv. 2017

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 févr. 2016

    État du capital au 01 févr. 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin Francis Dunne le 21 déc. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    17 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Mawer le 09 juil. 2015

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 févr. 2015

    État du capital au 04 févr. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Mawer le 14 janv. 2015

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Andrew Mawer en tant qu'administrateur le 19 déc. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Carol Ann Parkes en tant que directeur le 19 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Kevin Francis Dunne en tant qu'administrateur le 19 déc. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Francis Chessman en tant que directeur le 12 sept. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    17 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de FREEWAY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HENNESSEY, David Dermot
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower House
    United Kingdom
    222324950001
    MAWER, Andrew
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritish193660370003
    GITTINS, Paul
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Secrétaire
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    British45660860003
    GITTINS, Paul
    5 Hambledon Close
    Little Sutton
    L66 4YF South Wirral
    Secrétaire
    5 Hambledon Close
    Little Sutton
    L66 4YF South Wirral
    British45660860002
    LAKIN, Helen Mary
    Gorphwysfa 6 Nant Road
    Bwlchgwyn
    LL11 5YN Wrexham
    Clwyd
    Secrétaire
    Gorphwysfa 6 Nant Road
    Bwlchgwyn
    LL11 5YN Wrexham
    Clwyd
    British41250190001
    MAYER, Sally
    48 Prospect Street
    Shibden Heights
    HX3 6LG Halifax
    Secrétaire
    48 Prospect Street
    Shibden Heights
    HX3 6LG Halifax
    British75435950002
    NIXON, Raymond
    Holly House The Steadings
    Wicker Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EL Chester
    Cheshire
    Secrétaire
    Holly House The Steadings
    Wicker Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EL Chester
    Cheshire
    British36433110016
    BALLINGALL, Stuart James
    39 Craigleith Drive
    EH4 3JU Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    39 Craigleith Drive
    EH4 3JU Edinburgh
    Midlothian
    British118506820001
    CHESSMAN, Mark Francis
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    EnglandBritish196385070001
    DINGLEY, Leslie George
    5 Riverbank Court
    East Whitburn
    EH47 0FD Bathgate
    West Lothian
    Scotland
    Administrateur
    5 Riverbank Court
    East Whitburn
    EH47 0FD Bathgate
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish85397020003
    DUGGAN, Gary John
    6 Latham Way
    L63 9NX Spital
    Wirral
    Administrateur
    6 Latham Way
    L63 9NX Spital
    Wirral
    British74792420001
    DUNNE, Kevin Francis
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower House
    United Kingdom
    Administrateur
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower House
    United Kingdom
    United KingdomIrish193660360001
    FRANCIS, Rick
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    EnglandBritish180380320001
    GITTINS, Paul
    7 Vaughans Lane
    Great Boughton
    CH3 5XF Chester
    Cheshire
    Administrateur
    7 Vaughans Lane
    Great Boughton
    CH3 5XF Chester
    Cheshire
    EnglandBritish45660860003
    GRANT, George Alexander
    131 Morningside Drive
    EH10 5NR Edinburgh
    Administrateur
    131 Morningside Drive
    EH10 5NR Edinburgh
    British71010760002
    HARE, Robert Brown
    13 Balgreen Avenue
    EH12 5SX Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    13 Balgreen Avenue
    EH12 5SX Edinburgh
    Lothian
    British64474720003
    LAKIN, Helen Mary
    Gorphwysfa 6 Nant Road
    Bwlchgwyn
    LL11 5YN Wrexham
    Clwyd
    Administrateur
    Gorphwysfa 6 Nant Road
    Bwlchgwyn
    LL11 5YN Wrexham
    Clwyd
    BritainBritish41250190001
    LATTO, David Harry
    35 Palace Road
    HG4 1EZ Ripon
    North Yorkshire
    Administrateur
    35 Palace Road
    HG4 1EZ Ripon
    North Yorkshire
    British113070380001
    LEAMAN, Andrew Stephen
    4 Willow Court
    Well Lane, Mollington
    CH1 6LD Chester
    Administrateur
    4 Willow Court
    Well Lane, Mollington
    CH1 6LD Chester
    British48906540002
    MITTEN, Patrick Anthony
    Ridings
    New York Lane, Rawdon
    LS19 6JJ Leeds
    Administrateur
    Ridings
    New York Lane, Rawdon
    LS19 6JJ Leeds
    British81643270001
    MORRISON, Edward James
    50 Foresters Lea Crescent
    KY12 7TF Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    50 Foresters Lea Crescent
    KY12 7TF Dunfermline
    Fife
    British79242190001
    MORRISSEY, John Michael
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    Administrateur
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    EnglandBritish94094650001
    PARKES, Carol Ann
    Heathside Park Road
    SK3 0RB Stockport
    Heathside
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Heathside Park Road
    SK3 0RB Stockport
    Heathside
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish139996590027
    STEAD, Nigel Cleator
    Blake House
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Lex Autolease
    England
    England
    Administrateur
    Blake House
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Lex Autolease
    England
    England
    EnglandBritish47582470001
    TOWN, Lindsay John
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish64287260001
    WALDEN, Jonathan Kim
    Hyatt Lodge
    Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    England
    Administrateur
    Hyatt Lodge
    Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish3809630002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FREEWAY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    EH1 1YZ Edinburgh
    The Mound
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    EH1 1YZ Edinburgh
    The Mound
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc327000
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    FREEWAY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Letter of charge
    Créé le 19 juin 1996
    Livré le 10 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account or accounts in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 20 févr. 1995
    Livré le 22 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from capital incentives PLC and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 13 déc. 1994
    Livré le 23 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from capital incentives PLC and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    FREEWAY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 nov. 2017Commencement of winding up
    31 janv. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0