ASHBOURNE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéASHBOURNE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02958151
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ASHBOURNE LIMITED ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe ASHBOURNE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ASHBOURNE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ASHBOURNE GROUP UK LIMITED08 mars 200108 mars 2001
    SUN HEALTHCARE GROUP UK LIMITED 22 janv. 199922 janv. 1999
    SUN HEALTHCARE GROUP INTERNATIONAL LTD.30 août 199430 août 1994
    BASICTOP LIMITED12 août 199412 août 1994

    Quels sont les derniers comptes de ASHBOURNE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour ASHBOURNE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire le 09 oct. 2012

    1 pagesTM02

    Avis d'achèvement de l'accord volontaire

    6 pages1.4

    Cessation de la nomination de Timothy James Bolot en tant que directeur le 17 août 2012

    1 pagesTM01

    Avis au registre des sociétés de l'accord volontaire prenant effet

    4 pages1.1

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 janv. 2012

    État du capital au 18 janv. 2012

    • Capital: GBP 136,232,000
    SH01

    Cessation de la nomination de William James Buchan en tant que directeur le 15 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Andrew Smith en tant que directeur le 01 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen Jonathan Taylor en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Timothy James Bolot en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    21 pagesAA

    Cessation de la nomination de William Mcleish en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    11 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Richard Midmer en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Explanatory statement to sole member 14/05/2010
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    12 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 27 sept. 2009

    18 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Andrew Smith le 07 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr David Andrew Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Smith en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Andrew Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kamma Foulkes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de ASHBOURNE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    BROUSSARD, Bruce Dale
    4920 Calle De Tierra Ne
    FOREIGN Albuquerque
    New Mexico
    Secrétaire
    4920 Calle De Tierra Ne
    FOREIGN Albuquerque
    New Mexico
    American40571230001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Secrétaire
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    British53915080001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    Secrétaire
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Secrétaire
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MACFARLANE, Rona Jane
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    Secrétaire
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    British62509960001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secrétaire
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158304820001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secrétaire
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Secrétaire
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Secrétaire
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SPEIRS, Lesley Sarah
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    British69112020001
    WIMER, Mark G
    7939 West Bayhill Court
    83704 Boise
    Idaho
    Usa
    Secrétaire
    7939 West Bayhill Court
    83704 Boise
    Idaho
    Usa
    American52192900001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ABLETT, Julie
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    Administrateur
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    British57906600001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BROUSSARD, Bruce Dale
    4920 Calle De Tierra Ne
    FOREIGN Albuquerque
    New Mexico
    Administrateur
    4920 Calle De Tierra Ne
    FOREIGN Albuquerque
    New Mexico
    American40571230001
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Administrateur
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    DAVIS, Mary
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    Administrateur
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    British76212360001
    FARRALL, Elaine Ann
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    British14241020001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Administrateur
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish53915080001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Administrateur
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Administrateur
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    HAMILTON, Thomas Banks
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    Administrateur
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    British79846610001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Administrateur
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    LAWRENCE, Stephen John
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    Administrateur
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    EnglandBritish5579020001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Administrateur
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MARK, Larry Edward
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    Administrateur
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    New Zealander5076900001
    MCINTEER, Warren Hill
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish100131200001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MORETON, John Ernest
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    Administrateur
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    New Zealander80392940001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Administrateur
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    PHIPPEN, Kent William
    12 Elm Tree Road
    St Johns Wood
    NW8 9JX London
    Administrateur
    12 Elm Tree Road
    St Johns Wood
    NW8 9JX London
    United KingdomAmerican84576560001

    ASHBOURNE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Share charge
    Créé le 29 févr. 2008
    Livré le 14 mars 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its whole right, title, interest and benefit in and to the existing shares and related rights, existing shares means ordinary shares of £0.10, number of existing shares 53,648,599. related rights means all dividends see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 14 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 29 févr. 2008
    Livré le 14 mars 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 14 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Share charge
    Créé le 06 juin 2007
    Livré le 19 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each charging company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The whole right, title, interest and benefit in and to the existing shares and related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 19 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 juin 2007
    Livré le 19 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 19 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Share charge
    Créé le 07 juil. 2006
    Livré le 20 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its whole right title and interest and benefit in and to the existing shares and related rights any additional shares and related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 20 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 juil. 2006
    Livré le 20 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 20 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Share pledge
    Créé le 02 déc. 2005
    Livré le 15 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its right, title, interest and benefit in and to the existing shares and related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 15 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession and charge
    Créé le 02 déc. 2005
    Livré le 15 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 15 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 01 avr. 2005
    Livré le 19 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever or all monies due or to become due from cannon capital ventures limited on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Secured Creditors (The Security Agent)
    Transactions
    • 19 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Share pledge
    Créé le 24 mars 2005
    Livré le 08 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares (53,648,599 ordinary shares of £0.10 each in the company, any future shares) and all related assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Agent)
    Transactions
    • 08 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 10 févr. 2005
    Livré le 24 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and cannon capital ventures limited to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all estates or interests in any f/h or l/h property now owned by it, and all buildings and fixtures and fixed plant and fixed machinery, all of its book and other debts, any know-how, patent, trade mark, service mark, design, business name, any copyright or other intellectual property monopoly right. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Secured Creditors(The Security Agent)
    Transactions
    • 24 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ASHBOURNE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 juin 2012Date of meeting to approve CVA
    20 août 2012Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    practitioner
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0