LANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

LANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02970415
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe LANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    7 Abbey Court
    Eagle Way Sowton Industrial
    EX2 7HY Estate, Exeter
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ENVIROCHECK LIMITED16 févr. 199516 févr. 1995
    LUDGATE EIGHTY NINE LIMITED22 sept. 199422 sept. 1994

    Quels sont les derniers comptes de LANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour LANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    AB63IPS9

    Déclaration de confirmation établie le 20 janv. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XAW51K7L

    État du capital au 11 janv. 2022

    • Capital: GBP 2
    3 pagesSH19
    AAV8VH9D

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduction of share premuim account 17/09/2021
    RES13

    legacy

    1 pagesSH20
    AAV8VH5K

    legacy

    1 pagesCAP-SS
    AAV8VH7K

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2020

    25 pagesAA
    AA0KTGMJ

    Déclaration de confirmation établie le 19 janv. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X9WIS3KR

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2019

    29 pagesAA
    A9ED0V2J

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01
    X8YSVGWY

    Cessation de la nomination de Matthew Stephen Teague en tant que directeur le 18 oct. 2019

    1 pagesTM01
    X8GPI7A0

    Nomination de Mr Mark Daniel Johnston en tant qu'administrateur le 18 oct. 2019

    2 pagesAP01
    X8GPI8X0

    Cessation de la nomination de David William Callcott en tant que directeur le 30 juin 2019

    1 pagesTM01
    X8GPI7UB

    Cessation de la nomination de David William Callcott en tant que secrétaire le 18 avr. 2019

    1 pagesTM02
    X83MN42P

    Nomination de Mr Matthew Stephen Teague en tant que secrétaire le 18 avr. 2019

    2 pagesAP03
    X83MN3TU

    Nomination de Mr Matthew Stephen Teague en tant qu'administrateur le 01 avr. 2019

    2 pagesAP01
    X82ISWX7

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X7Z4D9GQ

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2018

    22 pagesAA
    A7Y7ZYMQ

    Nomination de Mr Stephen John Stout en tant qu'administrateur le 05 nov. 2018

    2 pagesAP01
    X7J6N2TV

    Nomination de Mr Simon James Brown en tant qu'administrateur le 05 nov. 2018

    2 pagesAP01
    X7J6MJ2R

    Cessation de la nomination de Mark Francis Milner en tant que directeur le 05 nov. 2018

    1 pagesTM01
    X7J6K82Y

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X6ZP7TBS

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2017

    21 pagesAA
    A6YZWDWQ

    Qui sont les dirigeants de LANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TEAGUE, Matthew Stephen
    7 Abbey Court
    Eagle Way Sowton Industrial
    EX2 7HY Estate, Exeter
    Secrétaire
    7 Abbey Court
    Eagle Way Sowton Industrial
    EX2 7HY Estate, Exeter
    257681180001
    BROWN, Simon James
    7 Abbey Court
    Eagle Way Sowton Industrial
    EX2 7HY Estate, Exeter
    Administrateur
    7 Abbey Court
    Eagle Way Sowton Industrial
    EX2 7HY Estate, Exeter
    EnglandBritishChief Executive138828660001
    JOHNSTON, Mark Daniel
    7 Abbey Court
    Eagle Way Sowton Industrial
    EX2 7HY Estate, Exeter
    Administrateur
    7 Abbey Court
    Eagle Way Sowton Industrial
    EX2 7HY Estate, Exeter
    United KingdomBritishDirector158185090001
    STOUT, Stephen John
    7 Abbey Court
    Eagle Way Sowton Industrial
    EX2 7HY Estate, Exeter
    Administrateur
    7 Abbey Court
    Eagle Way Sowton Industrial
    EX2 7HY Estate, Exeter
    United KingdomBritishChairman154424780001
    CALLCOTT, David William
    2 Northcote Road
    Clifton
    BS8 3HB Bristol
    Secrétaire
    2 Northcote Road
    Clifton
    BS8 3HB Bristol
    BritishFinance Director85543390001
    GORDON, Anthony Richard Francis
    189 North Gower Street
    NW1 2ND London
    Secrétaire désigné
    189 North Gower Street
    NW1 2ND London
    British900009470001
    NAPIER, Elisabeth
    Park View Southover
    Frampton
    DT2 9NH Dorchester
    Dorset
    Secrétaire
    Park View Southover
    Frampton
    DT2 9NH Dorchester
    Dorset
    British55762970001
    RE'EM, Daniel
    77c Roupell Street
    SE1 8SS London
    Secrétaire
    77c Roupell Street
    SE1 8SS London
    British5388110001
    TERRY, Graham Richard
    Salway House
    Clappentail Lane
    DT7 3LZ Lyme Regis
    Dorset
    Secrétaire
    Salway House
    Clappentail Lane
    DT7 3LZ Lyme Regis
    Dorset
    BritishAccountant50592780002
    WALTER, David Andrew
    11 Carshalton Lodge
    Oatlands Drive
    KT13 9LJ Weybridge
    Surrey
    Secrétaire
    11 Carshalton Lodge
    Oatlands Drive
    KT13 9LJ Weybridge
    Surrey
    BritishSolicitor59677320003
    AUDLEY, Maxwell Charles
    7 Pilgrim Street
    EC4V 6DR London
    Administrateur désigné
    7 Pilgrim Street
    EC4V 6DR London
    British900009450001
    CALLCOTT, David William
    2 Northcote Road
    Clifton
    BS8 3HB Bristol
    Administrateur
    2 Northcote Road
    Clifton
    BS8 3HB Bristol
    EnglandBritishFinance Director85543390001
    GORDON, Anthony Richard Francis
    189 North Gower Street
    NW1 2ND London
    Administrateur désigné
    189 North Gower Street
    NW1 2ND London
    British900009470001
    MILNER, Mark Francis
    7 Abbey Court
    Eagle Way Sowton Industrial
    EX2 7HY Estate, Exeter
    Administrateur
    7 Abbey Court
    Eagle Way Sowton Industrial
    EX2 7HY Estate, Exeter
    EnglandBritishDirector174048810001
    RE'EM, Daniel
    77c Roupell Street
    SE1 8SS London
    Administrateur
    77c Roupell Street
    SE1 8SS London
    BritishDirector5388110001
    ROPER, Christopher
    North End Farm
    Venn Lane Chideock
    DT6 6JY Bridport
    Dorset
    Administrateur
    North End Farm
    Venn Lane Chideock
    DT6 6JY Bridport
    Dorset
    United KingdomBritishDirector38855910005
    STOUT, Stephen John
    Priors
    Priorsfield Road
    GU7 2RG Hurtmore
    Surrey
    Administrateur
    Priors
    Priorsfield Road
    GU7 2RG Hurtmore
    Surrey
    United KingdomBritishDirector154424780001
    SYKES, Paul
    16 Hidden Meadow Lane
    New Canaan
    Ct 06840
    Usa
    Administrateur
    16 Hidden Meadow Lane
    New Canaan
    Ct 06840
    Usa
    United StatesBritishFinance Director53535790003
    TEAGUE, Matthew Stephen
    7 Abbey Court
    Eagle Way Sowton Industrial
    EX2 7HY Estate, Exeter
    Administrateur
    7 Abbey Court
    Eagle Way Sowton Industrial
    EX2 7HY Estate, Exeter
    EnglandBritishFinance Director256403180001
    WALTER, David Andrew
    11 Carshalton Lodge
    Oatlands Drive
    KT13 9LJ Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    11 Carshalton Lodge
    Oatlands Drive
    KT13 9LJ Weybridge
    Surrey
    BritishSolicitor59677320003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Eagle Way
    Sowton Industrial Estate
    EX2 7HY Exeter
    5-7 Abbey Court
    England
    06 avr. 2016
    Eagle Way
    Sowton Industrial Estate
    EX2 7HY Exeter
    5-7 Abbey Court
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02892803
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    LANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 18 mai 1998
    Livré le 21 mai 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee for itself and as trustee on behalf of the investors (as defined) under the investment agreement of even date (the "security trustee") pursuant to the deed of guarantee of even date (other than dividend on shares)
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 21 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 18 mai 1998
    Livré le 21 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee for itself and as trustee on behalf of the lenders (as defined) under therestructuring agreement of even date (the "security trustee") pursuant to the deed of guarantee of even date (other than dividend on shares)
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 21 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 juil. 1997
    Livré le 04 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of guarantee of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Plcfor Itself and as Trustee for the Investors
    Transactions
    • 04 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 oct. 1996
    Livré le 01 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or the investors (as therein defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC(As Security Trustee for Itself and the Investors)
    Transactions
    • 01 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 18 avr. 1996
    Livré le 20 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from landmark information group limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Eagle Star Insurance Company Limited
    Transactions
    • 20 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 08 mars 1995
    Livré le 14 mars 1995
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from landmark information group limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC on Behalf of the Investors (As Defined in the Debenture)
    Transactions
    • 14 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0