LANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | LANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02970415 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?
Adresse du siège social | 7 Abbey Court Eagle Way Sowton Industrial EX2 7HY Estate, Exeter |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour LANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 janv. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
État du capital au 11 janv. 2022
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2020 | 25 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 janv. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2019 | 29 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Stephen Teague en tant que directeur le 18 oct. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Mark Daniel Johnston en tant qu'administrateur le 18 oct. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David William Callcott en tant que directeur le 30 juin 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David William Callcott en tant que secrétaire le 18 avr. 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Matthew Stephen Teague en tant que secrétaire le 18 avr. 2019 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr Matthew Stephen Teague en tant qu'administrateur le 01 avr. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2018 | 22 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Stephen John Stout en tant qu'administrateur le 05 nov. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon James Brown en tant qu'administrateur le 05 nov. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Francis Milner en tant que directeur le 05 nov. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2017 | 21 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de LANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAGUE, Matthew Stephen | Secrétaire | 7 Abbey Court Eagle Way Sowton Industrial EX2 7HY Estate, Exeter | 257681180001 | |||||||
BROWN, Simon James | Administrateur | 7 Abbey Court Eagle Way Sowton Industrial EX2 7HY Estate, Exeter | England | British | Chief Executive | 138828660001 | ||||
JOHNSTON, Mark Daniel | Administrateur | 7 Abbey Court Eagle Way Sowton Industrial EX2 7HY Estate, Exeter | United Kingdom | British | Director | 158185090001 | ||||
STOUT, Stephen John | Administrateur | 7 Abbey Court Eagle Way Sowton Industrial EX2 7HY Estate, Exeter | United Kingdom | British | Chairman | 154424780001 | ||||
CALLCOTT, David William | Secrétaire | 2 Northcote Road Clifton BS8 3HB Bristol | British | Finance Director | 85543390001 | |||||
GORDON, Anthony Richard Francis | Secrétaire désigné | 189 North Gower Street NW1 2ND London | British | 900009470001 | ||||||
NAPIER, Elisabeth | Secrétaire | Park View Southover Frampton DT2 9NH Dorchester Dorset | British | 55762970001 | ||||||
RE'EM, Daniel | Secrétaire | 77c Roupell Street SE1 8SS London | British | 5388110001 | ||||||
TERRY, Graham Richard | Secrétaire | Salway House Clappentail Lane DT7 3LZ Lyme Regis Dorset | British | Accountant | 50592780002 | |||||
WALTER, David Andrew | Secrétaire | 11 Carshalton Lodge Oatlands Drive KT13 9LJ Weybridge Surrey | British | Solicitor | 59677320003 | |||||
AUDLEY, Maxwell Charles | Administrateur désigné | 7 Pilgrim Street EC4V 6DR London | British | 900009450001 | ||||||
CALLCOTT, David William | Administrateur | 2 Northcote Road Clifton BS8 3HB Bristol | England | British | Finance Director | 85543390001 | ||||
GORDON, Anthony Richard Francis | Administrateur désigné | 189 North Gower Street NW1 2ND London | British | 900009470001 | ||||||
MILNER, Mark Francis | Administrateur | 7 Abbey Court Eagle Way Sowton Industrial EX2 7HY Estate, Exeter | England | British | Director | 174048810001 | ||||
RE'EM, Daniel | Administrateur | 77c Roupell Street SE1 8SS London | British | Director | 5388110001 | |||||
ROPER, Christopher | Administrateur | North End Farm Venn Lane Chideock DT6 6JY Bridport Dorset | United Kingdom | British | Director | 38855910005 | ||||
STOUT, Stephen John | Administrateur | Priors Priorsfield Road GU7 2RG Hurtmore Surrey | United Kingdom | British | Director | 154424780001 | ||||
SYKES, Paul | Administrateur | 16 Hidden Meadow Lane New Canaan Ct 06840 Usa | United States | British | Finance Director | 53535790003 | ||||
TEAGUE, Matthew Stephen | Administrateur | 7 Abbey Court Eagle Way Sowton Industrial EX2 7HY Estate, Exeter | England | British | Finance Director | 256403180001 | ||||
WALTER, David Andrew | Administrateur | 11 Carshalton Lodge Oatlands Drive KT13 9LJ Weybridge Surrey | British | Solicitor | 59677320003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landmark Information Group | 06 avr. 2016 | Eagle Way Sowton Industrial Estate EX2 7HY Exeter 5-7 Abbey Court England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
LANDMARK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 18 mai 1998 Livré le 21 mai 1998 | En cours | Montant garanti All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee for itself and as trustee on behalf of the investors (as defined) under the investment agreement of even date (the "security trustee") pursuant to the deed of guarantee of even date (other than dividend on shares) | |
Brèves mentions (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 18 mai 1998 Livré le 21 mai 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee for itself and as trustee on behalf of the lenders (as defined) under therestructuring agreement of even date (the "security trustee") pursuant to the deed of guarantee of even date (other than dividend on shares) | |
Brèves mentions (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 31 juil. 1997 Livré le 04 août 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of guarantee of even date | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 15 oct. 1996 Livré le 01 nov. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee or the investors (as therein defined) on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Collateral debenture | Créé le 18 avr. 1996 Livré le 20 avr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from landmark information group limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Collateral debenture | Créé le 08 mars 1995 Livré le 14 mars 1995 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from landmark information group limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0