HARWORTH TRUSTEES LTD
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HARWORTH TRUSTEES LTD |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02974489 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HARWORTH TRUSTEES LTD ?
| Adresse du siège social | Advantage House Poplar Way Catcliffe S60 5TR Rotherham United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HARWORTH TRUSTEES LTD ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour HARWORTH TRUSTEES LTD ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Harworth Secretariat Services Limited en tant que secrétaire le 08 sept. 2021 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Christopher Michael Birch en tant qu'administrateur le 08 sept. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Richard Ball en tant que directeur le 08 sept. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 août 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Owen Michaelson en tant que directeur le 31 déc. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Ms Lynda Margaret Shillaw en tant qu'administrateur le 01 nov. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 août 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Katerina Jane Patmore le 13 mai 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 août 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Katerina Jane Patmore en tant qu'administrateur le 01 oct. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Michael David Kirkman en tant que directeur le 30 juin 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Ian Richard Ball en tant qu'administrateur le 30 juin 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Michael Birch en tant que directeur le 30 nov. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Richard Owen Michaelson en tant qu'administrateur le 13 nov. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 août 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 39 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 août 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Michael David Kirkman le 13 janv. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HARWORTH TRUSTEES LTD ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCH, Christopher Michael | Administrateur | Poplar Way Catcliffe S60 5TR Rotherham Advantage House United Kingdom | United Kingdom | British | 287032970001 | |||||||||
| PATMORE, Katerina Jane | Administrateur | Poplar Way Catcliffe S60 5TR Rotherham Advantage House United Kingdom | United Kingdom | British | 246771050001 | |||||||||
| SHILLAW, Lynda Margaret | Administrateur | Poplar Way Catcliffe S60 5TR Rotherham Advantage House United Kingdom | United Kingdom | British | 94296330002 | |||||||||
| COLE, Richard Andrew | Secrétaire | Lodge Farm Eakring Road, Wellow NG22 0EG Newark Nottinghamshire | British | 58361870002 | ||||||||||
| GARNESS, Melvin | Secrétaire | 11 The Drive DN22 6SD Retford Nottinghamshire | British | 18761260001 | ||||||||||
| ODONNELL, Benjamin John Fletcher | Secrétaire | 65 Fleet Street EC4Y 1HS London | British | 66560880001 | ||||||||||
| RHODES, Jeremy | Secrétaire | Harworth Park Blyth Road DN11 8DB Harworth Doncaster | British | 169993980001 | ||||||||||
| HARWORTH SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secrétaire | Poplar Way Catcliffe S60 5TR Rotherham Advantage House United Kingdom |
| 172322000002 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BALL, Ian Richard | Administrateur | Poplar Way Catcliffe S60 5TR Rotherham Advantage House United Kingdom | England | British | 96438580003 | |||||||||
| BINDER, Alan Naismith | Administrateur | Old Place Speldhurst TN3 0PA Tunbridge Wells Kent | British | 15929750001 | ||||||||||
| BIRCH, Christopher Michael | Administrateur | S60 5WG Rotherham Amp Technology Centre, Brunel Way South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 287032970001 | |||||||||
| BROCKSOM, David Graham | Administrateur | 7 York Road HG1 2QA Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 96416100003 | |||||||||
| BUCKLAND, Ross, Sir | Administrateur | 24 Vale Court 28 Maida Vale W9 1RT London | Australian | 11908840003 | ||||||||||
| COLE, Richard Andrew | Administrateur | Eakring Road Wellow NG22 0EG Newark Lodge Farm | England | British | 58361870002 | |||||||||
| EVANS, Simon John Morton | Administrateur | 65 Fleet Street EC4Y 1HS London | United Kingdom | British | 49783650002 | |||||||||
| GARNESS, Melvin | Administrateur | 11 The Drive DN22 6SD Retford Nottinghamshire | United Kingdom | British | 18761260001 | |||||||||
| HAGUE, Jeremy Richard | Administrateur | Park Crescent DN22 6UF Retford 5 Nottinghamshire United Kingdom | England | British | 115747040001 | |||||||||
| KIRKMAN, Andrew Michael David | Administrateur | Poplar Way Catcliffe S60 5TR Rotherham Advantage House United Kingdom | United Kingdom | British | 158885840002 | |||||||||
| LLOYD, Jonathan Simon | Administrateur | Orchard House Marton Cum Grafton YO51 9QY York | United Kingdom | British | 95211330002 | |||||||||
| MASON, Geoffrey Keith Howard | Administrateur | S60 5WG Rotherham Amp Technology Centre, Brunel Way South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 37404250003 | |||||||||
| MASON, Geoffrey Keith Howard | Administrateur | Harworth Park Blyth Road DN11 8DB Harworth Doncaster | United Kingdom | British | 37404250003 | |||||||||
| MAWE, Christopher | Administrateur | 5 Back Lane Whixley YO26 8BG York North Yorkshire | British | 99084660001 | ||||||||||
| MCPHIE, Gordon Allister | Administrateur | Wigley Green Farmhouse S42 7JJ Old Brampton Derbyshire | British | 35904020001 | ||||||||||
| MCPHIE, Gordon Allister | Administrateur | Wigley Green Farmhouse S42 7JJ Old Brampton Derbyshire | British | 35904020001 | ||||||||||
| MICHAELSON, Richard Owen | Administrateur | Poplar Way Catcliffe S60 5TR Rotherham Advantage House United Kingdom | England | British | 174637950001 | |||||||||
| ODONNELL, Benjamin John Fletcher | Administrateur | 65 Fleet Street EC4Y 1HS London | British | 66560880001 | ||||||||||
| RHODES, Jeremy | Administrateur | Harworth Park Blyth Road DN11 8DB Harworth Doncaster | United Kingdom | British | 170032420001 | |||||||||
| RICHARDSON, Michael | Administrateur | S60 5WG Rotherham Amp Technology Centre, Brunel Way South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 192682710001 | |||||||||
| SHRAGER, Robert Neil | Administrateur | Woodstock 5 Hollycroft Avenue Hampstead NW3 7QG London | British | 19091200001 | ||||||||||
| SPINDLER, Garold Ralph | Administrateur | Manor House Westhaugh Tumbling Hill Carleton WF8 2RP Pontefract | American | 101195530002 | ||||||||||
| STAPLES, Brian Lynn | Administrateur | Pendle House Castle Hill Prestbury SK10 4AR Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 55479560003 | |||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HARWORTH TRUSTEES LTD ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harworth Group Plc | 06 avr. 2016 | Brunel Way Catcliffe S60 5WG Rotherham Advanced Manufacturing Technology Centre England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0