NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02984572 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Frp Advisory Trading Limited 4th Floor Abbey House M2 4AB 32 Booth Street Manchester |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 11 pages | LIQ13 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 oct. 2022 | 10 pages | LIQ03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de First Floor 500 Pavilion Drive Northampton Business Park Northampton NN4 7YJ à C/O Frp Advisory Trading Limited 4th Floor Abbey House 32 Booth Street Manchester M2 4AB le 03 nov. 2021 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 7 pages | LIQ01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2020 | 21 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2019 | 19 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Keith Alan Reid en tant qu'administrateur le 23 avr. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Damien Holton en tant que directeur le 01 mars 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2018 | 20 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2017 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de James Huxley Milne en tant qu'administrateur le 08 déc. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Steven Neville Hardman en tant que directeur le 08 déc. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Edward Hinton en tant que directeur le 08 déc. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Eric Philippe Marianne Machiels en tant que directeur le 08 déc. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Jonathan Gregson en tant que directeur le 08 déc. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Michael Holton en tant qu'administrateur le 08 déc. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG, Jacqueline | Secrétaire | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive United Kingdom | 204213710001 | |||||||
| MILNE, James Huxley | Administrateur | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 220566330001 | |||||
| PICKERING, Stephen Shane | Administrateur | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 198076630001 | |||||
| REID, Keith Alan | Administrateur | NN4 7YJ Northampton Business Park First Floor 500 Pavilion Drive Northampton United Kingdom | United Kingdom | British | 179486220003 | |||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Secrétaire | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | 201246050001 | |||||||
| BISSET, Graham Ferguson | Secrétaire | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive Northamptonshire United Kingdom | 194567030001 | |||||||
| CALDER, Samantha Jane | Secrétaire | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor | British | 75830790003 | ||||||
| CRAIG, Martin | Secrétaire | 6 Burlington Road N10 1NJ London | British | 40902650003 | ||||||
| FITZHERBERT, David Henry | Secrétaire | 12 Gordon Place W8 4JD London | Irish | 74254060001 | ||||||
| OLDROYD, Elizabeth Alexandra | Secrétaire | 19 Middle Stoke Limpley Stoke BA2 7GF Bath | British | 98205520001 | ||||||
| PENTECOST, Alexandra Helen | Secrétaire | 2 Stratton Villas Milbourne SN16 9JB Malmesbury Wiltshire | British | 70254590001 | ||||||
| TEMPLES (NOMINEES) LIMITED | Secrétaire désigné | 152 City Road EC1V 2NX London | 900004500001 | |||||||
| AIKMAN, Elizabeth Jane | Administrateur | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor | United Kingdom | British | 294355310001 | |||||
| AXFORD, Eric Sidney | Administrateur | La Pierre Blanche Mont Es Croix JE3 8EN St Brelade Jersey C I | Jersey | British | 56102260002 | |||||
| BOYD, Gordon Alexander | Administrateur | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor | England | British | 148856600001 | |||||
| EDWARDS, Mark Simon | Administrateur | 2 Brook House Court Lakeside Road WA13 0GR Lymm Cheshire | British | 109659860001 | ||||||
| FITZHERBERT, David Henry | Administrateur | 12 Gordon Place W8 4JD London | United Kingdom | Irish | 74254060001 | |||||
| FITZSIMMONS, David Stephen | Administrateur | Hammer Tower Penshurst TN11 8HZ Tonbridge Kent | United Kingdom | British | 109928450001 | |||||
| GIBBINS, Stewart Charles | Administrateur | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 148918290002 | |||||
| GREGSON, Paul Jonathan | Administrateur | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor | England | British | 154908310001 | |||||
| HARDMAN, Steven Neville | Administrateur | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | Uk | British | 93743250007 | |||||
| HEWSON, John Francis | Administrateur | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor | United Kingdom | British | 120308140001 | |||||
| HINTON, Thomas Edward | Administrateur | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 238940970001 | |||||
| HOLTON, Michael Damien | Administrateur | NN4 7YJ Northampton Business Park First Floor 500 Pavilion Drive Northampton United Kingdom | England | British | 220533770001 | |||||
| MACHIELS, Eric Philippe Marianne | Administrateur | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | Belgian | 125748990002 | |||||
| MILLER, David Muir | Administrateur | The Old Boat House Inn 1 Warrington Lane WA13 0UH Lymm Cheshire | United Kingdom | British | 69864850004 | |||||
| QUINLAN, Rory John | Administrateur | Flat 12 25 Queen's Gate Gardens South Kensington SW7 5RP London | Australian | 113941780001 | ||||||
| ROUND, Richard Calvin | Administrateur | Elimbriar 8 Station Road Stanbridge LU7 9JF Leighton Buzzard Beds | Uk | British | 108158250002 | |||||
| WEST, Andrew Thomas | Administrateur | 4 Filkins Hall Filkins GL7 3JJ Lechdale Gloucestershire | United Kingdom | British | 79568920001 | |||||
| WYNDHAM, Harry Hugh Patrick | Administrateur | 56 Stockwell Park Crescent SW9 0DG London | England | British | 37118660001 | |||||
| TEMPLES (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED | Administrateur désigné | 152 City Road EC1V 2NX London | 900004490001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novera Energy (Holdings 2) Limited | 06 avr. 2016 | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton 500 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 14 sept. 2012 Livré le 21 sept. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 16 févr. 2006 Livré le 17 févr. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the borrower and the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right,title and interest from time to time in and to each of the following assets,the real property,the tangible moveable property,the accounts,the intellectual property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Share charge deed | Créé le 23 nov. 1995 Livré le 13 déc. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any financing document or hedging instrument pursuant to clause 2 of the deed as defined therein | |
Brèves mentions All of the securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Cross guarantee and debenture | Créé le 23 nov. 1995 Livré le 13 déc. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies as defined therein to the chargee under any financing document or hedging instrument as defined in the cross guarantee and debenture | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
NOVERA ENERGY GENERATION NO. 3 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0