LEE COOPER GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLEE COOPER GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02984862
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LEE COOPER GROUP LIMITED ?

    • (1824) /

    Où se situe LEE COOPER GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Gloucester House
    72 London Road
    AL1 1NS St. Albans
    Hertfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LEE COOPER GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CHIEFCO HOLDINGS PLC14 nov. 199414 nov. 1994
    DE FACTO 373 LIMITED31 oct. 199431 oct. 1994

    Quels sont les derniers comptes de LEE COOPER GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au03 mars 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour LEE COOPER GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    18 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 juil. 2012

    22 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 juil. 2011

    34 pages4.68

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    10 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 06 juil. 2010

    LRESEX

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 06 juil. 2010

    LRESEX

    Changement d'adresse du siège social de Hamilton House Mabledon Place London WC1H 9BB le 11 juin 2010

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 6 Snow Hill London Uk EC1A 2AY le 21 mai 2010

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Stefaan Le Clair en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    9 pages395

    legacy

    8 pages395

    Résolutions

    Resolutions
    5 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages287

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes annuels établis au 03 mars 2007

    16 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de LEE COOPER GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HANN, Indira
    Danecroft
    Oldfield Road
    SL6 1TX Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    Danecroft
    Oldfield Road
    SL6 1TX Maidenhead
    Berkshire
    British118446370001
    BAZANTAY, Emmanuel Patrick Serge
    Rue Roland Douay
    80080 Amiens
    55
    Amiens
    France
    Administrateur
    Rue Roland Douay
    80080 Amiens
    55
    Amiens
    France
    French140033000001
    DUNKLEY, Andrew Albert
    High Street
    Nash
    MK17 0EP Milton Keynes
    20
    Buckinghamshire
    Administrateur
    High Street
    Nash
    MK17 0EP Milton Keynes
    20
    Buckinghamshire
    EnglandBritish134204360001
    BERRY, John Graham
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    Secrétaire
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    British10711650001
    FARRINGTON, David John
    23 Napoleon Road
    TW1 3EW Twickenham
    Middlesex
    Secrétaire
    23 Napoleon Road
    TW1 3EW Twickenham
    Middlesex
    British13372050001
    LAUGHTON, Mark Timothy
    Nesfield
    Andertons Lane, Henbury
    SK11 9PB Macclesfield
    Cheshire
    Secrétaire
    Nesfield
    Andertons Lane, Henbury
    SK11 9PB Macclesfield
    Cheshire
    British121239790001
    LEWIS, Sally Elizabeth
    5 Fellows Road
    NW3 3LR London
    Secrétaire
    5 Fellows Road
    NW3 3LR London
    British4807180001
    RICHARDS, Alan Jeffrey
    Tiryns Forest Road
    RG40 5QR Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    Tiryns Forest Road
    RG40 5QR Wokingham
    Berkshire
    British1437330001
    WALL, John Robert
    9 Fairlawn Park
    St Leonards Hill
    SL4 4HL Windsor
    Berkshire
    Secrétaire
    9 Fairlawn Park
    St Leonards Hill
    SL4 4HL Windsor
    Berkshire
    British72368120001
    YOUNG, Mark Osborne
    2 Oyster Quay
    Port Solent
    PO6 4TE Portsmouth
    Hampshire
    Secrétaire
    2 Oyster Quay
    Port Solent
    PO6 4TE Portsmouth
    Hampshire
    British71930040003
    S & J REGISTRARS LIMITED
    99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    Secrétaire
    99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    43122090005
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Secrétaire désigné
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001
    BURNETT, Christopher Thomas
    Moorfield Rombalds Lane
    Ben Rhydding
    LS29 8RT Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Moorfield Rombalds Lane
    Ben Rhydding
    LS29 8RT Ilkley
    West Yorkshire
    British905440001
    DE LALANDE DE L'HERAUDIERE, Bruno Marie Jaques Goudon
    7 Rue A. De Saint-Exupery
    FOREIGN Lyon
    69002
    France
    Administrateur
    7 Rue A. De Saint-Exupery
    FOREIGN Lyon
    69002
    France
    French121807520001
    DE VILMORIN, Philippe-Andre
    16 Boulevard Emile Augier
    FOREIGN 75016 Paris
    France
    Administrateur
    16 Boulevard Emile Augier
    FOREIGN 75016 Paris
    France
    French65336490002
    DEGIOANNI, Thierry Antoine Michel
    10 Rue De Paris
    Orsay
    91400
    France
    Administrateur
    10 Rue De Paris
    Orsay
    91400
    France
    French121806980001
    DJEMMALI, Hosni
    11 Rue Iben Rachiq
    Tunis
    Tunisia
    Administrateur
    11 Rue Iben Rachiq
    Tunis
    Tunisia
    Tunisia41812320001
    DJILANI, Hedi
    2 Bis Rue Du Reservoir
    Tunis
    Tunisia
    Administrateur
    2 Bis Rue Du Reservoir
    Tunis
    Tunisia
    Tunisian41812080001
    DJILANI, Mohamed Hechmi
    2 Bis Rue Du Reservoir
    FOREIGN Tunis
    1008
    Tunisia
    Administrateur
    2 Bis Rue Du Reservoir
    FOREIGN Tunis
    1008
    Tunisia
    Tunisian73518380001
    DUTTON, Philip
    23 Quarry Dene
    LS16 8PA Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    23 Quarry Dene
    LS16 8PA Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish141395280001
    GERETY, James Anthony
    22 Leadale Avenue
    Chingford
    E4 8AT London
    Administrateur
    22 Leadale Avenue
    Chingford
    E4 8AT London
    EnglandBritish35957840001
    HARDY, Christopher Paul Cecil
    Flat 1 30 Bolton Gardens
    SW5 0AQ London
    Administrateur
    Flat 1 30 Bolton Gardens
    SW5 0AQ London
    British59163510001
    HARGREAVES, Jason
    328 The Colonnades
    Albert Dock
    L3 4AB Liverpool
    Administrateur
    328 The Colonnades
    Albert Dock
    L3 4AB Liverpool
    British80102490001
    HARGREAVES, John
    1st Floor, Block C, Houston Palace
    1 Avenue Princess Grace
    Monaco
    Mc 98000
    Administrateur
    1st Floor, Block C, Houston Palace
    1 Avenue Princess Grace
    Monaco
    Mc 98000
    British116048300001
    HICK, Paul Arney
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish47699120005
    JACKSON, William Nicholas
    9 Napier Avenue
    SW6 3PS London
    Administrateur
    9 Napier Avenue
    SW6 3PS London
    British43321760002
    JORDAN KEANE, Miriam
    48 Queens Gate
    SW7 5JN London
    Administrateur
    48 Queens Gate
    SW7 5JN London
    British48402680003
    KHAITAN, Ajay
    Robsart House 10 Abingdon Road
    OX2 9QN Oxford
    Cumnor
    Administrateur
    Robsart House 10 Abingdon Road
    OX2 9QN Oxford
    Cumnor
    United KingdomBritish87678640006
    KING, John
    Crossley House Crossley Park
    New Pale Road
    WA6 6JG Manley
    Cheshire
    Administrateur
    Crossley House Crossley Park
    New Pale Road
    WA6 6JG Manley
    Cheshire
    British81185040003
    LAUGHTON, Mark Timothy
    Nesfield
    Andertons Lane, Henbury
    SK11 9PB Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    Nesfield
    Andertons Lane, Henbury
    SK11 9PB Macclesfield
    Cheshire
    British121239790001
    LE CLAIR, Stefaan A
    A. Vermaelenstraat 4
    Blanden
    3052
    Belgium
    Administrateur
    A. Vermaelenstraat 4
    Blanden
    3052
    Belgium
    Belgian123657490001
    MASON, Paul
    Darwin Bank
    Whiddon Croft, Menston
    LS29 6QQ Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Darwin Bank
    Whiddon Croft, Menston
    LS29 6QQ Ilkley
    West Yorkshire
    British117547810001
    MAUNSELL, Christopher Ernest
    Upton Manor High Street
    Upton
    OX11 9JE Didcot
    Oxfordshire
    Administrateur
    Upton Manor High Street
    Upton
    OX11 9JE Didcot
    Oxfordshire
    EnglandBritish544600001
    MOORES, Robert Patrick
    51 Airedale Avenue
    W4 2NW London
    Administrateur
    51 Airedale Avenue
    W4 2NW London
    British47268200001
    NG, Frederick Tak Wai
    13/F Block L
    141 Prince Edward Road West Kowloon
    FOREIGN Hong Kong
    Administrateur
    13/F Block L
    141 Prince Edward Road West Kowloon
    FOREIGN Hong Kong
    Chinese64183300004

    LEE COOPER GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Créé le 26 août 2009
    Livré le 09 sept. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Investec Bank PLC
    Transactions
    • 09 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of pledge over inventory
    Créé le 26 août 2009
    Livré le 08 sept. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the pledgor and any obligor to any of the pledgees under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The entire current and future value of the inventory see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited and Investec Bank PLC
    Transactions
    • 08 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of variation
    Créé le 12 janv. 2007
    Livré le 27 janv. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the obligors and/or lee cooper suisse sa to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited (The Security Holder)
    Transactions
    • 27 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 20 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited as Security Agent for Ge Factofrance Snc
    Transactions
    • 20 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 20 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due of each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited ("the Security Holder")
    Transactions
    • 20 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 15 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due of each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 15 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 04 mai 2005
    Livré le 24 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lee Cooper Finance, Inc
    Transactions
    • 24 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 juin 1996
    Livré le 16 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with any of the offer facilities agreement and the refinance credit agreement and any other agreement which is included within the definitions of the financing documents and under the debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 02 déc. 1994
    Livré le 14 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the secured parties and to the secured parties (as defined) on any account whatsoever under or in connection with any of the transaction documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    LEE COOPER GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    06 juil. 2010Commencement of winding up
    14 févr. 2014Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Hunt
    Griffins
    Tavistock House South
    WC1H 9LG Tavistock Square
    London
    practitioner
    Griffins
    Tavistock House South
    WC1H 9LG Tavistock Square
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0