GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02988710 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED ?
| Adresse du siège social | Staple Court 11 Staple Inn Buildings WC1V 7QH London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2012 |
Quels sont les derniers dépôts pour GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2012 | 15 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2011 | 15 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mark Andrew John Harrison le 09 nov. 2011 | 2 pages | CH03 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Andrew John Harrison le 09 nov. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Fraser Gregory en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Divers 519 | 2 pages | MISC | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 20 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination de Mark Andrew John Harrison en tant que secrétaire | 3 pages | AP03 | ||||||||||||||
legacy | 11 pages | MG01 | ||||||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2010 au 31 mars 2011 | 4 pages | AA01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Bupa House Limited 15-19 Bloomsbury Way London le 01 oct. 2010 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Bupa Secretaries Limited en tant que secrétaire | 2 pages | TM02 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Flanagan en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Nicholas Beazley en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Mahboob Merchant en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRISON, Mark Andrew John | Secrétaire | Floor Olympic House 3 Olympic Way HA9 0NP Wembley 2nd United Kingdom | British | 154574090001 | ||||||
| HARRISON, Mark Andrew John, Mr. | Administrateur | Olympic House 3 Olympic Way HA9 0NP Wembley 2nd Floor United Kingdom | England | British | 112670960001 | |||||
| RUSHTON, Craig | Administrateur | 11 Staple Inn Buildings WC1V 7QH London Staple Court | United Kingdom | British | 149583960001 | |||||
| CUNNINGHAM, Thomas Bennie | Secrétaire | Trumpeters Lodge School Lane, Borden ME9 8JS Sittingbourne Kent England | British | 41165870002 | ||||||
| LYON, David Oliver | Secrétaire | 41 Park Avenue North AL5 2EE Harpenden Hertfordshire | British | 51084280003 | ||||||
| BUPA SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Bupa House Limited 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London | 117754090001 | |||||||
| PARAMOUNT COMPANY SEARCHES LIMITED | Secrétaire désigné | 229 Nether Street N3 1NT London | 900001530001 | |||||||
| BEAZLEY, Nicholas Tetley | Administrateur | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 105797560001 | |||||
| BURNS, Gary Victor | Administrateur | Thatchers Swanton Street, Bredgar ME9 8AP Sittingbourne Kent | British | 80009890002 | ||||||
| BURNS, Robert Ian | Administrateur | 6 Netherfield Road AL5 2AG Harpenden Hertfordshire | England | British | 36584260002 | |||||
| CUNNINGHAM, Annie Hastie | Administrateur | Trumpeters Lodge School Lane, Borden ME9 8JS Sittingbourne Kent England | England | British | 11335690002 | |||||
| DAVIES, Julian Peter | Administrateur | Timberlea, Warminster Road South Newton SP2 0QW Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 29367700001 | |||||
| FLANAGAN, Stephen David | Administrateur | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 117787010001 | |||||
| GREGORY, Fraser David | Administrateur | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 107664270003 | |||||
| KEE, Fergus Alexander | Administrateur | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | Irish | 26911740008 | |||||
| KENT, Benjamin David Jemphrey | Administrateur | Fernleigh Lodge Northchurch Common HP4 1LR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 93897360003 | |||||
| LOS, Steven Michael | Administrateur | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 116895800001 | |||||
| LYON, David Oliver | Administrateur | 41 Park Avenue North AL5 2EE Harpenden Hertfordshire | England | British | 51084280003 | |||||
| MERCHANT, Mahboob Ali | Administrateur | 28 Denham Road KT17 3AA Epsom Surrey | United Kingdom | British | 56732410001 | |||||
| SHEEHY, Stuart David | Administrateur | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | England | British | 123217250001 | |||||
| SPOORS, Mark | Administrateur | 27 Newfield Way Highfield Park AL4 0GB St Albans Hertfordshire | British | 72289290002 | ||||||
| PARAMOUNT PROPERTIES (UK) LIMITED | Administrateur désigné | 229 Nether Street N3 1NT London | 900001520001 |
GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Security accession deed | Créé le 24 sept. 2010 Livré le 02 oct. 2010 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 24 sept. 2010 Livré le 30 sept. 2010 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee and/or the noteholders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 30 juin 2006 Livré le 11 juil. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the chargor to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 22 juin 2004 Livré le 24 juin 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 07 sept. 1995 Livré le 14 sept. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0