GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED

GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02988710
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Staple Court
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BETACARE LIMITED10 nov. 199410 nov. 1994

    Quels sont les derniers comptes de GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Company business 12/11/2012
    RES13

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 nov. 2012

    État du capital au 12 nov. 2012

    • Capital: GBP 3
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mark Andrew John Harrison le 09 nov. 2011

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Andrew John Harrison le 09 nov. 2011

    2 pagesCH01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Approval of transaction documents 02/11/2011
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Docs approved 31/03/2011
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Fraser Gregory en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Divers

    519
    2 pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    20 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Restatement agreement approved/ company directors authorised 24/09/2010
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Nomination de Mark Andrew John Harrison en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    legacy

    11 pagesMG01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2010 au 31 mars 2011

    4 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de Bupa House Limited 15-19 Bloomsbury Way London le 01 oct. 2010

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Bupa Secretaries Limited en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Stephen Flanagan en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nicholas Beazley en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mahboob Merchant en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HARRISON, Mark Andrew John
    Floor
    Olympic House 3 Olympic Way
    HA9 0NP Wembley
    2nd
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    Olympic House 3 Olympic Way
    HA9 0NP Wembley
    2nd
    United Kingdom
    British154574090001
    HARRISON, Mark Andrew John, Mr.
    Olympic House
    3 Olympic Way
    HA9 0NP Wembley
    2nd Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Olympic House
    3 Olympic Way
    HA9 0NP Wembley
    2nd Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish112670960001
    RUSHTON, Craig
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Staple Court
    Administrateur
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Staple Court
    United KingdomBritish149583960001
    CUNNINGHAM, Thomas Bennie
    Trumpeters Lodge
    School Lane, Borden
    ME9 8JS Sittingbourne
    Kent
    England
    Secrétaire
    Trumpeters Lodge
    School Lane, Borden
    ME9 8JS Sittingbourne
    Kent
    England
    British41165870002
    LYON, David Oliver
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    Secrétaire
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    British51084280003
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Bupa House Limited
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Secrétaire
    Bupa House Limited
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    117754090001
    PARAMOUNT COMPANY SEARCHES LIMITED
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    Secrétaire désigné
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    900001530001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish105797560001
    BURNS, Gary Victor
    Thatchers
    Swanton Street, Bredgar
    ME9 8AP Sittingbourne
    Kent
    Administrateur
    Thatchers
    Swanton Street, Bredgar
    ME9 8AP Sittingbourne
    Kent
    British80009890002
    BURNS, Robert Ian
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish36584260002
    CUNNINGHAM, Annie Hastie
    Trumpeters Lodge
    School Lane, Borden
    ME9 8JS Sittingbourne
    Kent
    England
    Administrateur
    Trumpeters Lodge
    School Lane, Borden
    ME9 8JS Sittingbourne
    Kent
    England
    EnglandBritish11335690002
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish29367700001
    FLANAGAN, Stephen David
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish117787010001
    GREGORY, Fraser David
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish107664270003
    KEE, Fergus Alexander
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomIrish26911740008
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish93897360003
    LOS, Steven Michael
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish116895800001
    LYON, David Oliver
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish51084280003
    MERCHANT, Mahboob Ali
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    Administrateur
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish56732410001
    SHEEHY, Stuart David
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    EnglandBritish123217250001
    SPOORS, Mark
    27 Newfield Way
    Highfield Park
    AL4 0GB St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    27 Newfield Way
    Highfield Park
    AL4 0GB St Albans
    Hertfordshire
    British72289290002
    PARAMOUNT PROPERTIES (UK) LIMITED
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    Administrateur désigné
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    900001520001

    GUARDIAN HOMECARE KENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security accession deed
    Créé le 24 sept. 2010
    Livré le 02 oct. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 24 sept. 2010
    Livré le 30 sept. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee and/or the noteholders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sovereign Capital Partners LLP as Security Trustee for Itself and the Noteholders
    Transactions
    • 30 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 30 juin 2006
    Livré le 11 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 11 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 juin 2004
    Livré le 24 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 24 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 07 sept. 1995
    Livré le 14 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0