GROVE FRESH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGROVE FRESH LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02994068
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GROVE FRESH LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe GROVE FRESH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GROVE FRESH LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FLORIDA EXPORTS LIMITED18 nov. 199418 nov. 1994

    Quels sont les derniers comptes de GROVE FRESH LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour GROVE FRESH LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour GROVE FRESH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Retrait de la demande de radiation de la société

    1 pagesDS02

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Wellness Foods Limited Orchard Lea Winkfield Lane Winkfield Windsor SL4 4RU à 72 Manton Road Earlstrees Industrial Estate Corby Northants NN17 4JL

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 3000 Hillswood Business Park Hillswood Drive Chertsey England KT16 0RS à Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR le 26 nov. 2014

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 10 nov. 2014

    LRESSP

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    14 pagesAA

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    2 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 déc. 2013

    État du capital au 05 déc. 2013

    • Capital: GBP 8,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    17 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Gerard Vincent Magee le 28 oct. 2011

    2 pagesCH01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré

    1 pagesAD04

    Modification des coordonnées du secrétaire Mark John Lane le 21 oct. 2011

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mark John Lane le 21 oct. 2011

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de GROVE FRESH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LANE, Mark John
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Secrétaire
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    British151310030001
    LANE, Mark John
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    British132183700001
    MAGEE, Gerard Vincent
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    IrelandIrish151272980001
    ASHBY, David John
    20 Earlsbrook Road
    RH1 6DP Redhill
    Surrey
    Secrétaire
    20 Earlsbrook Road
    RH1 6DP Redhill
    Surrey
    British102448200001
    BAILEY, Betty Patricia
    17 Browning Road
    Fetcham
    KT22 9HN Leatherhead
    Surrey
    Secrétaire
    17 Browning Road
    Fetcham
    KT22 9HN Leatherhead
    Surrey
    British27277550001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    SHUPICK, Andrew Colin
    21 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    Secrétaire
    21 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    British42780010003
    WSM SERVICES LIMITED
    Derwent House
    35 South Park Road
    SW19 8RR London
    Secrétaire
    Derwent House
    35 South Park Road
    SW19 8RR London
    30807900001
    HATTON, Christina Dorothy
    32 Belmont Rise
    Cheam
    SM2 6EQ Sutton
    Surrey
    Administrateur
    32 Belmont Rise
    Cheam
    SM2 6EQ Sutton
    Surrey
    British43261850001
    HOLLOWELL, Trevor
    Carden Marsh
    Carden Tilston
    SY14 7HR Malpas
    Cheshire
    Administrateur
    Carden Marsh
    Carden Tilston
    SY14 7HR Malpas
    Cheshire
    British40326570001
    O'CONNOR, Philip Stephen
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Administrateur
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandIrish107745290001
    PARSONS, Howard Lewis
    3 The Downs Llhergy Cripperty
    Union Mills
    IM4 4NQ Douglas
    Isle Of Man
    Administrateur
    3 The Downs Llhergy Cripperty
    Union Mills
    IM4 4NQ Douglas
    Isle Of Man
    British43336610001
    SCHREUDER, Willem Meindert
    1m Stillen Winkel 3
    Krefeld
    D47804
    Germany
    Administrateur
    1m Stillen Winkel 3
    Krefeld
    D47804
    Germany
    Dutch95349710001
    SHEWRING, David
    14 Crooms Hill
    Greenwich
    SE10 8ER London
    Administrateur
    14 Crooms Hill
    Greenwich
    SE10 8ER London
    British41904940001
    SHUPICK, Andrew Colin
    21 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    Administrateur
    21 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    EnglandBritish42780010003
    TAYLOR, Mark John
    North Croft
    Station Road
    CR3 7DE Woldingham
    Surrey
    Administrateur
    North Croft
    Station Road
    CR3 7DE Woldingham
    Surrey
    United KingdomBritish9677100002
    TAYLOR, Nancy Jane
    6 South Park Mews
    Fulham
    SW6 3AY London
    Administrateur
    6 South Park Mews
    Fulham
    SW6 3AY London
    UkBritish19800190002
    TOOMEY, John Francis
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Administrateur
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandIrish164624980001

    GROVE FRESH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A supplemental deed
    Créé le 13 janv. 2010
    Livré le 14 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 14 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite debenture
    Créé le 24 déc. 2009
    Livré le 08 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge over any right title or interest in any land and all shareas related rights and all distribution rights thereon; all investments and related rights all book debts benefits and security thereon; all non trading debts and all benefits rights and security thereunder; fixed charge over all amounts standing to the credit of each account and any other amount; all property rights all fees royalties and other rights thereon; the goodwill and uncalled capital and benefit of all authorisations held in relation to any security interest; all insurances and floating charge over all undertaking and assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 08 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security accession deed
    Créé le 14 janv. 2009
    Livré le 27 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Part second floor offices saxley court victoria road horley t/no SY742440; fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Agent and Trustee for Itself and the Finance Parties)
    Transactions
    • 27 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental deed
    Créé le 14 mars 2008
    Livré le 31 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Trustee for the Finance Parties) (the Security Trustee)
    Transactions
    • 31 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security accession deed
    Créé le 30 mars 2007
    Livré le 05 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Part second floor offices, saxley court, victoria road, horley t/no SY742440 by way of fixed charge the land; shares; investments; equipment and book debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Trustee for the Finance Parties (Thesecurity Trustee)
    Transactions
    • 05 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 05 janv. 2007
    Livré le 10 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    GROVE FRESH LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 nov. 2014Commencement of winding up
    01 juil. 2015Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0