CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED

CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03002225
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des autres sociétés holding n.c.a. (64209) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    6 Jephson Court
    Tancred Close
    CV31 3RZ Leamington Spa
    Warwickshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VILTSTYLE LIMITED16 déc. 199416 déc. 1994

    Quels sont les derniers comptes de CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 04 oct. 2016

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Amount capital reduced be credited to a reserve 29/02/2016
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Changement d'adresse du siège social de 100 New Bridge Street London EC4V 6JA à 6 Jephson Court Tancred Close Leamington Spa Warwickshire CV31 3RZ le 18 mai 2016

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Abogado Nominees Limited en tant que secrétaire le 10 févr. 2016

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 déc. 2015

    État du capital au 22 déc. 2015

    • Capital: GBP 501,175
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Abogado Nominees Limited le 01 oct. 2009

    1 pagesCH04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Simon David Whittaker en tant que directeur le 27 mars 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul Stephen Lewis en tant qu'administrateur le 10 juin 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    16 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 janv. 2015

    État du capital au 12 janv. 2015

    • Capital: GBP 501,175
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    16 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 déc. 2013

    État du capital au 18 déc. 2013

    • Capital: GBP 501,175
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Simon David Whittaker le 28 sept. 2013

    3 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Terrance Helz en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Terrance Helz en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    17 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    17 pagesAR01

    Nomination de Martin Gerard Mullin en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEWIS, Paul Stephen
    Tancred Close
    CV31 3RZ Royal Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Tancred Close
    CV31 3RZ Royal Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    England
    EnglandBritishBusiness Executive163019350001
    MULLIN, Martin Gerard
    c/o Cooper Lighting And Safety Limited
    Wheatley Hall Road
    DN2 4NB Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    c/o Cooper Lighting And Safety Limited
    Wheatley Hall Road
    DN2 4NB Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishBusiness Executive150271550001
    BARKER, Jack
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    BritishSolicitors Clerk34404400001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Secrétaire désigné
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    FORSTER, Robert
    Shady Beech
    Greenfield Lane Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Shady Beech
    Greenfield Lane Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British5336440001
    HELZ, Terrance Valentine
    11 China Rose Court
    The Woodlands
    Texas
    77381
    Usa
    Secrétaire
    11 China Rose Court
    The Woodlands
    Texas
    77381
    Usa
    AmericanAttorney61652840001
    THOMASSON, Leigh
    32 Airedale Avenue
    Tickhill
    DN11 9UD Doncaster
    South Yorkshire
    Secrétaire
    32 Airedale Avenue
    Tickhill
    DN11 9UD Doncaster
    South Yorkshire
    BritishManaging Director41994080003
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Secrétaire désigné
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement01688036
    900021150001
    BARKER, Jack
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    BritishSolicitors Clerk34404400001
    BEYEN, Kris Maria August
    Tancred Close
    Queensway
    CV31 3RZ Royal Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    Administrateur
    Tancred Close
    Queensway
    CV31 3RZ Royal Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    United KingdomBelgianBusiness Executive157565820001
    BROOK, John Graeme
    Beechtree House
    Burn
    YO8 8LJ Selby
    North Yorkshire
    Administrateur
    Beechtree House
    Burn
    YO8 8LJ Selby
    North Yorkshire
    BritishChief Executive48960960001
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    Administrateur désigné
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Administrateur désigné
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    FORSTER, Robert
    Shady Beech
    Greenfield Lane Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Shady Beech
    Greenfield Lane Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director5336440001
    GAWRONSKI, Grant Lawrence
    19 Hunters Crossing Court
    The Woodlands
    Texas 77381
    Usa
    Administrateur
    19 Hunters Crossing Court
    The Woodlands
    Texas 77381
    Usa
    UsaAmericanBusiness Executive115387690001
    HAACK, Axel Gottfried Gunther
    9 Haute Corniche
    67210 Obernai
    France
    Administrateur
    9 Haute Corniche
    67210 Obernai
    France
    GermanBusiness Executive120071580001
    HELZ, Terrance Valentine
    11 China Rose Court
    The Woodlands
    Texas
    77381
    Usa
    Administrateur
    11 China Rose Court
    The Woodlands
    Texas
    77381
    Usa
    United StatesAmericanAttorney61652840001
    JONES, Clare Adele
    10 Heddon Place
    Headingley
    LS6 4EL Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    10 Heddon Place
    Headingley
    LS6 4EL Leeds
    West Yorkshire
    BritishSolicitor50145210001
    MAXWELL, Peter Willis
    Banbury Road
    CV37 7HW Stratford Upon Avon
    41
    Warwickshire
    Administrateur
    Banbury Road
    CV37 7HW Stratford Upon Avon
    41
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director60789150004
    PRIESTLEY, Robert
    118 Huddersfield Road
    Brighouse
    HD6 3RH Huddersfield
    Administrateur
    118 Huddersfield Road
    Brighouse
    HD6 3RH Huddersfield
    EnglandBritishCompany Director109114780001
    SCRIMSHAW, James Eric
    Dove House
    Temple Grafton
    B49 6NT Alcester
    Warwickshire
    Administrateur
    Dove House
    Temple Grafton
    B49 6NT Alcester
    Warwickshire
    BritishCompany Director60793220002
    SMITH, Gavin David
    144 Pannal Ash Road
    HG2 9AJ Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    144 Pannal Ash Road
    HG2 9AJ Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant102540130001
    THOMASSON, Leigh
    Alderson Drive
    Tickhill
    DN11 9HR Doncaster
    2
    South Yorkshire
    Administrateur
    Alderson Drive
    Tickhill
    DN11 9HR Doncaster
    2
    South Yorkshire
    EnglandUnited KingdomCompany Director41994080004
    VALE, Michael John
    16 West Hill
    Portishead
    BS20 9QL Bristol
    North Somerset
    Administrateur
    16 West Hill
    Portishead
    BS20 9QL Bristol
    North Somerset
    BritishSales Director37773560001
    WHITTAKER, Simon David
    Tancred Close
    Queensway
    CV31 3RZ Royal Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Tancred Close
    Queensway
    CV31 3RZ Royal Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director115390050002
    WILKINSON, David Kenworthy
    Barn Cottage Hebers Ghyll Drive
    LS29 9QH Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Barn Cottage Hebers Ghyll Drive
    LS29 9QH Ilkley
    West Yorkshire
    BritishInvestment Banker30236530001
    WINTERBOTTOM, David Stuart
    Walnuts End
    6 The Paddock Whitegate
    WA16 0GZ Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    Walnuts End
    6 The Paddock Whitegate
    WA16 0GZ Northwich
    Cheshire
    BritishDirector6529580001

    CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Créé le 17 oct. 1998
    Livré le 21 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the finance documents as described in the debenture on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandfor Itself and in Its Capacity as Security Trustee for the Other Beneficiaries as Described in the Debenture
    Transactions
    • 21 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental fixed charge
    Créé le 30 oct. 1995
    Livré le 31 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge all present and future benefits in respect of the policies (as defined) or such other policy or policies as may in accordance with the terms of this charge replace the same from time to time with the payment or discharge of all monies and liabilities hereby covenanted to be paid or discharged by the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 févr. 1995
    Livré le 10 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transactions
    • 10 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 03 févr. 1995
    Livré le 10 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge over on all present and future benefits in respect of the policies - as defined - or such other policy or policies as may in accordance with the terms of this charge replace the same from time to time with the payment or discharge of all monies and liabilities hereby covenanted to be paid or discharged by the company , please see doc for further details,.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transactions
    • 10 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 févr. 1995
    Livré le 09 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Plcas Agent for 3I Group PLC and 3I 94 Lmbo Plan
    Transactions
    • 09 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0