CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03002225 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED ?
Adresse du siège social | 6 Jephson Court Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa Warwickshire England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2014 |
Quels sont les derniers dépôts pour CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 04 oct. 2016
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 100 New Bridge Street London EC4V 6JA à 6 Jephson Court Tancred Close Leamington Spa Warwickshire CV31 3RZ le 18 mai 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Abogado Nominees Limited en tant que secrétaire le 10 févr. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Abogado Nominees Limited le 01 oct. 2009 | 1 pages | CH04 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 14 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Simon David Whittaker en tant que directeur le 27 mars 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Paul Stephen Lewis en tant qu'administrateur le 10 juin 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires | 16 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires | 16 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Simon David Whittaker le 28 sept. 2013 | 3 pages | CH01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Terrance Helz en tant que secrétaire | 2 pages | TM02 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Terrance Helz en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires | 17 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires | 17 pages | AR01 | ||||||||||||||
Nomination de Martin Gerard Mullin en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEWIS, Paul Stephen | Administrateur | Tancred Close CV31 3RZ Royal Leamington Spa Jephson Court Warwickshire England | England | British | Business Executive | 163019350001 | ||||||||
MULLIN, Martin Gerard | Administrateur | c/o Cooper Lighting And Safety Limited Wheatley Hall Road DN2 4NB Doncaster South Yorkshire | England | British | Business Executive | 150271550001 | ||||||||
BARKER, Jack | Secrétaire | 21 Silverdale Drive Guiseley LS20 8BE Leeds West Yorkshire | British | Solicitors Clerk | 34404400001 | |||||||||
DWYER, Daniel John | Secrétaire désigné | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||||||
FORSTER, Robert | Secrétaire | Shady Beech Greenfield Lane Guiseley LS20 8HF Leeds West Yorkshire | British | 5336440001 | ||||||||||
HELZ, Terrance Valentine | Secrétaire | 11 China Rose Court The Woodlands Texas 77381 Usa | American | Attorney | 61652840001 | |||||||||
THOMASSON, Leigh | Secrétaire | 32 Airedale Avenue Tickhill DN11 9UD Doncaster South Yorkshire | British | Managing Director | 41994080003 | |||||||||
ABOGADO NOMINEES LIMITED | Secrétaire désigné | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London |
| 900021150001 | ||||||||||
BARKER, Jack | Administrateur | 21 Silverdale Drive Guiseley LS20 8BE Leeds West Yorkshire | British | Solicitors Clerk | 34404400001 | |||||||||
BEYEN, Kris Maria August | Administrateur | Tancred Close Queensway CV31 3RZ Royal Leamington Spa Jephson Court Warwickshire | United Kingdom | Belgian | Business Executive | 157565820001 | ||||||||
BROOK, John Graeme | Administrateur | Beechtree House Burn YO8 8LJ Selby North Yorkshire | British | Chief Executive | 48960960001 | |||||||||
DOYLE, Betty June | Administrateur désigné | 8 The Bartons Elstree Hill North WD6 3EN Elstree Herts | British | 900003960001 | ||||||||||
DWYER, Daniel John | Administrateur désigné | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||||||
FORSTER, Robert | Administrateur | Shady Beech Greenfield Lane Guiseley LS20 8HF Leeds West Yorkshire | British | Company Director | 5336440001 | |||||||||
GAWRONSKI, Grant Lawrence | Administrateur | 19 Hunters Crossing Court The Woodlands Texas 77381 Usa | Usa | American | Business Executive | 115387690001 | ||||||||
HAACK, Axel Gottfried Gunther | Administrateur | 9 Haute Corniche 67210 Obernai France | German | Business Executive | 120071580001 | |||||||||
HELZ, Terrance Valentine | Administrateur | 11 China Rose Court The Woodlands Texas 77381 Usa | United States | American | Attorney | 61652840001 | ||||||||
JONES, Clare Adele | Administrateur | 10 Heddon Place Headingley LS6 4EL Leeds West Yorkshire | British | Solicitor | 50145210001 | |||||||||
MAXWELL, Peter Willis | Administrateur | Banbury Road CV37 7HW Stratford Upon Avon 41 Warwickshire | United Kingdom | British | Company Director | 60789150004 | ||||||||
PRIESTLEY, Robert | Administrateur | 118 Huddersfield Road Brighouse HD6 3RH Huddersfield | England | British | Company Director | 109114780001 | ||||||||
SCRIMSHAW, James Eric | Administrateur | Dove House Temple Grafton B49 6NT Alcester Warwickshire | British | Company Director | 60793220002 | |||||||||
SMITH, Gavin David | Administrateur | 144 Pannal Ash Road HG2 9AJ Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 102540130001 | ||||||||
THOMASSON, Leigh | Administrateur | Alderson Drive Tickhill DN11 9HR Doncaster 2 South Yorkshire | England | United Kingdom | Company Director | 41994080004 | ||||||||
VALE, Michael John | Administrateur | 16 West Hill Portishead BS20 9QL Bristol North Somerset | British | Sales Director | 37773560001 | |||||||||
WHITTAKER, Simon David | Administrateur | Tancred Close Queensway CV31 3RZ Royal Leamington Spa Jephson Court Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 115390050002 | ||||||||
WILKINSON, David Kenworthy | Administrateur | Barn Cottage Hebers Ghyll Drive LS29 9QH Ilkley West Yorkshire | British | Investment Banker | 30236530001 | |||||||||
WINTERBOTTOM, David Stuart | Administrateur | Walnuts End 6 The Paddock Whitegate WA16 0GZ Northwich Cheshire | British | Director | 6529580001 |
CROMPTON LIGHTING HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and mortgage debenture | Créé le 17 oct. 1998 Livré le 21 oct. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the finance documents as described in the debenture on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Supplemental fixed charge | Créé le 30 oct. 1995 Livré le 31 oct. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge all present and future benefits in respect of the policies (as defined) or such other policy or policies as may in accordance with the terms of this charge replace the same from time to time with the payment or discharge of all monies and liabilities hereby covenanted to be paid or discharged by the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 03 févr. 1995 Livré le 10 févr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed charge | Créé le 03 févr. 1995 Livré le 10 févr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions First fixed charge over on all present and future benefits in respect of the policies - as defined - or such other policy or policies as may in accordance with the terms of this charge replace the same from time to time with the payment or discharge of all monies and liabilities hereby covenanted to be paid or discharged by the company , please see doc for further details,. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 03 févr. 1995 Livré le 09 févr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0