MICHAEL AUKETT ARCHITECTS LTD.

MICHAEL AUKETT ARCHITECTS LTD.

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMICHAEL AUKETT ARCHITECTS LTD.
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03003256
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MICHAEL AUKETT ARCHITECTS LTD. ?

    • Activités d'architecture (71111) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe MICHAEL AUKETT ARCHITECTS LTD. ?

    Adresse du siège social
    Lynton House
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MICHAEL AUKETT ARCHITECTS LTD. ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PIPEWALL LIMITED19 déc. 199419 déc. 1994

    Quels sont les derniers comptes de MICHAEL AUKETT ARCHITECTS LTD. ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour MICHAEL AUKETT ARCHITECTS LTD. ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    19 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 07 déc. 2017

    12 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 07 déc. 2016

    20 pages4.68

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de Atlantic Court 77 Kings Road London SW3 4NX à Lynton House 7-12 Tavistock Square London WC1H 9LT le 22 déc. 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    7 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 08 déc. 2015

    LRESEX

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrea Tropia en tant que directeur le 19 juin 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 janv. 2015

    État du capital au 29 janv. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de Donald Patrick O Reilly en tant que directeur le 19 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 janv. 2014

    État du capital au 06 janv. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2012

    6 pagesAA

    État du capital au 23 juil. 2013

    • Capital: GBP 100.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Marienne Pachonick en tant que directeur le 12 avr. 2013

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    11 pagesAR01

    État du capital au 10 déc. 2012

    • Capital: GBP 200,100.00
    4 pagesSH19

    Qui sont les dirigeants de MICHAEL AUKETT ARCHITECTS LTD. ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROSS, Lewis Ian
    64 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    Secrétaire
    64 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    British8006590004
    BAKER, Stephen John
    78 Pound Road
    TN12 5BJ East Peckham
    Kent
    Administrateur
    78 Pound Road
    TN12 5BJ East Peckham
    Kent
    United KingdomBritishArchitect112278540001
    BRYAN, Christopher
    Flat 200 Lear House
    Poynders Gardens
    SW4 8PG London
    Administrateur
    Flat 200 Lear House
    Poynders Gardens
    SW4 8PG London
    United KingdomBritishArchitect125773520001
    BUNTING, Mathew James
    32 Lesbourne Road
    RH2 7LD Reigate
    Surrey
    Administrateur
    32 Lesbourne Road
    RH2 7LD Reigate
    Surrey
    EnglandBritishArchitect95932220001
    ROSS, Lewis Ian
    64 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    Administrateur
    64 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    United KingdomBritishChartered Accountant8006590004
    AUKETT, Allison
    61 Drayton Gardens
    SW10 9RT London
    Secrétaire
    61 Drayton Gardens
    SW10 9RT London
    British120388850001
    BETT, Allison
    31 Redcliffe Road
    SW10 9NP London
    Secrétaire
    31 Redcliffe Road
    SW10 9NP London
    BritishCompany Secretary54939370001
    WHITAKER, Robert John
    48 Clonmore Street
    SW18 5EY London
    Secrétaire
    48 Clonmore Street
    SW18 5EY London
    BritishAccountant64492350002
    BBR SECRETARIES LIMITED
    42 Bedford Row
    WC1R 4JL London
    Secrétaire
    42 Bedford Row
    WC1R 4JL London
    82200000001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ANDREWS, Stephen Marriott
    The Cider House Ridgley Road
    GU8 4QQ Chiddingfold
    Surrey
    Administrateur
    The Cider House Ridgley Road
    GU8 4QQ Chiddingfold
    Surrey
    BritishArchitect58099810001
    AUKETT, Michael Claude
    61 Drayton Gardens
    SW10 9RT London
    Administrateur
    61 Drayton Gardens
    SW10 9RT London
    EnglandBritishArchitect49553450008
    BROCKLISS, John William
    5 Court Downs Road
    BR3 6LL Beckenham
    Kent
    Administrateur
    5 Court Downs Road
    BR3 6LL Beckenham
    Kent
    EnglandBritishDesigner65495750002
    BROOKE, Lynne
    122 Lauderdale Tower
    Barbican
    EC2Y 8BY London
    Administrateur
    122 Lauderdale Tower
    Barbican
    EC2Y 8BY London
    BritishSolicitor9124650001
    FRENCH, Jonathan Domanic
    The Old Post Office
    GL56 0YN Adlestrop
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Old Post Office
    GL56 0YN Adlestrop
    Gloucestershire
    BritishArchitect81971110001
    LETTINGTON, John
    19 Landgrove Road
    SW19 7LL London
    Administrateur
    19 Landgrove Road
    SW19 7LL London
    EnglandBritishIt Director70059140002
    MILLER, Paul
    5 George Road
    GU13 9PS Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    5 George Road
    GU13 9PS Fleet
    Hampshire
    BritishArchitect67586570001
    O REILLY, Donald Patrick
    26 Valmar Road
    SE5 9NG London
    Administrateur
    26 Valmar Road
    SE5 9NG London
    EnglandIrishArchitect70059780001
    PACHONICK, Marienne
    131 Newlands Park
    SE26 5PP London
    First Floor Flat
    United Kingdom
    Administrateur
    131 Newlands Park
    SE26 5PP London
    First Floor Flat
    United Kingdom
    EnglandBritishArchitect125773620002
    RODEN, David
    25 Broughton Road
    SW6 2LE London
    Administrateur
    25 Broughton Road
    SW6 2LE London
    BritishArchitect90896700001
    SARFATY, Jonathan
    Flat 4
    10 Strathray Gardens
    NW3 4NY London
    Administrateur
    Flat 4
    10 Strathray Gardens
    NW3 4NY London
    AustralianArchitect110156190001
    SIMMS, Kenneth John
    213 Highbury Quadrant
    N5 2TE London
    Administrateur
    213 Highbury Quadrant
    N5 2TE London
    EnglandBritishArchitect26284500001
    TROPIA, Andrea
    12 Fleur Gates
    Southfields
    SW19 6QQ London
    Administrateur
    12 Fleur Gates
    Southfields
    SW19 6QQ London
    EnglandBritishArchitect125773390001
    TSOUTSOS, George
    139b Upper Street
    Islington
    N1 1QP London
    Administrateur
    139b Upper Street
    Islington
    N1 1QP London
    GreekArchitect95932200001
    TYTHERLEIGH, Graham John
    67 Highgate West Hill
    N6 6BU London
    Administrateur
    67 Highgate West Hill
    N6 6BU London
    UkBritishDesign Consultant23198930001
    WHITAKER, Robert John
    48 Clonmore Street
    SW18 5EY London
    Administrateur
    48 Clonmore Street
    SW18 5EY London
    BritishAccountant64492350002
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    MICHAEL AUKETT ARCHITECTS LTD. a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 08 févr. 2006
    Livré le 14 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed providing for rental deposit
    Créé le 22 juin 2001
    Livré le 12 juil. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 24 april 1998
    Brèves mentions
    The sum of £14,000 together with a further sum of £19,000 payable by the tenant held in an interest bearing designated account with a clearing bank of the landlord's choosing having its head office in the city of london ("deposit account") and the deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Prudential Staff Pensions Limited
    Transactions
    • 12 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Charge over deposits
    Créé le 22 nov. 1999
    Livré le 25 nov. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A first fixed charge over any sums deposited or to be deposited by the company held with the bank at any of its branches.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 25 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 30 juil. 1999
    Livré le 20 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 20 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 25 mars 1996
    Livré le 27 mars 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 25 march 1996 and/or this charge
    Brèves mentions
    The deposit of £5,500 together with with all further additions and the designated account with barclays bank PLC or such othert clearing bank to which the deposit shall be credited from time to time.
    Personnes ayant droit
    • Atlantic Venture Investments Limited
    Transactions
    • 27 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 27 oct. 1995
    Livré le 28 oct. 1995
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement of even date and/or the rent deposit deed
    Brèves mentions
    The deposit of £5,500 together with all further additions and the designated account with barclays bank PLC. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Atlantic Venture Investments Limited
    Transactions
    • 28 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 20 mars 1995
    Livré le 21 mars 1995
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an agreement dated 20TH march 1995 and/or this deed
    Brèves mentions
    The deposit of £5,500 together with all further additions. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Atlantic Venture Investments Limited
    Transactions
    • 21 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)

    MICHAEL AUKETT ARCHITECTS LTD. a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 déc. 2015Commencement of winding up
    02 août 2018Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Rodney Newton
    Lynton House 7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    practitioner
    Lynton House 7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Simon James Underwood
    Lynton House 7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    practitioner
    Lynton House 7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0