GETTY COMMUNICATIONS LIMITED

GETTY COMMUNICATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGETTY COMMUNICATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03005770
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GETTY COMMUNICATIONS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe GETTY COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GETTY COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GETTY COMMUNICATIONS GROUP LIMITED22 août 199522 août 1995
    MERLVIEW LIMITED04 janv. 199504 janv. 1995

    Quels sont les derniers comptes de GETTY COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour GETTY COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de 101 Bayham Street London NW1 0AG à 15 Canada Square London E14 5GL le 20 oct. 2015

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Jonathan Simon Lockwood en tant que directeur le 28 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 28 sept. 2015

    LRESSP

    Cessation de la nomination de John Joseph Lapham en tant que directeur le 04 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Tim Murphy en tant que directeur le 05 juin 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 janv. 2015

    État du capital au 20 janv. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2013

    32 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    15 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    resolution

    Résolution de capitalisation ou d'émission d'actions gratuites

    Capatalise 109718000 23/07/2014
    RES14
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    legacy

    3 pagesSH20

    État du capital au 25 juil. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    3 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium reduced 23/07/2014
    RES13

    État du capital après une attribution d'actions au 23 juil. 2014

    • Capital: GBP 511,913.26
    3 pagesSH01

    État du capital après une attribution d'actions au 23 juil. 2014

    • Capital: GBP 511,912.26
    3 pagesSH01

    Nomination de Mr Tim Murphy en tant qu'administrateur le 31 mars 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Chris Hoel en tant qu'administrateur le 31 mars 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Shane Johnson en tant qu'administrateur le 31 mars 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jodi Anne Colligan en tant que directeur le 31 mars 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Constance G. Chapman en tant que secrétaire le 01 avr. 2014

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Beatrice Bailey en tant que secrétaire le 20 nov. 2013

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de GETTY COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHAPMAN, Constance G.
    S., Suite 400
    WA 98104 Seattle
    605 5th Ave.
    Usa
    Secrétaire
    S., Suite 400
    WA 98104 Seattle
    605 5th Ave.
    Usa
    187699320001
    HOEL, Chris
    Suite 400
    Seattle
    Wa 98104
    605 5th Ave.
    Usa
    Administrateur
    Suite 400
    Seattle
    Wa 98104
    605 5th Ave.
    Usa
    UsaUnited StatesVp, Chief Accounting Officer189119020001
    JOHNSON, Shane
    Suite 400
    Seattle
    605 5th Ave. S.,
    Wa 98104
    Usa
    Administrateur
    Suite 400
    Seattle
    605 5th Ave. S.,
    Wa 98104
    Usa
    United StatesAmericanVp, Tax190333070001
    BAILEY, Beatrice
    c/o Getty Images, Inc.
    5th Ave S
    98104 Seattle
    605
    Washington
    Usa
    Secrétaire
    c/o Getty Images, Inc.
    5th Ave S
    98104 Seattle
    605
    Washington
    Usa
    151658920001
    BEYLE, Jeffrey Lewis
    2720 91st Place Ne
    98004 Bellevue
    Washington
    Secrétaire
    2720 91st Place Ne
    98004 Bellevue
    Washington
    AmericanAttorney At Law135989770001
    GOODHIND, Geoffrey William David
    159 Marine Parade
    SS9 2RB Leigh On Sea
    Essex
    Secrétaire
    159 Marine Parade
    SS9 2RB Leigh On Sea
    Essex
    British8826440001
    GOULD, Lawrence
    50 Wildwood Road
    NW11 6UP London
    Secrétaire
    50 Wildwood Road
    NW11 6UP London
    BritishCompany Secretary17070280002
    LAPHAM, John Joseph
    c/o Getty Images, Inc.
    North 34th Street
    WA 98101 Seattle
    601
    Usa
    Secrétaire
    c/o Getty Images, Inc.
    North 34th Street
    WA 98101 Seattle
    601
    Usa
    AmericanLawyer174530250001
    MAKRIS, Philip George
    10 Meadowbank
    NW3 3AY London
    Secrétaire
    10 Meadowbank
    NW3 3AY London
    AmericanCompany Director75290830002
    QUIRK, Simon Phillip William
    Flat 2
    8 St Stephens Gardens
    W2 5QX London
    Secrétaire
    Flat 2
    8 St Stephens Gardens
    W2 5QX London
    AustralianLawyer99471090001
    WARD, John Paul Peter
    7 Richardson Mews
    Fitzoria
    W1P 5DF London
    Secrétaire
    7 Richardson Mews
    Fitzoria
    W1P 5DF London
    IrishJoint Secretary75146510002
    WILLIAMS, Glenn Bernard Douglas
    12 Lowry Close
    College Town
    GU47 0FJ Sandhurst
    Berkshire
    Secrétaire
    12 Lowry Close
    College Town
    GU47 0FJ Sandhurst
    Berkshire
    BritishFinance Director63412650001
    WOLFSON, Michael Barry
    4 Abbey View
    WD7 8LT Radlett
    Hertfordshire
    Secrétaire
    4 Abbey View
    WD7 8LT Radlett
    Hertfordshire
    BritishDirector119783620001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    ASAKA, Gary Michael
    6 Barrett Street
    W1U 1AZ London
    Administrateur
    6 Barrett Street
    W1U 1AZ London
    AmericanAccountant82073170001
    BAILEY, James Nathan
    12 Reservoir Street
    Cambridge
    Massachusetts 02138
    Usa
    Administrateur
    12 Reservoir Street
    Cambridge
    Massachusetts 02138
    Usa
    United StatesAmericanLawyer/Consultant46977670001
    BEYLE, Jeffrey Lewis
    2720 91st Place Ne
    98004 Bellevue
    Washington
    Administrateur
    2720 91st Place Ne
    98004 Bellevue
    Washington
    UsaAmericanAttorney At Law135989770001
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur désigné
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    COLLIGAN, Jodi Anne
    c/o Getty Images, Inc.
    5 Ave S
    98104 Seattle
    605
    Washington
    Usa
    Administrateur
    c/o Getty Images, Inc.
    5 Ave S
    98104 Seattle
    605
    Washington
    Usa
    UsaAmericanCpa147041000001
    CRISTALLO, Steven
    23014 Se 40th Pl
    Sammamish
    Wa 98075
    Usa
    Administrateur
    23014 Se 40th Pl
    Sammamish
    Wa 98075
    Usa
    AmericanAttorney96729730001
    DUNN, Jeffrey Joseph
    c/o Getty Images, Inc.
    North 34th Street
    WA 98103 Seattle
    601
    Usa
    Administrateur
    c/o Getty Images, Inc.
    North 34th Street
    WA 98103 Seattle
    601
    Usa
    UsaUnited StatesVp, Finance And Controller130086340002
    FERNANDEZ, Manuel
    PO BOX 283
    Rowayton Connecticut
    FOREIGN 06853 Usa
    Administrateur
    PO BOX 283
    Rowayton Connecticut
    FOREIGN 06853 Usa
    UsChairman/Ceo Gartner Group Inc58897500001
    GARB, Andrew
    16944 Dulce Ynez Lane
    90272 Pacific Palisades
    California
    Usa
    Administrateur
    16944 Dulce Ynez Lane
    90272 Pacific Palisades
    California
    Usa
    UsaLawyer48881730001
    GETTY, Mark Harris
    7 William Blake House
    The Lanterns Bridge Lane
    SW11 3AD London
    Administrateur
    7 William Blake House
    The Lanterns Bridge Lane
    SW11 3AD London
    IrishCompany Director34010890002
    GETTY, Mark Harris
    7 William Blake House
    The Lanterns Bridge Lane
    SW11 3AD London
    Administrateur
    7 William Blake House
    The Lanterns Bridge Lane
    SW11 3AD London
    IrishCompany Director34010890002
    GOULD, Lawrence
    50 Wildwood Road
    NW11 6UP London
    Administrateur
    50 Wildwood Road
    NW11 6UP London
    United KingdomBritishFinance Director17070280002
    GREEN, Michael Philip
    25 Knightsbridge
    SW1X 9RZ London
    Administrateur
    25 Knightsbridge
    SW1X 9RZ London
    BritishDirector37355670003
    GREGOIRE, Brent
    c/o Getty Images, Inc.
    5th Ave S
    98104 Seattle
    605
    Washington
    Usa
    Administrateur
    c/o Getty Images, Inc.
    5th Ave S
    98104 Seattle
    605
    Washington
    Usa
    UsaAmericanSvp Tax162305630001
    HAMMI, Karima
    Bayham Street
    NW1 0AG London
    101
    United Kingdom
    Administrateur
    Bayham Street
    NW1 0AG London
    101
    United Kingdom
    EnglandFrenchLawyer119582770001
    KIM, Haeran
    c/o Getty Images, Inc
    North 34th Street
    WA 98103 Seattle
    601
    Usa
    Administrateur
    c/o Getty Images, Inc
    North 34th Street
    WA 98103 Seattle
    601
    Usa
    UsaSouth KoreanTax Director151620780001
    KLEIN, Jonathan David
    3815 East John Street
    Seattle
    Washington 98112
    Usa
    Administrateur
    3815 East John Street
    Seattle
    Washington 98112
    Usa
    BritishCompany Director9675160006
    LAPHAM, John Joseph
    c/o Getty Images, Inc.
    5th Ave S
    98104 Seattle
    605
    Washington
    Usa
    Administrateur
    c/o Getty Images, Inc.
    5th Ave S
    98104 Seattle
    605
    Washington
    Usa
    UsaAmericanLawyer174530250001
    LINTON, Nigel Robert
    69 Summerlee Avenue
    N2 9QJ London
    Administrateur
    69 Summerlee Avenue
    N2 9QJ London
    EnglandBritishAccountant96730530001
    LOCKWOOD, Jonathan Simon
    Bayham Street
    NW1 0AG London
    101
    United Kingdom
    Administrateur
    Bayham Street
    NW1 0AG London
    101
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor106676380005
    LOWRY, Bruce
    c/o Getty Images, Inc.
    North 34th Street
    WA 98103 Seattle
    601
    Usa
    Administrateur
    c/o Getty Images, Inc.
    North 34th Street
    WA 98103 Seattle
    601
    Usa
    UsaAmericanAttorney146410800001

    GETTY COMMUNICATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over trade marks
    Créé le 19 juil. 2002
    Livré le 02 août 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from getty images, inc., (The borrower) or any of its subsidiaries to the chargee and/or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights titles and interests charged, assigned and licensed or to be charged, assigned and licensed under the security, including the registered rights, the unregistered rights, the copyrights, the licences-out, the licenses-in (as defined) and all other rights, titles and interests of whatever nature set out, the registered trade marks and the trade marks in respect of which an application for registration has been filed, as listed in the table attached to the form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of America, N.A. (As Agent and Security Trustee, for and on Behalf of the Beneficiaries).
    Transactions
    • 02 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Equitable mortgage over shares
    Créé le 19 juil. 2002
    Livré le 02 août 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from getty images, inc., (The borrower) or any of its subsidiaries to the chargee and/or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the company's shares in all stocks shares or other securities, rights, dividends, interest, income, benefits and advantages whatsoever, at any time accruing, offered or arising in respect of or incidental to any of the securities and all stocks, shares, rights, money or property accruing or offered at any time by way of conversion, redempton, bonus, preference, exchange, purchase, substitution, option, interest or otherwise in respect thereof, as defined therein. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of America, N.A. (As Agent and Security Trustee, for and on Behalf of the Beneficiaries).
    Transactions
    • 02 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Pledge agreement
    Créé le 29 oct. 1999
    Livré le 05 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligation and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) or any of them under each of the finance documents (as defined) and on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All right title and interest the pledgor now has or hereafter aquires in the shares of capital stock. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transactions
    • 05 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 oct. 1999
    Livré le 29 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from each obligor (as defined) to the secured lenders (as defined) under each or any of the finance documents (as defined) or any other document
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC,as Agent and Trustee for Itself and Each of the Secured Lenders
    Transactions
    • 29 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 févr. 1998
    Livré le 23 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities (together the secured liabilities)
    Brèves mentions
    L/H property k/a 21 to 31 (odd) woodfield place london t/no ngl 638677. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders (The Securityagent)
    Transactions
    • 23 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security interest in trademarks between the company and the agent as a supplement and ancillary to and not in limitation of the security interest granted to the agent under the debenture with respect to the intellectual property rights
    Créé le 09 févr. 1998
    Livré le 23 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The full and timely payment observance and performance of the obligations pursuant to the finance documents
    Brèves mentions
    All right title and interest in the trademarks (including without limitation those items in schedule a to this companies form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC as Security Agent Under the Debenture (The Agent)
    Transactions
    • 23 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 14 mars 1995
    Livré le 22 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    GETTY COMMUNICATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 nov. 2016Dissolved on
    28 sept. 2015Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Allan Watson Graham
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0