CADBURY RUSSIA LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCADBURY RUSSIA LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03006768
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CADBURY RUSSIA LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CADBURY RUSSIA LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Begbies Traynor (Central) Llp, Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CADBURY RUSSIA LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MONDELEZ INTERNATIONAL SERVICES LIMITED13 mai 201513 mai 2015
    CADBURY RUSSIA LIMITED03 mai 199503 mai 1995
    HACKREMCO (NO.1004) LIMITED06 janv. 199506 janv. 1995

    Quels sont les derniers comptes de CADBURY RUSSIA LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour CADBURY RUSSIA LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    14 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 juil. 2023

    14 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Cadbury House Sanderson Road Uxbridge Middlesex UB8 1DH à Begbies Traynor (Central) Llp, Town Wall House Balkerne Hill Colchester Essex CO3 3AD le 03 août 2022

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    7 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 21 juil. 2022

    LRESEX
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 21 juil. 2022

    LRESSP

    Nomination de Mr Thomas James Gingell en tant qu'administrateur le 21 avr. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Michael Hladusz en tant que directeur le 30 mars 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Thomas James Gingell en tant que directeur le 26 janv. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Hannah Jane O'brien en tant qu'administrateur le 26 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    20 pagesAA

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    État du capital après une attribution d'actions au 10 déc. 2020

    • Capital: GBP 164
    • Capital: USD 2,001
    3 pagesSH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    19 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    18 pagesAA

    Nomination de Mr Thomas James Gingell en tant qu'administrateur le 01 oct. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Carole Noelle Keene en tant que directeur le 30 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de CADBURY RUSSIA LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CADBURY NOMINEES LIMITED
    Sanderson Road
    UB8 1DH Uxbridge
    Cadbury House
    Middlesex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Sanderson Road
    UB8 1DH Uxbridge
    Cadbury House
    Middlesex
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement773839
    132455680001
    ARRIGHI, Adrian John Paul
    Sanderson Road
    UB8 1DH Uxbridge
    Cadbury House
    Middlesex
    Administrateur
    Sanderson Road
    UB8 1DH Uxbridge
    Cadbury House
    Middlesex
    United KingdomBritishTax Director253688100001
    FOYE, Michael Brendan
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Begbies Traynor (Central) Llp, Town Wall House
    Essex
    Administrateur
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Begbies Traynor (Central) Llp, Town Wall House
    Essex
    United KingdomBritishTreasury Director176300530002
    GINGELL, Thomas James
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Begbies Traynor (Central) Llp, Town Wall House
    Essex
    Administrateur
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Begbies Traynor (Central) Llp, Town Wall House
    Essex
    EnglandBritishFinance Director223999870001
    O'BRIEN, Hannah Jane
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Begbies Traynor (Central) Llp, Town Wall House
    Essex
    Administrateur
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Begbies Traynor (Central) Llp, Town Wall House
    Essex
    EnglandBritishDirector, Aer291415740001
    FOSTER, David Charles
    22 Lansdowne Avenue
    Codsall
    WV8 2EN Wolverhampton
    West Midlands
    Secrétaire
    22 Lansdowne Avenue
    Codsall
    WV8 2EN Wolverhampton
    West Midlands
    British28652700002
    HUDSPITH, John Edward
    59 Girdwood Road
    Southfields
    SW18 5QR London
    Secrétaire
    59 Girdwood Road
    Southfields
    SW18 5QR London
    British97602130001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Secrétaire désigné
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    BALDRY, Simon Christopher
    9 Blackett Street
    SW15 7QG London
    Poland
    Administrateur
    9 Blackett Street
    SW15 7QG London
    Poland
    BritishManaging Director46315440003
    BLAKEMORE, Dominic William
    Winterbrook Road
    SE24 9JA London
    40
    United Kingdom
    Administrateur
    Winterbrook Road
    SE24 9JA London
    40
    United Kingdom
    United KingdomEnglishChartered Accountant & Group F131131880001
    BYRNE, Donal Anthony
    4 Auburn Grove
    IRISH Malahide
    County Dublin Eire
    Administrateur
    4 Auburn Grove
    IRISH Malahide
    County Dublin Eire
    IrishCompany Director28464470001
    CAYWOOD, Pauline
    21 Duke Shore Wharf
    Narrow Street
    E14 8BU London
    Administrateur
    21 Duke Shore Wharf
    Narrow Street
    E14 8BU London
    United KingdomBritishChartered Accountant122695290001
    CUTLER, Linda Anne
    Sanderson Road
    UB8 1DH Uxbridge
    Cadbury House
    Middlesex
    Administrateur
    Sanderson Road
    UB8 1DH Uxbridge
    Cadbury House
    Middlesex
    EnglandBritishHead Of Tax Strategy153038370002
    ELLIOTT, Robert John
    4 Ashdale Park
    Finchampstead
    RG40 3QS Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    4 Ashdale Park
    Finchampstead
    RG40 3QS Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director65738510001
    FOSTER, David Charles
    22 Lansdowne Avenue
    Codsall
    WV8 2EN Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    22 Lansdowne Avenue
    Codsall
    WV8 2EN Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritishSolicitor28652700002
    FULTON, John Graham
    57 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7AL London
    Administrateur
    57 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7AL London
    BritishGroup Treasury Director106783900002
    GINGELL, Thomas James
    Sanderson Road
    UB8 1DH Uxbridge
    Cadbury House
    Middlesex
    Administrateur
    Sanderson Road
    UB8 1DH Uxbridge
    Cadbury House
    Middlesex
    EnglandBritishAccountant223999870001
    HLADUSZ, John Michael
    Sanderson Road
    UB8 1DH Uxbridge
    Cadbury House
    Middlesex
    Administrateur
    Sanderson Road
    UB8 1DH Uxbridge
    Cadbury House
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Accountant229194010001
    JACK, Thomas Edward
    Sanderson Road
    UB8 1DH Uxbridge
    Cadbury House
    Middlesex
    Administrateur
    Sanderson Road
    UB8 1DH Uxbridge
    Cadbury House
    Middlesex
    EnglandBritishAccountant74344230022
    JENNINGS, Clare Louisa Minnie, Mrs.
    Sanderson Road
    UB8 1DH Uxbridge
    Cadbury House
    Middlesex
    Administrateur
    Sanderson Road
    UB8 1DH Uxbridge
    Cadbury House
    Middlesex
    EnglandBritishAccountant284041550001
    JOHNSTON, Ian David
    4/13 Palace Gate
    W8 5LS London
    Administrateur
    4/13 Palace Gate
    W8 5LS London
    AustralianMd Confectionary Str37959920004
    KEENE, Carole Noelle
    Sanderson Road
    UB8 1DH Uxbridge
    Cadbury House
    Middlesex
    Administrateur
    Sanderson Road
    UB8 1DH Uxbridge
    Cadbury House
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director167481960001
    KLEYN, Ysbrand Jan
    Beechwood House Parsonage Lane
    Farnham Common
    SL2 3PA Slough
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Beechwood House Parsonage Lane
    Farnham Common
    SL2 3PA Slough
    Buckinghamshire
    DutchProject Director43229030001
    KNAUER, Peter
    D-15345 Proetzel
    Siedlungsweg 11b
    Germany
    Administrateur
    D-15345 Proetzel
    Siedlungsweg 11b
    Germany
    GermanManaging Director56291570001
    LAWFORD, Paula Anne
    Rosinka 1522
    Angelovo Krasnogorski Rayon
    Moskovskaya Oblast
    Russia
    Administrateur
    Rosinka 1522
    Angelovo Krasnogorski Rayon
    Moskovskaya Oblast
    Russia
    BritishAccountant48557750001
    LAWTON, John Stanford
    Waygen House
    Wawensmere Road Wooten Wawen
    B95 6BW Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Waygen House
    Wawensmere Road Wooten Wawen
    B95 6BW Solihull
    West Midlands
    BritishGroup Technical Director31123640001
    MAGOL, Cowsi
    5 Chevely Close
    Coopersale
    CM16 7RL Epping
    Essex
    Administrateur
    5 Chevely Close
    Coopersale
    CM16 7RL Epping
    Essex
    BritishCertified Accountant87113370001
    MARSHALL, James Daniel
    Devonshire Road
    Chiswick
    W4 2HS London
    98
    United Kingdom
    Administrateur
    Devonshire Road
    Chiswick
    W4 2HS London
    98
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant122693820004
    MILLS, John Michael
    103 Moffats Lane
    AL9 7RP Brookmans Park
    Hertfordshire
    Administrateur
    103 Moffats Lane
    AL9 7RP Brookmans Park
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Secretary193353200001
    MOORE, Robert
    83 St Saviours
    8 Shad Thames
    SE1 2YP London
    England
    Administrateur
    83 St Saviours
    8 Shad Thames
    SE1 2YP London
    England
    BritishAccountant101947250001
    ORCHARD, Christopher William
    3 Manor Way
    HP5 3BG Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    3 Manor Way
    HP5 3BG Chesham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector Of Business Risk Mana93326450002
    OWEN, Timothy David
    East End House
    Moss Lane
    HA5 3AW Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    East End House
    Moss Lane
    HA5 3AW Pinner
    Middlesex
    EnglandBritishCorporate Treasurer16209650002
    SLATER, Gordon Trevor
    2a Oxford & Cambridge Mansions
    Old Marylebone Road
    NW1 5EB London
    Administrateur
    2a Oxford & Cambridge Mansions
    Old Marylebone Road
    NW1 5EB London
    United KingdomBritishCertified Accountant16209660001
    STRACHOTA, Steven Charles
    Pokrovsky Hills, Beregovaya Street
    3, Bldg 12, Unit 1203
    Moscow
    123367
    Russian Federation
    Administrateur
    Pokrovsky Hills, Beregovaya Street
    3, Bldg 12, Unit 1203
    Moscow
    123367
    Russian Federation
    AmericanFinance Director103992310001
    SUNDERLAND, John Michael, Sir
    Woodlands
    Penn Street
    HP7 0PX Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Woodlands
    Penn Street
    HP7 0PX Amersham
    Buckinghamshire
    BritishMd Confectionary Stream56576560001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CADBURY RUSSIA LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Brentwick Limited
    Sanderson Road
    UB8 1DH Uxbridge
    Cadbury House
    England
    06 avr. 2016
    Sanderson Road
    UB8 1DH Uxbridge
    Cadbury House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CADBURY RUSSIA LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Contract of pledge of shares in joint stock company
    Créé le 27 mars 1997
    Livré le 15 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    (A) the payment or other obligations which cadbury zao is obliged to fulfil under the loan agreement (as defined) and other finance documents (as defined) related to the loan agreement as acknowledged by the company in section 2 of this pledge (as defined); and (b) the obligations of the company to european bank for reconstruction and development, including its successors and permitted assigns and persons deriving title through or under the bank under this pledge and/or any other finance documents to which the company is a party
    Brèves mentions
    The pledgor pledges the pledged shares meaning all of the shares of cadbury zao and cadbury confectionery zao listed and described in annex 1 to this pledge, all and any of the rights or property under or in relation to the shares listed and described in annex 1 and all other shares of cadbury zao and cadbury confectionery zao issued or which are to be issued by said companies and which the pledgor will acquire or has the right to aquire the ownership. Any dividends or distributions which may at any time become payable (whether in cash or otherwise) and any and all amounts due from cadbury zao to any of the related companies or any of the shareholder companies on any account whatsoever.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • European Bank for Reconstruction and Development, Including Its Successors and Permittedassigns and Persons Deriving Title Through or Under the Bank
    Transactions
    • 15 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Pledge of shares
    Créé le 26 févr. 1997
    Livré le 05 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The "secured obligations" of cadbury zao to the chargee under the loan agreement (as defined), and the obligations of the company (the "pledgor") under the subordination agreement (as defined) and this pledge
    Brèves mentions
    A first ranking right of pledge under the laws of the netherlands over the shares (and any and all dividends, distributions of share premium or any other distribution of cash relating to the shares). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • European Bank for Reconstruction and Development,Including Its Successors and Permitted Assigns and Persons Deriving Title Through or Under the Bank
    Transactions
    • 05 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Subordination agreement
    Créé le 28 nov. 1996
    Livré le 16 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All payments or other distributions of any kind or character received directly or indirectly by the company and all or any of the other conpanies named therein from any ringfence company (as defined) in respect of any part of the sponsor indebtedness (as defined) other than permitted payments due or to become due from the companies to the bank
    Brèves mentions
    Any payment or other distribution of any kind or character received from any ringfence company in respect of the sponsor indebtedness shall be received in trust for the bank until the bank indebtedness has been paid in full.
    Personnes ayant droit
    • European Bank for Reconstruction and Development
    Transactions
    • 16 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 28 nov. 1996
    Livré le 16 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due,owing or payable to the chargee (i)by the company and all or any of the other companies named therein under the subordination agreement (as defined) and (ii) by cadbury zao under the loan agreement (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • European Bank for Reconstruction and Development
    Transactions
    • 16 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)

    CADBURY RUSSIA LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 févr. 2024Due to be dissolved on
    21 juil. 2022Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Lee De'Ath
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    practitioner
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Richard Howard Toone
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    practitioner
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0