BF REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBF REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03007384
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BF REALISATIONS LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe BF REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hallam Fields Road
    Ilkeston
    DE7 4AZ Derbyshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BF REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BEAUVALE FURNISHINGS LIMITED26 mai 199526 mai 1995
    SHOWHIDE LIMITED09 janv. 199509 janv. 1995

    Quels sont les derniers comptes de BF REALISATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2000

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BF REALISATIONS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BF REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Restauration par ordonnance du tribunal

    4 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 31 août 2011

    3 pages3.6

    legacy

    2 pagesLQ02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 12 mai 2011

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 12 mai 2010

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 12 mai 2009

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 12 mai 2008

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    3 pages3.6

    legacy

    1 pages405(2)

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    3 pages3.6

    legacy

    1 pages405(2)

    legacy

    1 pages405(1)

    Divers

    Form 3.2 - statement of affairs
    4 pagesMISC

    Rapport du séquestre administratif

    9 pages3.10

    Certificat de changement de nom

    Company name changed beauvale furnishings LIMITED\certificate issued on 07/08/02
    2 pagesCERTNM

    legacy

    1 pages405(1)

    legacy

    7 pages363s
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    annual-return18 janv. 2002

    legacy

    363(287)

    legacy

    5 pages395

    Qui sont les dirigeants de BF REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STONE, Robert Eric
    Cheveral
    Main Street
    NG14 7GH Bleasby
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Cheveral
    Main Street
    NG14 7GH Bleasby
    Nottinghamshire
    British28071870002
    BRANDT, Michael Roger
    2 Dovedale Road
    West Bridgford
    NG2 6JA Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    2 Dovedale Road
    West Bridgford
    NG2 6JA Nottingham
    Nottinghamshire
    British14407540001
    CARTER, Sandra Pauline
    34 Nursery Hollow
    DE7 4LQ Ilkeston
    Derbyshire
    Administrateur
    34 Nursery Hollow
    DE7 4LQ Ilkeston
    Derbyshire
    British75845440001
    STONE, Robert Eric
    Cheveral
    Main Street
    NG14 7GH Bleasby
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Cheveral
    Main Street
    NG14 7GH Bleasby
    Nottinghamshire
    British28071870002
    GASTER, David
    Camden House
    218 Tonbridge Road
    ME18 5NX Wateringbury
    Kent
    Secrétaire
    Camden House
    218 Tonbridge Road
    ME18 5NX Wateringbury
    Kent
    British80205980001
    KEELY, Terence
    Fountain Dale House
    Fountain Dale Ricket Lane
    NG21 0ND Blidworth
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Fountain Dale House
    Fountain Dale Ricket Lane
    NG21 0ND Blidworth
    Nottinghamshire
    British14916610005
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    GASTER, David
    Camden House
    218 Tonbridge Road
    ME18 5NX Wateringbury
    Kent
    Administrateur
    Camden House
    218 Tonbridge Road
    ME18 5NX Wateringbury
    Kent
    British80205980001
    KEELY, Terence
    Fountain Dale House
    Fountain Dale Ricket Lane
    NG21 0ND Blidworth
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Fountain Dale House
    Fountain Dale Ricket Lane
    NG21 0ND Blidworth
    Nottinghamshire
    EnglandBritish14916610005
    MILLERSHIP, Paul Anthony
    4 Adams Court
    DE7 8YF Ilkeston
    Derbyshire
    Administrateur
    4 Adams Court
    DE7 8YF Ilkeston
    Derbyshire
    British14916600001
    SUTTON, Peter Arthur
    Ians Oak
    Yeldersley
    DE6 1LS Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    Ians Oak
    Yeldersley
    DE6 1LS Ashbourne
    Derbyshire
    British79597860001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    BF REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of rectification of a debenture of 17 july 1998 and
    Créé le 22 août 2001
    Livré le 30 août 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursaunt to a guarantee dated 17 july 1998
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Paul Anthony Millership
    Transactions
    • 30 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 17 juil. 1998
    Livré le 29 juil. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreement
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Paul Anthony Millership
    Transactions
    • 29 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 17 juil. 1998
    Livré le 28 juil. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the loan agreement of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank Investments Limited
    Transactions
    • 28 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 23 avr. 1998
    Livré le 01 mai 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the agent, the overdraft bank, the banks and the swap counterparties (as each term is defined in facilities agreement) and as agent pursuant to the facilities agreement) under the terms of the facilities agreement dated 23RD april 1998
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital plant and machinery. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 2002Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
    • 28 juin 2003Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (405 (2))
    • 28 juin 2003Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
    • 19 juil. 2005Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (405 (2))
    • 113 sept. 2011Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
      • Numéro de dossier 1
    Legal charge
    Créé le 23 avr. 1998
    Livré le 01 mai 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the agent, the overdraft bank, the banks and the swap counterparties (as each term is defined in facilities agreement) and as agent pursuant to the facilities agreement) under the terms of the facilities agreement dated 23RD april 1998
    Brèves mentions
    L/H land and buildings on the north east side of hallam fields road ilkeston derbyshire, factory premises and 2.5 acres of land at manners avenue ilkeston,. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 19 mai 1995
    Livré le 07 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company,previously known as showhide limited,to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold land/blds on the north east side of hallam fields rd,ilkeston,derbyshire..............goodwill of business and benefit of all licences.......................see form 395. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 06 mai 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 19 mai 1995
    Livré le 01 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as showhide limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mai 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 19 mai 1995
    Livré le 01 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as showhide limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/as 87 kingston avenue,ilkeston,derbyshire.t/nos.dy 179735 and dy 189518 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mai 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BF REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 avr. 1998Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Lynn Robert Bailey
    Plumtree Court
    London
    EC4A 4HT
    practitioner
    Plumtree Court
    London
    EC4A 4HT
    Stuart David Maddison
    Plumtree Court
    London
    EC4A 4HT
    practitioner
    Plumtree Court
    London
    EC4A 4HT
    Am Grove
    Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0