D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED

D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéD K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03008724
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED ?

    • Autres travaux de construction spécialisés n.d.a. (43999) / Construction

    Où se situe D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    6th Floor 33 Holborn
    EC1N 2HT London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BERIA LIMITED11 janv. 199511 janv. 1995

    Quels sont les derniers comptes de D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Woodall le 30 juil. 2018

    2 pagesCH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2015

    2 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 5 Godalming Business Centre Woolsack Way Godalming Surrey GU7 1XW à 6th Floor 33 Holborn London EC1N 2HT le 31 mai 2016

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 janv. 2016

    État du capital au 18 janv. 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2014

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 janv. 2015

    État du capital au 12 janv. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 janv. 2014

    État du capital au 13 janv. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    2 pagesAA

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 déc. 2013 au 30 sept. 2013

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Asset Management Solutions Limited en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Beif Ii Corporate Services Limited en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert Mcclatchey en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ernest Battey en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Livingston en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de International Administration Group (Guernsey) Limited en tant que secrétaire

    3 pagesAP04

    Nomination de Iag Limited en tant qu'administrateur

    3 pagesAP02

    Qui sont les dirigeants de D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    INTERNATIONAL ADMINISTRATION GROUP (GUERNSEY) LIMITED
    Glategny Esplanade
    GY1 1WW St Peter Port
    Regency Court
    Guernsey
    Guernsey
    Secrétaire
    Glategny Esplanade
    GY1 1WW St Peter Port
    Regency Court
    Guernsey
    Guernsey
    Forme juridiqueLIMITED COMPANY
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleGUERNSEY
    Numéro d'enregistrement36305
    123212890003
    WOODALL, Mark Andrew
    Glategny Esplanade
    GY1 1WW St Peter Port
    Regency Court
    Guernsey
    Guernsey
    Administrateur
    Glategny Esplanade
    GY1 1WW St Peter Port
    Regency Court
    Guernsey
    Guernsey
    GuernseyBritish179218860001
    IAG LIMITED
    Glategny Esplanade
    GY1 1WW St Peter Port
    Regency Court
    Guernsey
    Guernsey
    Administrateur
    Glategny Esplanade
    GY1 1WW St Peter Port
    Regency Court
    Guernsey
    Guernsey
    Forme juridiqueLIMITED COMPANY
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleGUERNSEY
    Numéro d'enregistrement45079
    171273930001
    FAY, Martin Lawrence
    Crofton Cliff Crofton Avenue
    PO13 9NJ Lee On The Solent
    Hampshire
    Secrétaire
    Crofton Cliff Crofton Avenue
    PO13 9NJ Lee On The Solent
    Hampshire
    British8066790001
    JOHNSTON, William Raymond
    9 Beverley Court
    59 Fairfax Road
    NW6 4EG London
    Secrétaire
    9 Beverley Court
    59 Fairfax Road
    NW6 4EG London
    British37227240001
    NETTLESHIP, Isobel Mary
    Kent House
    14 - 17 Market Place
    W1W 8AJ London
    Secrétaire
    Kent House
    14 - 17 Market Place
    W1W 8AJ London
    British147086990001
    SHERIDAN, Clare
    Kent House
    14 - 17 Market Place
    W1W 8AJ London
    Secrétaire
    Kent House
    14 - 17 Market Place
    W1W 8AJ London
    British74216410002
    ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED
    Charles Street
    CF10 2GE Cardiff
    46
    United Kingdom
    Secrétaire
    Charles Street
    CF10 2GE Cardiff
    46
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement03008724
    166036180001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BATTEY, Ernest Stephen
    Furnival Street
    EC4A 1AB London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Furnival Street
    EC4A 1AB London
    10
    United Kingdom
    British28614660001
    BENNETT, Nigel Anthony
    7 Courtneidge Close
    LU7 0EL Stewkley
    Bedfordshire
    Administrateur
    7 Courtneidge Close
    LU7 0EL Stewkley
    Bedfordshire
    EnglandBritish74375610001
    BISHOP, John Michael
    Orchard View
    Tintells Lane
    KT24 6JD West Horsley
    Surrey
    Administrateur
    Orchard View
    Tintells Lane
    KT24 6JD West Horsley
    Surrey
    EnglandBritish116243840001
    BURGESS, Richard John
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    Administrateur
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)British35427700001
    DIXON, Richard John
    Furnival Street
    EC4A 1AB London
    10
    Administrateur
    Furnival Street
    EC4A 1AB London
    10
    United KingdomBritish130277830002
    EMINSON, Clive Franklin
    Garden Cottage Stratton Hall Lane
    Levington
    IP10 0LH Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    Garden Cottage Stratton Hall Lane
    Levington
    IP10 0LH Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish39767370001
    FAY, Linda Diane Isabel
    Crofton Cliff
    Crofton Avenue
    PO13 9NJ Lee On The Solent
    Hampshire
    Administrateur
    Crofton Cliff
    Crofton Avenue
    PO13 9NJ Lee On The Solent
    Hampshire
    British38454870001
    FAY, Martin Lawrence
    Crofton Cliff Crofton Avenue
    PO13 9NJ Lee On The Solent
    Hampshire
    Administrateur
    Crofton Cliff Crofton Avenue
    PO13 9NJ Lee On The Solent
    Hampshire
    British8066790001
    HARTSHORN, Timothy
    5 Freston Road
    N3 1UP London
    Administrateur
    5 Freston Road
    N3 1UP London
    British103668910001
    KEITH, Alistair
    Wildacre
    South Munstead Lane
    GU8 4AG Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Wildacre
    South Munstead Lane
    GU8 4AG Godalming
    Surrey
    British69099040002
    LIVINGSTON, Andrew James
    Furnival Street
    EC4A 1AB London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Furnival Street
    EC4A 1AB London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritish132011640001
    MCCLATCHEY, Robert Sean
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    United KingdomBritish140441450001
    STYLES, Robert James
    7 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    7 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish102666050001
    TASKER, Ian James
    26 Ravensbourne Avenue
    BR2 0BP Bromley
    Kent
    Administrateur
    26 Ravensbourne Avenue
    BR2 0BP Bromley
    Kent
    EnglandBritish84496470004
    BEIF II CORPORATE SERVICES LIMITED
    100 Wood Street
    EC2V 7EX London
    Fifth Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    100 Wood Street
    EC2V 7EX London
    Fifth Floor
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement07002591
    151210770001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Medicx Fund Limited
    Glategny Esplanade
    St. Peter Port
    GY1 1WW Guernsey
    Regency Court
    Channel Islands
    06 avr. 2016
    Glategny Esplanade
    St. Peter Port
    GY1 1WW Guernsey
    Regency Court
    Channel Islands
    Non
    Forme juridiqueCompany Limited By Shares
    Pays d'enregistrement45397
    Autorité légaleThe Companies (Guernsey) Law, 2008
    Lieu d'enregistrementGuernsey
    Numéro d'enregistrement45397
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of legal charge
    Créé le 25 janv. 2000
    Livré le 27 janv. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from primary medical property limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of primary medical property limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union PLC any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    Brèves mentions
    49 portsmouth rd woolston southampton, land and buildings on the south east side of beaulieu rd dibden purlieu southampton and briar cottage beaulieu rd dibden together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fitting thereon and all improvements and additions thereto and all easements rights and licences appurtenant thereto, all monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the deed, floating charge the whole of the property, assets, rights and revenues including the uncalled share capital (if any). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 27 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Assignment by way of charge
    Créé le 20 déc. 1999
    Livré le 30 déc. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from primary medical properties investments limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of primary medical properties investments limited on any account whatsoever and in any manner whatsoever to the general practice finance corporation limited under the provisions of the deed of legal charge dated 20TH december 1999
    Brèves mentions
    All rights titles and interests and whether present or future of the compny the occupational leases in respect of the property at 49 portsmouth road woolston southampton and at beaulieu road dibden purlieu southampton. All sums due by way of insurance rent. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 30 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of legal charge
    Créé le 20 déc. 1999
    Livré le 30 déc. 1999
    En cours
    Montant garanti
    £2,304,457.00 owed by primary medical investments limited together with interest thereon pursuant to the provisions of the legal charge and all monies laid out by the general practice finance corporation limited under any of the provisions of the legal charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a 49 portsmouth road woolston southampton together with fixtures and fittings and equipment and all f/h property at beaulieu road dibden purlieu southampton. Floating charge all undertakings property assets and rights present and future.
    Personnes ayant droit
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 30 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 24 sept. 1998
    Livré le 05 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    49 portsmouth road woolston southampton hampshire t/no;-HP469177.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0