D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03008724 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 6th Floor 33 Holborn EC1N 2HT London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Woodall le 30 juil. 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 janv. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 janv. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2015 | 2 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 5 Godalming Business Centre Woolsack Way Godalming Surrey GU7 1XW à 6th Floor 33 Holborn London EC1N 2HT le 31 mai 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2014 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 2 pages | AA | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 31 déc. 2013 au 30 sept. 2013 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Asset Management Solutions Limited en tant que secrétaire | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Beif Ii Corporate Services Limited en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Mcclatchey en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ernest Battey en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Livingston en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de International Administration Group (Guernsey) Limited en tant que secrétaire | 3 pages | AP04 | ||||||||||
Nomination de Iag Limited en tant qu'administrateur | 3 pages | AP02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL ADMINISTRATION GROUP (GUERNSEY) LIMITED | Secrétaire | Glategny Esplanade GY1 1WW St Peter Port Regency Court Guernsey Guernsey |
| 123212890003 | ||||||||||||||
| WOODALL, Mark Andrew | Administrateur | Glategny Esplanade GY1 1WW St Peter Port Regency Court Guernsey Guernsey | Guernsey | British | 179218860001 | |||||||||||||
| IAG LIMITED | Administrateur | Glategny Esplanade GY1 1WW St Peter Port Regency Court Guernsey Guernsey |
| 171273930001 | ||||||||||||||
| FAY, Martin Lawrence | Secrétaire | Crofton Cliff Crofton Avenue PO13 9NJ Lee On The Solent Hampshire | British | 8066790001 | ||||||||||||||
| JOHNSTON, William Raymond | Secrétaire | 9 Beverley Court 59 Fairfax Road NW6 4EG London | British | 37227240001 | ||||||||||||||
| NETTLESHIP, Isobel Mary | Secrétaire | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | British | 147086990001 | ||||||||||||||
| SHERIDAN, Clare | Secrétaire | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | British | 74216410002 | ||||||||||||||
| ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED | Secrétaire | Charles Street CF10 2GE Cardiff 46 United Kingdom |
| 166036180001 | ||||||||||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||||||||||
| BATTEY, Ernest Stephen | Administrateur | Furnival Street EC4A 1AB London 10 United Kingdom | British | 28614660001 | ||||||||||||||
| BENNETT, Nigel Anthony | Administrateur | 7 Courtneidge Close LU7 0EL Stewkley Bedfordshire | England | British | 74375610001 | |||||||||||||
| BISHOP, John Michael | Administrateur | Orchard View Tintells Lane KT24 6JD West Horsley Surrey | England | British | 116243840001 | |||||||||||||
| BURGESS, Richard John | Administrateur | 54 Manor Road SM2 7AG Cheam Surrey | United Kingdom ( England ) (Gb-Eng) | British | 35427700001 | |||||||||||||
| DIXON, Richard John | Administrateur | Furnival Street EC4A 1AB London 10 | United Kingdom | British | 130277830002 | |||||||||||||
| EMINSON, Clive Franklin | Administrateur | Garden Cottage Stratton Hall Lane Levington IP10 0LH Ipswich Suffolk | England | British | 39767370001 | |||||||||||||
| FAY, Linda Diane Isabel | Administrateur | Crofton Cliff Crofton Avenue PO13 9NJ Lee On The Solent Hampshire | British | 38454870001 | ||||||||||||||
| FAY, Martin Lawrence | Administrateur | Crofton Cliff Crofton Avenue PO13 9NJ Lee On The Solent Hampshire | British | 8066790001 | ||||||||||||||
| HARTSHORN, Timothy | Administrateur | 5 Freston Road N3 1UP London | British | 103668910001 | ||||||||||||||
| KEITH, Alistair | Administrateur | Wildacre South Munstead Lane GU8 4AG Godalming Surrey | British | 69099040002 | ||||||||||||||
| LIVINGSTON, Andrew James | Administrateur | Furnival Street EC4A 1AB London 10 United Kingdom | England | British | 132011640001 | |||||||||||||
| MCCLATCHEY, Robert Sean | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London Barclays Bank Plc | United Kingdom | British | 140441450001 | |||||||||||||
| STYLES, Robert James | Administrateur | 7 Churchill Place E14 5HP London | United Kingdom | British | 102666050001 | |||||||||||||
| TASKER, Ian James | Administrateur | 26 Ravensbourne Avenue BR2 0BP Bromley Kent | England | British | 84496470004 | |||||||||||||
| BEIF II CORPORATE SERVICES LIMITED | Administrateur | 100 Wood Street EC2V 7EX London Fifth Floor United Kingdom |
| 151210770001 | ||||||||||||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||||||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicx Fund Limited | 06 avr. 2016 | Glategny Esplanade St. Peter Port GY1 1WW Guernsey Regency Court Channel Islands | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of legal charge | Créé le 25 janv. 2000 Livré le 27 janv. 2000 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from primary medical property limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of primary medical property limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union PLC any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever | |
Brèves mentions 49 portsmouth rd woolston southampton, land and buildings on the south east side of beaulieu rd dibden purlieu southampton and briar cottage beaulieu rd dibden together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fitting thereon and all improvements and additions thereto and all easements rights and licences appurtenant thereto, all monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the deed, floating charge the whole of the property, assets, rights and revenues including the uncalled share capital (if any). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignment by way of charge | Créé le 20 déc. 1999 Livré le 30 déc. 1999 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from primary medical properties investments limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of primary medical properties investments limited on any account whatsoever and in any manner whatsoever to the general practice finance corporation limited under the provisions of the deed of legal charge dated 20TH december 1999 | |
Brèves mentions All rights titles and interests and whether present or future of the compny the occupational leases in respect of the property at 49 portsmouth road woolston southampton and at beaulieu road dibden purlieu southampton. All sums due by way of insurance rent. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of legal charge | Créé le 20 déc. 1999 Livré le 30 déc. 1999 | En cours | Montant garanti £2,304,457.00 owed by primary medical investments limited together with interest thereon pursuant to the provisions of the legal charge and all monies laid out by the general practice finance corporation limited under any of the provisions of the legal charge | |
Brèves mentions F/H property k/a 49 portsmouth road woolston southampton together with fixtures and fittings and equipment and all f/h property at beaulieu road dibden purlieu southampton. Floating charge all undertakings property assets and rights present and future. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 24 sept. 1998 Livré le 05 oct. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 49 portsmouth road woolston southampton hampshire t/no;-HP469177. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0