SPECIALITY CARE (REST HOMES) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SPECIALITY CARE (REST HOMES) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03010116 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SPECIALITY CARE (REST HOMES) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 2 Barton Close, Grove Park Enderby LE19 1SJ Leicester England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SPECIALITY CARE (REST HOMES) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 août 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 mai 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 août 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SPECIALITY CARE (REST HOMES) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 13 févr. 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 27 févr. 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 13 févr. 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour SPECIALITY CARE (REST HOMES) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2026 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 101-102 the Foundry Annex 65 Glasshill Street London SE1 0QR | 1 pages | AD03 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 août 2024 | 23 pages | AA | ||
legacy | 74 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 101-102 the Foundry Annex 65 Glasshill Street London SE1 0QR | 1 pages | AD03 | ||
Modification des détails de Speciality Care Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 sept. 2024 | 2 pages | PSC05 | ||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 101-102 the Foundry Annex 65 Glasshill Street London SE1 0QR | 1 pages | AD02 | ||
Changement d'adresse du siège social de , 2 Barton Close, Enderby, Leicester, LE19 1SJ, England à 2 Barton Close, Grove Park Enderby Leicester LE19 1SJ le 03 sept. 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Changement d'adresse du siège social de , the Forge Church Street West, Woking, Surrey, GU21 6HT, England à 2 Barton Close, Grove Park Enderby Leicester LE19 1SJ le 03 sept. 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Cessation de la nomination de Ryan David Jervis en tant que directeur le 17 juin 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mrs Samantha Rosemary Jane Booth en tant qu'administrateur le 17 juin 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Trevor Michael Torrington en tant que directeur le 17 juin 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 août 2023 | 25 pages | AA | ||
legacy | 76 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Nomination de Mr Charles Edward Coney en tant qu'administrateur le 21 févr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 02 févr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 août 2022 | 25 pages | AA | ||
legacy | 73 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Qui sont les dirigeants de SPECIALITY CARE (REST HOMES) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOTH, Samantha Rosemary Jane | Administrateur | Barton Close, Grove Park Enderby LE19 1SJ Leicester 2 England | England | British | 287875550001 | |||||
| CONEY, Charles Edward | Administrateur | Barton Close, Grove Park Enderby LE19 1SJ Leicester 2 England | England | British | 319663830001 | |||||
| BISHOP, Simon John | Secrétaire | Field Of Dreams Kingshill Leigh Sinton WR13 5EF Malvern Worcestershire | British | 58315790002 | ||||||
| CORMACK, Derek George | Secrétaire | Pillars Grantley Avenue, Wonersh GU5 0QN Guildford Surrey | Irish | 67400530015 | ||||||
| HALL, David James | Secrétaire | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor England | 159689330001 | |||||||
| MORRISON, Scott | Secrétaire | 24 Gaveston Road CV32 6EU Leamington Spa Warwickshire | British | 99297890001 | ||||||
| SCHOFIELD, Nigel Bennett | Secrétaire | Lechlade Gardens Castledean Park BH7 7JD Bournemouth 1 Dorset | British | 52338530002 | ||||||
| BLG (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED | Secrétaire | 7th Floor Beaufort House 15 St Botolph Street EC3A 7NJ London | 39680630001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ARTIS, Carol Mary | Administrateur | Hall Bank Clifford Hall L6A 3LW Burton In Lonsdale North Yorkshire | British | 54150740002 | ||||||
| BALL, Julian Charles | Administrateur | Mill Fleam Hilton DE65 5HE Derby 14 Derbyshire | England | British | 138044110001 | |||||
| BLACKOE, George Henry | Administrateur | 4 Ridgeway Nettleham LN2 2TL Lincoln Lincolnshire | United Kingdom | British | 3431630001 | |||||
| BLACKOE, George Henry | Administrateur | 4 Ridgeway Nettleham LN2 2TL Lincoln Lincolnshire | United Kingdom | British | 3431630001 | |||||
| CAMERON, Charles Donald Ewen | Administrateur | Orchard Manor Church Lane Martin Hussingtree WR3 8TQ Worcester Worcestershire | England | British | 113187140001 | |||||
| CAMERON, Christine Isabel | Administrateur | 10 Mount Crescent HR1 NQ1 Hereford | England | British | 163745150001 | |||||
| CAVANAGH, Peter Kenneth | Administrateur | 8 Fir Grove Paddington WA1 3JF Warrington | British | 114627410002 | ||||||
| CORMACK, Derek George | Administrateur | Pillars Grantley Avenue, Wonersh GU5 0QN Guildford Surrey | England | Irish | 67400530015 | |||||
| FRANZIDIS, Matthew | Administrateur | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor England | England | Uk | 129251300001 | |||||
| HALL, Karen | Administrateur | Far Cottage Penoyre LD3 9LP Brecon Powys | British | 95184230001 | ||||||
| HARTE, Derek Mark | Administrateur | 52 Gibson Square Islington N1 0RA London | British | 24654930001 | ||||||
| HILL, Margaret | Administrateur | 11 Pear Tree Close Hollingsworth S43 2LU Chesterfield Derbyshire | England | British | 102587360001 | |||||
| HUGHES, Sarah | Administrateur | Church Croft Madley HR2 9LT Hereford 29 United Kingdom | England | British | 131540480001 | |||||
| HUGHES, Sarah | Administrateur | Church Croft Madley H1ZZ 9LT Hereford 29 | England | British | 131540480001 | |||||
| HUNTER, David Morris | Administrateur | Hamilton House 1 Temple Avenue EC47 0HA London | British | 51501030001 | ||||||
| JERVIS, Ryan David | Administrateur | Church Street West GU21 6HT Woking The Forge Surrey England | United Kingdom | British | 265451030001 | |||||
| KEATING, Denise Elizabeth | Administrateur | 62 Church Street Cogenhoe NN7 1LS Northampton Northamptonshire | England | British | 111513540001 | |||||
| LOCK, Jason David | Administrateur | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor England | England | British | 144822040001 | |||||
| MANSON, David Lindsay | Administrateur | 111 Lodge Road Knowle B93 0HG Solihull West Midlands | England | British | 126071210001 | |||||
| MORAN, Mark | Administrateur | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor | United Kingdom | British | 60066000008 | |||||
| MYERS, Nigel | Administrateur | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor | England | British | 122921990001 | |||||
| NICHOLSON, Timothy Frantz | Administrateur | Hamilton House 1 Temple Avenue EC4Y 0HA London | American | 43829280002 | ||||||
| RIALL, Tom | Administrateur | 80 Hammersmith Road W14 8UD London Fifth Floor England | England | British | 177307320001 | |||||
| ROBINSON, Anthony Leake | Administrateur | Hamilton House 1 Temple Avenue EC4Y 0HA London | British | 48323880004 | ||||||
| SCOTT, Philip Henry | Administrateur | Exhibition House Addison Bridge Place W14 8XP London 21 United Kingdom | England | British | 174231320001 | |||||
| SMITH, Albert Edward | Administrateur | Flint House Froxfield SN8 3JY Marlborough Wiltshire | England | British | 77631340001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SPECIALITY CARE (REST HOMES) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speciality Care Limited | 06 avr. 2016 | Barton Close, Grove Park Enderby LE19 1SJ Leicester 2 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0