KNOWMASTER LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | KNOWMASTER LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03013147 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe KNOWMASTER LIMITED ?
Adresse du siège social | Tower Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Kent England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de KNOWMASTER LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour KNOWMASTER LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
État du capital au 18 déc. 2012
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Nomination de Mr David James Bruce en tant qu'administrateur le 08 août 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Graham Maxwell Barr en tant que directeur le 08 août 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Nomination de Mr Graham Maxwell Barr en tant qu'administrateur le 16 avr. 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Bryan Park en tant que directeur le 16 avr. 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Tower Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN United Kingdom le 21 févr. 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 2 County Gate Staceys Street Maidstone Kent ME14 1st le 07 oct. 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 14 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Bryan Park en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
legacy | 9 pages | MG01 | ||||||||||
Nomination de Mr Samuel Thomas Budgen Clark en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 19 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Roger Brown en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de KNOWMASTER LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARK, Samuel Thomas Budgen | Secrétaire | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | British | 117669700002 | ||||||
BRUCE, David James | Administrateur | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | United Kingdom | British | Director | 171398800001 | ||||
CLARK, Samuel Thomas Budgen | Administrateur | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | England | British | Director | 149939610001 | ||||
REA, Michael Peter | Administrateur | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | England | British | Director | 147194830001 | ||||
MCLEAN, Linda Ann | Secrétaire | Rose Cottage Prees Green SY13 2BN Whitchurch Shropshire | British | 95019110001 | ||||||
RICHARDSON, Norman | Secrétaire | The Moorings School Lane CH66 5PH Childer Thornton South Wirral | British | Solicitor | 34876810002 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BARR, Graham Maxwell | Administrateur | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | United Kingdom | British | Director | 125097020001 | ||||
BROWN, Roger Michael | Administrateur | Staceys Street ME14 1ST Maidstone 2 County Gate Kent | England | British | Director | 134140540001 | ||||
BUNTING, David John | Administrateur | 1 Dibbs Pocket Preston Old Road, Freckleton PR4 1JF Preston Lancashire | United Kingdom | British | Insurance Broker | 63563080002 | ||||
HAMEL, Karl | Administrateur | 47 Forest Road CH60 5SN Heswall Merseyside | United Kingdom | British | Insurance Broker | 111016270001 | ||||
HARRISON, Thomas Millward | Administrateur | 29 Orston Crescent Spital CH63 9NZ Wirral Merseyside | British | Insurance Broker | 94218200001 | |||||
JOHNSON, Timothy David | Administrateur | The Green Westerham TN16 1AS Kent Nursery Cottage 3a | England | British | Director | 129538180001 | ||||
PARK, Bryan | Administrateur | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | England | British | Director | 113694470002 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
KNOWMASTER LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 14 sept. 2010 Livré le 18 sept. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of accession to a debenture dated 30 june 2006 and | Créé le 03 oct. 2007 Livré le 17 oct. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the chargors to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0