KNOWMASTER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKNOWMASTER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03013147
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KNOWMASTER LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe KNOWMASTER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Tower Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Kent
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de KNOWMASTER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour KNOWMASTER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    État du capital au 18 déc. 2012

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Mr David James Bruce en tant qu'administrateur le 08 août 2012

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Graham Maxwell Barr en tant que directeur le 08 août 2012

    1 pagesTM01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Nomination de Mr Graham Maxwell Barr en tant qu'administrateur le 16 avr. 2012

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Bryan Park en tant que directeur le 16 avr. 2012

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de Tower Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN United Kingdom le 21 févr. 2012

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 2 County Gate Staceys Street Maidstone Kent ME14 1st le 07 oct. 2011

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    14 pagesAA

    Nomination de Mr Bryan Park en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    legacy

    9 pagesMG01

    Nomination de Mr Samuel Thomas Budgen Clark en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    19 pagesAA

    Cessation de la nomination de Roger Brown en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de KNOWMASTER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Secrétaire
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    British117669700002
    BRUCE, David James
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector171398800001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector149939610001
    REA, Michael Peter
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector147194830001
    MCLEAN, Linda Ann
    Rose Cottage
    Prees Green
    SY13 2BN Whitchurch
    Shropshire
    Secrétaire
    Rose Cottage
    Prees Green
    SY13 2BN Whitchurch
    Shropshire
    British95019110001
    RICHARDSON, Norman
    The Moorings
    School Lane
    CH66 5PH Childer Thornton
    South Wirral
    Secrétaire
    The Moorings
    School Lane
    CH66 5PH Childer Thornton
    South Wirral
    BritishSolicitor34876810002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARR, Graham Maxwell
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector125097020001
    BROWN, Roger Michael
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    Administrateur
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    EnglandBritishDirector134140540001
    BUNTING, David John
    1 Dibbs Pocket
    Preston Old Road, Freckleton
    PR4 1JF Preston
    Lancashire
    Administrateur
    1 Dibbs Pocket
    Preston Old Road, Freckleton
    PR4 1JF Preston
    Lancashire
    United KingdomBritishInsurance Broker63563080002
    HAMEL, Karl
    47 Forest Road
    CH60 5SN Heswall
    Merseyside
    Administrateur
    47 Forest Road
    CH60 5SN Heswall
    Merseyside
    United KingdomBritishInsurance Broker111016270001
    HARRISON, Thomas Millward
    29 Orston Crescent
    Spital
    CH63 9NZ Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    29 Orston Crescent
    Spital
    CH63 9NZ Wirral
    Merseyside
    BritishInsurance Broker94218200001
    JOHNSON, Timothy David
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    Administrateur
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    EnglandBritishDirector129538180001
    PARK, Bryan
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector113694470002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    KNOWMASTER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 14 sept. 2010
    Livré le 18 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 18 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of accession to a debenture dated 30 june 2006 and
    Créé le 03 oct. 2007
    Livré le 17 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 17 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0