DESIGN & RENOVATIONS LIMITED

DESIGN & RENOVATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDESIGN & RENOVATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03015655
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DESIGN & RENOVATIONS LIMITED ?

    • (4521) /

    Où se situe DESIGN & RENOVATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    6 Sedgecombe Avenue
    Kenton
    HA3 0HL Harrow
    Middlesex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DESIGN & RENOVATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CAINGOLD LIMITED30 janv. 199530 janv. 1995

    Quels sont les derniers dépôts pour DESIGN & RENOVATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    5 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 févr. 2011

    État du capital au 07 févr. 2011

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Kenneth Barclay le 30 janv. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Janet Barclay le 30 janv. 2011

    1 pagesCH03

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Kenneth Barclay le 08 févr. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2008

    5 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed caingold LIMITED\certificate issued on 12/02/09
    2 pagesCERTNM

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2007

    5 pagesAA

    legacy

    6 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2006

    5 pagesAA

    legacy

    6 pages363s

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2005

    6 pagesAA

    legacy

    6 pages363s

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2004

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages225

    Qui sont les dirigeants de DESIGN & RENOVATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARCLAY, Janet
    6 Sedgecombe Avenue
    Kenton
    HA3 0HL Harrow
    Middlesex
    Secrétaire
    6 Sedgecombe Avenue
    Kenton
    HA3 0HL Harrow
    Middlesex
    BritishCompany Secretary79344240005
    BARCLAY, Kenneth
    Burford Gardens
    WR11 3AJ Evesham
    39
    Worcestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Burford Gardens
    WR11 3AJ Evesham
    39
    Worcestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishConsultant79344170006
    WHELAN, Jeff
    182 Hermitage Road
    N4 1NN London
    Secrétaire désigné
    182 Hermitage Road
    N4 1NN London
    British900010240001
    GODDARD, Michael
    42 Somerville Drive
    OX6 7TU Bicester
    Oxfordshire
    Administrateur
    42 Somerville Drive
    OX6 7TU Bicester
    Oxfordshire
    BritishBuilder50840550001
    HEAD, David
    Broadmoor Lodge
    Little Walford
    CV36 5LY Shipston On Stour
    Warwickshire
    Administrateur
    Broadmoor Lodge
    Little Walford
    CV36 5LY Shipston On Stour
    Warwickshire
    BritishBuilder50841240004
    RUTLAND, Alan
    82 Stanley Road
    CO15 2BL Clacton On Sea
    Essex
    Administrateur désigné
    82 Stanley Road
    CO15 2BL Clacton On Sea
    Essex
    British900010230001

    DESIGN & RENOVATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 01 oct. 2003
    Livré le 02 oct. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The coach house telegraph street shipston-on stour warwickshire t/n WK395567.
    Personnes ayant droit
    • Johnson & Co (Deddington) Limited
    Transactions
    • 02 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 06 août 2001
    Livré le 14 août 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as the coach house telegraph street shipston-on-stour warwickshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 22 déc. 2000
    Livré le 09 janv. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as the old forge idlecote warwickshire title numbers WK338839 WK387023. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 16 juin 2000
    Livré le 21 juin 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 6A & 6B west street buckingham buckinghamshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 29 mars 2000
    Livré le 06 avr. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a little barn 6C west street buckingham buckinghamshire t/nos.BM238681 and BM119252.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 28 oct. 1998
    Livré le 14 nov. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Oriel farm shenington banbury oxfordshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 07 déc. 1997
    Livré le 19 déc. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Ancient lights tingewick buckinghamshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 16 juin 1997
    Livré le 19 juin 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0