YORKSHIRE CARE GROUP LIMITED

YORKSHIRE CARE GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéYORKSHIRE CARE GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03016902
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de YORKSHIRE CARE GROUP LIMITED ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe YORKSHIRE CARE GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Suite 201 Second Floor
    Design Centre East, Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de YORKSHIRE CARE GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AYRESBECK LIMITED01 févr. 199501 févr. 1995

    Quels sont les derniers comptes de YORKSHIRE CARE GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour YORKSHIRE CARE GROUP LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour YORKSHIRE CARE GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jon Hather le 09 avr. 2014

    2 pagesCH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 févr. 2014

    État du capital au 14 févr. 2014

    • Capital: GBP 1,575,000
    SH01

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 27 janv. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Michael Parsons en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    12 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jon Hather le 25 mars 2013

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    15 pagesMG01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Nomination de Mr Ian Portal en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Jon Hather en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de * Suite 201 the Chambers Chelsea Harbour London SW10 0XF* le 13 déc. 2011

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    13 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de YORKSHIRE CARE GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PORTAL, Ian
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    165689860001
    DUNCAN, David Gregor
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Administrateur
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director97755760001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Administrateur
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary68848420006
    DUNCAN, David Gregor
    Flat 43 The Piper Building
    Peterborough Road
    SW6 3EF London
    Secrétaire
    Flat 43 The Piper Building
    Peterborough Road
    SW6 3EF London
    BritishFinance Director97755760001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    BritishCompany Secretary68848420004
    PARSONS, Michael Dennis
    13 The Belvedere
    Chelsea Harbour
    SW10 0XA London
    Secrétaire
    13 The Belvedere
    Chelsea Harbour
    SW10 0XA London
    BritishConsultant Company Director44895330007
    SUMMARSELL, Robert Alan
    South Downs Park Lane Court
    Shadwell
    LS17 8TW Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    South Downs Park Lane Court
    Shadwell
    LS17 8TW Leeds
    West Yorkshire
    British2569680002
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Secrétaire désigné
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    ARASU, Sathiyarajah, Dr
    35 Beverly House
    133-135 Park Road St Johns Wood
    NW8 7JD London
    Administrateur
    35 Beverly House
    133-135 Park Road St Johns Wood
    NW8 7JD London
    EnglandBritishMedical Doctor100451830001
    BACON, Nicholas Hickman Ponsonby, Sir
    Raveningham Hall
    Raveningham
    NR14 6NS Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Raveningham Hall
    Raveningham
    NR14 6NS Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishCompany Director1997230001
    MCGARTOLL, Owen Raphael
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Administrateur
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    IrishDirector116537370001
    PARSONS, Michael Dennis
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Administrateur
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector44895330007
    PARSONS, Michael Dennis
    13 The Belvedere
    Chelsea Harbour
    SW10 0XA London
    Administrateur
    13 The Belvedere
    Chelsea Harbour
    SW10 0XA London
    United KingdomBritishConsultant Company Director44895330007
    SUMMARSELL, Robert Alan
    South Downs Park Lane Court
    Shadwell
    LS17 8TW Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    South Downs Park Lane Court
    Shadwell
    LS17 8TW Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director2569680002
    L & A REGISTRARS LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Administrateur désigné
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001440001

    YORKSHIRE CARE GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 14 déc. 2012
    Livré le 19 déc. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wilmington Trust (London) Limited
    Transactions
    • 19 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 22 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    An intercreditor and subordination agreement
    Créé le 13 juil. 2006
    Livré le 25 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Subject to clause 10.2 if at any time prior to the discharge in full of the liabilities of the senior creditors, any lender or investor receives or recovers any payment or distribution of, or on account of or in relation to, any of the liabilities which is not permitted by clause 7 any amount by way of set-off in respect of any of the liabilities owed to them which does not give effect to a payment permitted by clause 7. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 25 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Subordination agreement
    Créé le 13 juil. 2006
    Livré le 20 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company as junior creditor under the subordination agreement has undertaken to the security trustee that if: any obligor makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of, all or any part of the junior liabilities; or any junior creditor recieves all or any amount. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 20 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 13 juil. 2006
    Livré le 20 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The bridge secured obligations being all monies due or to become due from each bridge obligor to the bridge finance parties or bridge overdraft banks (or any of them) and the opco secured obligations being all monies due or to become due from each opco obligor to the opco finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties (The "Securitytrustee")
    Transactions
    • 20 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 19 oct. 2004
    Livré le 02 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the charging companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The dales nursing home main street draughton craven north yorkshire, f/h,t/n NYK132490, threshfield court nursing home threshfield craven north yorkshire, f/h t/n NYK53903,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Beneficiaries(The Security Trustee)
    Transactions
    • 02 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 nov. 2003
    Livré le 12 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the property known as the dales care centre and 1-7 dale view cottages, main street, draughton, craven, north yorkshire t/no NYK132490; all and whole the property known as threshfield court nursing home, station road, threshfield, skipton, craven, north yorkshire and 1-10, the stable, threshfield, skipton, craven, north yorkshire t/no NYK53903. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 12 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 oct. 2003
    Livré le 25 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 oct. 2003
    Livré le 25 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage threshfield court nursing home station road threshfield skipton craven north yorkshire BD23 5ET t/no NYK53903. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 oct. 2003
    Livré le 25 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage the dales care centre main street draughton craven north yorkshire BD23 6DU t/no NYK132490. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 juin 1996
    Livré le 21 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever .
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 21 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 juin 1996
    Livré le 21 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever .
    Brèves mentions
    F/H property k/a the dales nursibng home main street draughton skipton north yorkshire t/no:- NYK132490.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 21 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 juin 1996
    Livré le 21 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever .
    Brèves mentions
    F/H property k/a threshfield court nursing home threshfield grassinton north yorkshire t/no:- NYK53903.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 21 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0