MORTGAGE INTELLIGENCE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MORTGAGE INTELLIGENCE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03018519 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MORTGAGE INTELLIGENCE LIMITED ?
| Adresse du siège social | Roddis House 12 Old Christchurch Road BH1 1LG Bournemouth |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MORTGAGE INTELLIGENCE LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MORTGAGE INTELLIGENCE LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 22 janv. 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 05 févr. 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 22 janv. 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MORTGAGE INTELLIGENCE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 22 janv. 2026 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT United Kingdom à Roddis House 12 Old Christchurch Road Bournemouth BH1 1LG | 1 pages | AD02 | ||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Roddis House 12 Old Christchurch Road Bournemouth BH1 1LG | 1 pages | AD04 | ||
Nomination de Onedome Finance Ltd en tant qu'administrateur le 01 déc. 2025 | 2 pages | AP02 | ||
Nomination de Mr Babak Ismayil en tant qu'administrateur le 01 déc. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Elliott James Vigar en tant qu'administrateur le 01 déc. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Oakwood Corporate Secretary Limited en tant que secrétaire le 01 déc. 2025 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Richard John Twigg en tant que directeur le 01 déc. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Adrian Paul Scott en tant que directeur le 01 déc. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Notification de Onedome Finance Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 déc. 2025 | 2 pages | PSC02 | ||
Cessation de Mortgage Intelligence Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 déc. 2025 | 1 pages | PSC07 | ||
Modification des détails de Mortgage Intelligence Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 nov. 2025 | 2 pages | PSC05 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2024 | 20 pages | AA | ||
legacy | 71 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 janv. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard John Twigg le 06 janv. 2025 | 2 pages | CH01 | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2023 | 21 pages | AA | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 73 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Cessation de la nomination de Sarah Anne Laker en tant que directeur le 17 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT | 1 pages | AD03 | ||
Qui sont les dirigeants de MORTGAGE INTELLIGENCE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMAYIL, Babak | Administrateur | Roddis House 12 Old Christchurch Road BH1 1LG Bournemouth | England | British | 186556430001 | |||||||||
| VIGAR, Elliott James | Administrateur | Roddis House 12 Old Christchurch Road BH1 1LG Bournemouth | United Kingdom | British | 315304760001 | |||||||||
| ONEDOME FINANCE LTD | Administrateur | Parkway Whiteley PO15 7FJ Fareham Cmme - 3 Turnberry House Hants England |
| 331712530001 | ||||||||||
| COPE, Stephen Samuel | Secrétaire | 7 Brackendale Road BH8 9HY Bournemouth Dorset | British | 114361330001 | ||||||||||
| DAVIES, Philip John | Secrétaire | 3 Barton Common Lane BH25 5PS New Milton Hampshire | British | 109518120001 | ||||||||||
| MILLS, Christopher Douglas Francis | Secrétaire | Orchard View Forge Hill Hampstead Norreys RG18 0TE Newbury Berkshire | British | 127063910001 | ||||||||||
| WATSON, Simon Donald | Secrétaire | 4 Dumville Drive RH9 8NY Godstone Surrey | British | 48982500003 | ||||||||||
| WATSON, Simon Donald | Secrétaire | 19 Salisbury Road RH9 8AA Godstone Surrey | British | 48982500002 | ||||||||||
| WHITE, William James | Secrétaire | Thanes Farm Motcombe SP7 9LE Shaftesbury Dorset | British | 31946620001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Gareth Rhys | Secrétaire | 1st Floor 91-99 New London Road CM2 0PP Chelmsford Greenwood House Essex United Kingdom | 159836800001 | |||||||||||
| FIRST SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 72 New Bond Street W1S 1RR London | 900000780001 | |||||||||||
| OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Secrétaire | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
| BELL, Graham Richard | Administrateur | 88-103 Caldecotte Lake Drive Caldecotte MK7 8JT Milton Keynes Countrywide House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 149828400001 | |||||||||
| BLAND, Leslie Martin | Administrateur | Old Way Old Avenue KT14 6AD West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 2030290002 | |||||||||
| BURDEN, Alan Rodger | Administrateur | 6 Flaghead Road Canford Cliffs BH13 7JW Poole Dorset | England | British | 1875270001 | |||||||||
| CEENEY, Natalie Anna | Administrateur | 1st Floor 91-99 New London Road CM2 0PP Chelmsford Greenwood House Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 209016670003 | |||||||||
| CLARKE, Jim | Administrateur | United Kingdom House 180 Oxford Street W1D 1NN London 7th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 127131840004 | |||||||||
| CURRAN, Peter | Administrateur | 1st Floor 91-99 New London Road CM2 0PP Chelmsford Greenwood House Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 318302470001 | |||||||||
| DAVIES, Philip John | Administrateur | 3 Barton Common Lane BH25 5PS New Milton Hampshire | British | 109518120001 | ||||||||||
| DIXON, Paul Michael | Administrateur | 88-103 Caldecotte Lake Drive Caldecotte MK7 8JT Milton Keynes Countrywide House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 256585450001 | |||||||||
| GOLDEN, Robert Charles | Administrateur | Higher Street Kingswear TQ6 0AG Dartmouth Tower House Devon | United Kingdom | British | 140557190001 | |||||||||
| HOLT, David Michael | Administrateur | 14 Ettrick Road Branksome Park BH13 6LG Poole Dorset | United Kingdom | British | 31946630001 | |||||||||
| LAKER, Sarah Anne | Administrateur | 4th Floor 4-12 Old Christchurch Road BH1 1LG Bournemouth Roddis House Dorset United Kingdom | United Kingdom | British | 56577810004 | |||||||||
| LIVESEY, David Christopher | Administrateur | 16-20 Hockliffe Street LU7 1GN Leighton Buzzard Cumbria House Beds United Kingdom | England | British | 160476270001 | |||||||||
| MACHIN, Anthony John | Administrateur | Summer Hill 168 Chester Road SK11 8PT Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 99500610001 | |||||||||
| MILLS, Christopher Douglas Francis | Administrateur | Orchard View Forge Hill Hampstead Norreys RG18 0TE Newbury Berkshire | England | British | 127063910001 | |||||||||
| ROYAL, Stephen John | Administrateur | 6 Tower Road BH13 6HY Poole Dorset | British | 68795190001 | ||||||||||
| SCOTT, Adrian Paul | Administrateur | 16-20 Hockliffe Street LU7 1GN Leighton Buzzard Cumbria House Beds United Kingdom | United Kingdom | British | 106711150001 | |||||||||
| SELLERS, Robin David | Administrateur | Town House Church Hill CM7 4NP Finchingfield Essex | British | 42712940006 | ||||||||||
| STOCKTON, Nigel, Mr. | Administrateur | 88-103 Caldecotte Lake Drive Caldecotte MK7 8JT Milton Keynes Countrywide House Buckinghamshire England | United Kingdom | British | 174177530001 | |||||||||
| STOCKTON, Nigel, Mr. | Administrateur | 88-103 Caldecotte Lake Drive Caldecotte MK7 8JT Milton Keynes Countrywide House Buckinghamshire England | United Kingdom | British | 174177530001 | |||||||||
| STOCKTON, Nigel, Mr. | Administrateur | 88-103 Caldecotte Lake Drive Caldecotte MK7 8JT Milton Keynes Countrywide House Buckinghamshire England | United Kingdom | British | 174177530001 | |||||||||
| STONE, Peter John | Administrateur | 68 Ennerdale Road Kew Gardens TW9 2DL Richmond Surrey | United Kingdom | British | 1618850001 | |||||||||
| TURNER, Grenville | Administrateur | 88-103 Caldecotte Lake Drive Caldecotte MK7 8JT Milton Keynes Countrywide House Buckinghamshire England | United Kingdom | British | 67625660003 | |||||||||
| TWIGG, Richard John | Administrateur | 16-20 Hockliffe Street LU7 1GN Leighton Buzzard Cumbria House Beds United Kingdom | England | British | 290309030001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MORTGAGE INTELLIGENCE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onedome Finance Ltd | 01 déc. 2025 | 4400 Parkway Whiteley PO15 7FJ Fareham Cmme- 3 Turnberry House Hants England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mortgage Intelligence Holdings Limited | 06 avr. 2016 | 16-20 Hockliffe Street LU7 1GN Leighton Buzzard Cumbria House Bedfordshire United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour MORTGAGE INTELLIGENCE LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 06 févr. 2017 | 12 oct. 2017 | La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0