THE LOCUM GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE LOCUM GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03020008
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE LOCUM GROUP LIMITED ?

    • Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques n.c.a. (74909) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques
    • Autres activités des agences de placement (78109) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe THE LOCUM GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Academy Court
    94 Chancery Lane
    WC2A 1DT London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE LOCUM GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MERRINWORTH LIMITED09 févr. 199509 févr. 1995

    Quels sont les derniers comptes de THE LOCUM GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour THE LOCUM GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 09 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 févr. 2016

    État du capital au 10 févr. 2016

    • Capital: GBP 6,007,500
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 févr. 2015

    État du capital au 12 févr. 2015

    • Capital: GBP 6,007,500
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014

    4 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 févr. 2014

    État du capital au 17 févr. 2014

    • Capital: GBP 6,007,500
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Déclaration des objets de la société

    1 pagesCC04

    Résolutions

    Resolutions
    34 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * Academy Court, Third Floor 94 Chancery Lane London WC2A 1DT* le 13 févr. 2012

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Joan Edmunds le 15 févr. 2011

    1 pagesCH03

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2010

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Derek Beal en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr James Andrew Reed en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 27 juin 2009

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2008 au 30 juin 2009

    1 pagesAA01

    Qui sont les dirigeants de THE LOCUM GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EDMUNDS, Joan
    94 Chancery Lane
    WC2A 1DT London
    Academy Court
    United Kingdom
    Secrétaire
    94 Chancery Lane
    WC2A 1DT London
    Academy Court
    United Kingdom
    British18978230001
    REED, James Andrew
    94 Chancery Lane
    WC2A 1DT London
    Academy Court
    United Kingdom
    Administrateur
    94 Chancery Lane
    WC2A 1DT London
    Academy Court
    United Kingdom
    EnglandBritish84718880002
    CARTER, Adrian John
    Linton House
    Hopping Jacks Lane, Danbury
    CM3 4PJ Chelmsford
    Essex
    Secrétaire
    Linton House
    Hopping Jacks Lane, Danbury
    CM3 4PJ Chelmsford
    Essex
    British49358790006
    CHAPMAN, Peter
    52 Braeburn Way
    Kings Hill
    ME19 4BY West Malling
    Kent
    Secrétaire
    52 Braeburn Way
    Kings Hill
    ME19 4BY West Malling
    Kent
    British85205140001
    CHICK, Lesley Anne
    4 The Terrace
    Folly Lane
    BS25 1TE Shipham
    Winscombe
    North Somerset
    Secrétaire désigné
    4 The Terrace
    Folly Lane
    BS25 1TE Shipham
    Winscombe
    North Somerset
    British900008230001
    HARA, Balbir
    30 Highcliffe Gardens
    IG4 5HR Ilford
    Essex
    Secrétaire
    30 Highcliffe Gardens
    IG4 5HR Ilford
    Essex
    British54925610001
    WYNN, Martin Stuart
    Fernbank East Street
    Rusper
    RH12 4RE Horsham
    West Sussex
    Secrétaire
    Fernbank East Street
    Rusper
    RH12 4RE Horsham
    West Sussex
    British37363980002
    BEAL, Derek George
    The Crest 1 Highview Place
    Arterberry Road
    SW20 8AL London
    Administrateur
    The Crest 1 Highview Place
    Arterberry Road
    SW20 8AL London
    EnglandBritish16866760004
    CONNELL, Richard Andrew
    Lower Roundhurst
    Tennyson's Lane Roundhurst
    GU27 3BN Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    Lower Roundhurst
    Tennyson's Lane Roundhurst
    GU27 3BN Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritish102127970001
    COX, Gary Alan
    36 Rosslyn Park
    KT13 9QZ Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    36 Rosslyn Park
    KT13 9QZ Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish85047330001
    DAEL, Susan
    18 Halidon Rise
    Harold Park
    RM3 0YL Romford
    Essex
    Administrateur
    18 Halidon Rise
    Harold Park
    RM3 0YL Romford
    Essex
    British74826250002
    DOYLE, Desmond Mark Christopher
    Woodlawn House
    Arrow Lane, Hartley Witney
    RG27 8LR Hook
    Hampshire
    Administrateur
    Woodlawn House
    Arrow Lane, Hartley Witney
    RG27 8LR Hook
    Hampshire
    British88770150001
    ECHTLE, Christa Iris
    9 Old Palace Lane
    TW9 1PG Richmond
    Surrey
    Administrateur
    9 Old Palace Lane
    TW9 1PG Richmond
    Surrey
    British39803450001
    FENNELL, David Michael
    The Laurels
    Maple Court Rodmersham
    ME9 0LR Sittingbourne
    Kent
    Administrateur
    The Laurels
    Maple Court Rodmersham
    ME9 0LR Sittingbourne
    Kent
    EnglandBritish108942680001
    FURNISS, Ian William
    Middle Field
    2 Woodlands Close
    NR25 6DU Holt
    Norfolk
    Administrateur
    Middle Field
    2 Woodlands Close
    NR25 6DU Holt
    Norfolk
    EnglandBritish117943650001
    GARRATT, Mark Jonathan
    21 Stradella Road
    Herne Hill
    SE24 9HN London
    Administrateur
    21 Stradella Road
    Herne Hill
    SE24 9HN London
    EnglandBritish118003050001
    GOUL-WHEEKER, Trevor Robert Ogilvie
    La Petite Sevelotte
    15, The Park
    KT23 3LN Bookham
    Surrey
    Administrateur
    La Petite Sevelotte
    15, The Park
    KT23 3LN Bookham
    Surrey
    EnglandBritish102096180002
    GUNN, Dorothy Patricia
    36 Brunswick Gardens
    Hainault
    IG6 2QU Ilford
    Essex
    Administrateur
    36 Brunswick Gardens
    Hainault
    IG6 2QU Ilford
    Essex
    British49390740001
    HARPER, Paul Stephen
    Drey Cottage 15 Firs Walk
    Tewin Wood
    AL6 0NY Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    Drey Cottage 15 Firs Walk
    Tewin Wood
    AL6 0NY Welwyn
    Hertfordshire
    British64302310001
    HARTOP, Barry
    Field Cottage
    The Ridgeway
    GU1 2DG Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Field Cottage
    The Ridgeway
    GU1 2DG Guildford
    Surrey
    EnglandBritish67432850001
    MEIGHAN, Julia
    3a Spareleaze Hill
    IG10 1BS Loughton
    Essex
    Administrateur
    3a Spareleaze Hill
    IG10 1BS Loughton
    Essex
    British30536990002
    MORRIS, Angela Smith
    14 Moor Lane
    GU22 9QY Woking
    Surrey
    Administrateur
    14 Moor Lane
    GU22 9QY Woking
    Surrey
    EnglandBritish75022250001
    NEALE, Frank Leslie George
    Archway House 53 The Avenue
    WD17 4NU Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Archway House 53 The Avenue
    WD17 4NU Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritish4554050001
    NICHOLLS, Nigel Philip
    46 Tollgate Road
    Colney Heath
    AL4 0PY St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    46 Tollgate Road
    Colney Heath
    AL4 0PY St Albans
    Hertfordshire
    British5999120002
    NICHOLSON, William
    2a Ashbridge Road
    Leytonstone
    E11 1NH London
    Administrateur
    2a Ashbridge Road
    Leytonstone
    E11 1NH London
    British74826470002
    PEACOCK, Teresa
    39 Bridport Way
    Kings Park Village
    CM7 9FJ Braintree
    Essex
    Administrateur
    39 Bridport Way
    Kings Park Village
    CM7 9FJ Braintree
    Essex
    British44331460002
    RAWORTH, Richard
    7 St Georges Road
    St Margarets
    TW1 1QS Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    7 St Georges Road
    St Margarets
    TW1 1QS Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish1506920001
    REDDING, Diana Elizabeth
    Rainbow House
    Oakridge Lane Sidcot
    BS25 1LZ Winscombe
    Avon
    Administrateur désigné
    Rainbow House
    Oakridge Lane Sidcot
    BS25 1LZ Winscombe
    Avon
    EnglandBritish900004650001
    WYNN, Martin Stuart
    Fernbank East Street
    Rusper
    RH12 4RE Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    Fernbank East Street
    Rusper
    RH12 4RE Horsham
    West Sussex
    United KingdomBritish37363980002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE LOCUM GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Reed Healthcare Limited
    94 Chancery Lane
    WC2A 1DT London
    Academy Court
    England
    06 avr. 2016
    94 Chancery Lane
    WC2A 1DT London
    Academy Court
    England
    Non
    Forme juridiqueCompany Limited By Shares
    Autorité légaleEnglish Law
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    THE LOCUM GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 04 juil. 2002
    Livré le 24 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage of life policy
    Créé le 07 sept. 1999
    Livré le 14 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies accruing under the policy of insurance dated 10.2.99 policy number x 68381609 on the life of d m r fennell with standard life assurance company.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over shares
    Créé le 07 août 1996
    Livré le 19 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 ordinary shares of £1.00 each (the shares) in the capital of L.G. international employment services limited including all dividends bonuses rights and benefits attaching to or arising in respect thereof.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over shares
    Créé le 07 août 1996
    Livré le 19 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 ordinary shares of £1.00 each (the shares) in the capital of L.G. international employment services limited including all dividends bonuses rights and benefits attaching to or arising in respect thereof.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transactions
    • 19 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over shares
    Créé le 26 juin 1995
    Livré le 08 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All dividends, bonuses, rights and benefits in respect of the 100 ordinary shares of £1.00 each in the capital of caroline pelham limited and all beneficial interests therein and to any proceeds of sale.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 26 juin 1995
    Livré le 08 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over shares
    Créé le 26 juin 1995
    Livré le 08 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All dividends, bonuses, rights and benefits in respect of the 100 ordinary shares of £1.00 each in the capital of caroline pelham limited and all beneficial interests of the company therein and to any proceeds of sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transactions
    • 08 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 26 juin 1995
    Livré le 08 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transactions
    • 08 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0