THE LOCUM GROUP LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | THE LOCUM GROUP LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03020008 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE LOCUM GROUP LIMITED ?
| Adresse du siège social | Academy Court 94 Chancery Lane WC2A 1DT London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE LOCUM GROUP LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour THE LOCUM GROUP LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 8 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 févr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014 | 4 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Déclaration des objets de la société | 1 pages | CC04 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 34 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Academy Court, Third Floor 94 Chancery Lane London WC2A 1DT* le 13 févr. 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2011 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Joan Edmunds le 15 févr. 2011 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2010 | 4 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Derek Beal en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr James Andrew Reed en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 27 juin 2009 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2008 au 30 juin 2009 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de THE LOCUM GROUP LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDMUNDS, Joan | Secrétaire | 94 Chancery Lane WC2A 1DT London Academy Court United Kingdom | British | 18978230001 | ||||||
| REED, James Andrew | Administrateur | 94 Chancery Lane WC2A 1DT London Academy Court United Kingdom | England | British | 84718880002 | |||||
| CARTER, Adrian John | Secrétaire | Linton House Hopping Jacks Lane, Danbury CM3 4PJ Chelmsford Essex | British | 49358790006 | ||||||
| CHAPMAN, Peter | Secrétaire | 52 Braeburn Way Kings Hill ME19 4BY West Malling Kent | British | 85205140001 | ||||||
| CHICK, Lesley Anne | Secrétaire désigné | 4 The Terrace Folly Lane BS25 1TE Shipham Winscombe North Somerset | British | 900008230001 | ||||||
| HARA, Balbir | Secrétaire | 30 Highcliffe Gardens IG4 5HR Ilford Essex | British | 54925610001 | ||||||
| WYNN, Martin Stuart | Secrétaire | Fernbank East Street Rusper RH12 4RE Horsham West Sussex | British | 37363980002 | ||||||
| BEAL, Derek George | Administrateur | The Crest 1 Highview Place Arterberry Road SW20 8AL London | England | British | 16866760004 | |||||
| CONNELL, Richard Andrew | Administrateur | Lower Roundhurst Tennyson's Lane Roundhurst GU27 3BN Haslemere Surrey | United Kingdom | British | 102127970001 | |||||
| COX, Gary Alan | Administrateur | 36 Rosslyn Park KT13 9QZ Weybridge Surrey | England | British | 85047330001 | |||||
| DAEL, Susan | Administrateur | 18 Halidon Rise Harold Park RM3 0YL Romford Essex | British | 74826250002 | ||||||
| DOYLE, Desmond Mark Christopher | Administrateur | Woodlawn House Arrow Lane, Hartley Witney RG27 8LR Hook Hampshire | British | 88770150001 | ||||||
| ECHTLE, Christa Iris | Administrateur | 9 Old Palace Lane TW9 1PG Richmond Surrey | British | 39803450001 | ||||||
| FENNELL, David Michael | Administrateur | The Laurels Maple Court Rodmersham ME9 0LR Sittingbourne Kent | England | British | 108942680001 | |||||
| FURNISS, Ian William | Administrateur | Middle Field 2 Woodlands Close NR25 6DU Holt Norfolk | England | British | 117943650001 | |||||
| GARRATT, Mark Jonathan | Administrateur | 21 Stradella Road Herne Hill SE24 9HN London | England | British | 118003050001 | |||||
| GOUL-WHEEKER, Trevor Robert Ogilvie | Administrateur | La Petite Sevelotte 15, The Park KT23 3LN Bookham Surrey | England | British | 102096180002 | |||||
| GUNN, Dorothy Patricia | Administrateur | 36 Brunswick Gardens Hainault IG6 2QU Ilford Essex | British | 49390740001 | ||||||
| HARPER, Paul Stephen | Administrateur | Drey Cottage 15 Firs Walk Tewin Wood AL6 0NY Welwyn Hertfordshire | British | 64302310001 | ||||||
| HARTOP, Barry | Administrateur | Field Cottage The Ridgeway GU1 2DG Guildford Surrey | England | British | 67432850001 | |||||
| MEIGHAN, Julia | Administrateur | 3a Spareleaze Hill IG10 1BS Loughton Essex | British | 30536990002 | ||||||
| MORRIS, Angela Smith | Administrateur | 14 Moor Lane GU22 9QY Woking Surrey | England | British | 75022250001 | |||||
| NEALE, Frank Leslie George | Administrateur | Archway House 53 The Avenue WD17 4NU Watford Hertfordshire | England | British | 4554050001 | |||||
| NICHOLLS, Nigel Philip | Administrateur | 46 Tollgate Road Colney Heath AL4 0PY St Albans Hertfordshire | British | 5999120002 | ||||||
| NICHOLSON, William | Administrateur | 2a Ashbridge Road Leytonstone E11 1NH London | British | 74826470002 | ||||||
| PEACOCK, Teresa | Administrateur | 39 Bridport Way Kings Park Village CM7 9FJ Braintree Essex | British | 44331460002 | ||||||
| RAWORTH, Richard | Administrateur | 7 St Georges Road St Margarets TW1 1QS Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | 1506920001 | |||||
| REDDING, Diana Elizabeth | Administrateur désigné | Rainbow House Oakridge Lane Sidcot BS25 1LZ Winscombe Avon | England | British | 900004650001 | |||||
| WYNN, Martin Stuart | Administrateur | Fernbank East Street Rusper RH12 4RE Horsham West Sussex | United Kingdom | British | 37363980002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE LOCUM GROUP LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Healthcare Limited | 06 avr. 2016 | 94 Chancery Lane WC2A 1DT London Academy Court England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
THE LOCUM GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Créé le 04 juil. 2002 Livré le 24 juil. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage of life policy | Créé le 07 sept. 1999 Livré le 14 sept. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All monies accruing under the policy of insurance dated 10.2.99 policy number x 68381609 on the life of d m r fennell with standard life assurance company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over shares | Créé le 07 août 1996 Livré le 19 août 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 2 ordinary shares of £1.00 each (the shares) in the capital of L.G. international employment services limited including all dividends bonuses rights and benefits attaching to or arising in respect thereof.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over shares | Créé le 07 août 1996 Livré le 19 août 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 2 ordinary shares of £1.00 each (the shares) in the capital of L.G. international employment services limited including all dividends bonuses rights and benefits attaching to or arising in respect thereof.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over shares | Créé le 26 juin 1995 Livré le 08 juil. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All dividends, bonuses, rights and benefits in respect of the 100 ordinary shares of £1.00 each in the capital of caroline pelham limited and all beneficial interests therein and to any proceeds of sale. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 26 juin 1995 Livré le 08 juil. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over shares | Créé le 26 juin 1995 Livré le 08 juil. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All dividends, bonuses, rights and benefits in respect of the 100 ordinary shares of £1.00 each in the capital of caroline pelham limited and all beneficial interests of the company therein and to any proceeds of sale thereof. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 26 juin 1995 Livré le 08 juil. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0