REEB ESTATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREEB ESTATES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03020809
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REEB ESTATES LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe REEB ESTATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Riverside Business Centre
    Worcester Road
    DY13 9BZ Stourport-On-Severn
    Worcestershire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de REEB ESTATES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LOMBARD STREET PROPERTIES (LAINDON) LIMITED06 avr. 199506 avr. 1995
    BROOMCO (881) LIMITED13 févr. 199513 févr. 1995

    Quels sont les derniers comptes de REEB ESTATES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour REEB ESTATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 28 févr. 2019

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 28 févr. 2018

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 28 févr. 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2016

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 avr. 2016

    État du capital au 08 avr. 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2015

    3 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de The Old Library Vale Road Stourport on Severn Worcestershire DY13 8YJ à Riverside Business Centre Worcester Road Stourport-on-Severn Worcestershire DY13 9BZ le 23 nov. 2015

    1 pagesAD01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2015

    État du capital au 15 juin 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2014

    3 pagesAA

    Nomination de Mr Jonathan David Robin Westwood en tant qu'administrateur le 04 nov. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Timothy Nicholas Siviter en tant que directeur le 04 nov. 2014

    1 pagesTM01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 juin 2014

    État du capital au 12 juin 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2013

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de REEB ESTATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WESTWOOD, Jonathan David Robin
    Worcester Road
    DY13 9BZ Stourport-On-Severn
    Riverside Business Centre
    Worcestershire
    England
    Administrateur
    Worcester Road
    DY13 9BZ Stourport-On-Severn
    Riverside Business Centre
    Worcestershire
    England
    EnglandBritishDirector165439430001
    FAULKNER, Robert Michael Stanley
    12 Newfield Crescent
    B63 3SS Halesowen
    West Midlands
    Secrétaire
    12 Newfield Crescent
    B63 3SS Halesowen
    West Midlands
    BritishProject Manager27616940001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    BIRCH, Sally Ann
    150 Wilden Lane
    DY13 9LP Stourport On Severn
    Worcestershire
    Administrateur
    150 Wilden Lane
    DY13 9LP Stourport On Severn
    Worcestershire
    United KingdomBritishSecretary123289480001
    FAULKNER, Robert Michael Stanley
    12 Newfield Crescent
    B63 3SS Halesowen
    West Midlands
    Administrateur
    12 Newfield Crescent
    B63 3SS Halesowen
    West Midlands
    EnglandBritishProject Manager27616940001
    LAWRENCE, Angela Rosemary
    Broadway 7 Chapel Court
    DY10 2UQ Kidderminster
    Worcestershire
    Administrateur
    Broadway 7 Chapel Court
    DY10 2UQ Kidderminster
    Worcestershire
    BritishPrivate Secretary27616950001
    SIVITER, Timothy Nicholas
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport-On-Severn
    The Old Library
    Worcestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport-On-Severn
    The Old Library
    Worcestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector165439550001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REEB ESTATES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Jdr Westwood
    Worcester Road
    DY13 9BZ Stourport-On-Severn
    Riverside Business Centre
    Worcestershire
    England
    01 juil. 2016
    Worcester Road
    DY13 9BZ Stourport-On-Severn
    Riverside Business Centre
    Worcestershire
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    REEB ESTATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 26 avr. 2007
    Livré le 28 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a 3, 5 and 7 manchester road denton manchester t/nos GM294191, GM107795 and GM185564.
    Personnes ayant droit
    • Carillion Jm Limited and Maple Oak Limited
    Transactions
    • 28 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 08 avr. 2005
    Livré le 22 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 07 avr. 2004
    Livré le 17 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank Ag
    Transactions
    • 17 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 avr. 2004
    Livré le 17 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the west side of ashton road denton t/n GM910430, underlease of 18 milton street denton t/n LA383656, underlease of 20 milton street denton t/n LA299603, with all buildings and fixtures thereon, for details of further properties charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mowlem PLC
    Transactions
    • 17 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 07 avr. 2004
    Livré le 17 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the west side of ashton road denton t/n GM910430, underlease of 18 milton street denton t/n LA383656, underlease of 20 milton street denton t/n LA299603, with all buildings and fixtures thereon, for details of further properties charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Maple Oak PLC
    Transactions
    • 17 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 27 nov. 2003
    Livré le 13 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land known as the land at the palatine street denton manchester. By way of specific charge all rights, title and interest in and to the policies and to the compensation monies, all fixed plant, machinery and equipment, all contracts agreements and warranties. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transactions
    • 13 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 juil. 2003
    Livré le 24 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land the unitarian church, wiltan street, denton, manchester t/n's GM620375, GM833143, GM827390 and GM874088. By way of specific charge all the rights, title and interest of the company in and to the policies and to the compensation monies, the benefit of all rights and claims of the company against all lessees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transactions
    • 24 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 mars 2003
    Livré le 18 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings at 105A-107 ashton road and 2 milton street, denton, manchester t/n GM292281. All the rights, title and interest in and to the policies, the benefit of all rights and claims against all lessees from time to time of the whole or any parts of the property, all fixed plant, machinery and equipment from time to time in or on the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transactions
    • 18 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 févr. 2003
    Livré le 22 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of specific charge all the rights title and interest in and to the policies and the compensation monies referred to in the deed fixed plant machinery and equipment all the chargor's rights title and interest in and to all contracts agreements or warranties affecting the property all that f/h land k/a 40 to 63 (odd) and part of 45 to 47 peel street and 46 to 52 (even) wilton street denton manchester t/n GM346090 all that f/h land k/a 58-78 (even) queen street and 54-60 wilton street denton t/n GM346069 part of the f/h land k/a land and buildings lying to the south-west of palatine streetdenton t/n LA194457 for details of further properties please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transactions
    • 22 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 janv. 2003
    Livré le 04 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that leasehold land known as land adjoining 84 wilton street denton manchester title number GM886262 including all buildings and other structures from time to time erected thereon and all fixtures (trade or otherwise) from time to time thereon or therein and all rights title interest and benefit n and to any of the foregoing. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transactions
    • 04 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 janv. 2003
    Livré le 04 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that freehold land known as land adjoining 84 wilton street denton manchester all right title interest and benefit of the chargor (whether legal or equitable or otherwise howsoevr) from time to time in and to the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transactions
    • 04 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 déc. 2002
    Livré le 12 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land k/a land on the south side of clare street denton manchester t/no GM863985. By way of specific charge all the rights, title and interest in and to the policies and the compenstaion monies, rights against all lesees, fixed plant machinery and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transactions
    • 12 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of contracts
    Créé le 18 nov. 2002
    Livré le 03 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The chargor assigned and agreed to assign all rights, title and interest in an to the contracts and agreements being the forward sale and purchase agreement dated 21 october 2002 between the company, reeb estates (denton) pardev (clandeboye) limited and pillar property PLC. The finance agreement dated 21 october 2002 between the company, maple oak PLC, reeb estates (denton) pardev (clandeboye) limited and pillar property PLC.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transactions
    • 03 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 nov. 2002
    Livré le 19 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land k/a 50 wilton street denton manchester t/n GM908003 all other rights and claims and all fixed plant,machinery and equipment and all other rights,title and interest in and to all contracts,agreements or warranties thereunder; see form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.a / N.V
    Transactions
    • 19 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 sept. 2002
    Livré le 14 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land k/a 103-105 ashton road denton and land adjoining 103-105 ashton road denton t/nos GM816682 and GM816680. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transactions
    • 14 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 sept. 2002
    Livré le 14 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All right,title,benefit and interest whatsoever in and to the freehold land to the south west of prestwich street,denton; gm 362600;all other rights and claims and all fixed plant,machinery and equipment and all other rights,title and interest in and to all contracts,agreements or warranties thereunder; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transactions
    • 14 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 août 2002
    Livré le 16 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All those properties at denton more particularly described on the schedule to form 395 including 89 to 101 (odd) ashton road and 1, 3 and 5 wilton street t/no. GM833138 and land and buildings on west side of ashton road t/no. GM833139 and 109 to 123 (odd) ashton road t/no. GM345997. For details of further properties charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Maple Oak PLC
    Transactions
    • 16 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 août 2002
    Livré le 16 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land in relation to 18-26 (even) milton street f/H. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • John Mowlem & Company PLC
    Transactions
    • 16 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 août 2002
    Livré le 14 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All those f/h and, in relation to 18-26 (even) milton street, f/h and l/h parcels of land and buildings constructed thereon as the same are: - 89 to 101 (odd) ashton road and 1,3 and 5 wilton street t/n GM833138 land and buildings on west side of ashton road GM833139 and 125 ashton road GM345997 * for further details of properties charged please refer to form 395 *. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V. (The "Bank")
    Transactions
    • 14 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 27 juil. 2001
    Livré le 28 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h and l/h properties at denton and hyde greater manchester and wincham near northwich cheshire as specified in the schedule of properties attached to the form 395 the goodwill of the business and benefit of insurances. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Julian Hodge Bank Limited
    Transactions
    • 28 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0