REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED

REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03021292
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Central House
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    North Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    REDSTONE COMMUNICATIONS LIMITED06 févr. 200206 févr. 2002
    REDSTONE NETWORK SERVICES LIMITED17 déc. 200117 déc. 2001
    REDSTONE COMMUNICATIONS LIMITED 21 déc. 200021 déc. 2000
    REDSTONE NETWORK SERVICES LIMITED14 févr. 199514 févr. 1995

    Quels sont les derniers comptes de REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    État du capital au 10 déc. 2020

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium account be cancelled 18/11/2020
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Dean Anthony Barber en tant que directeur le 03 avr. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Dean Anthony Barber en tant qu'administrateur le 02 sept. 2019

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Peter Brotherton en tant que secrétaire le 03 sept. 2018

    1 pagesTM02

    Nomination de Harneet Jagpal en tant que secrétaire le 03 sept. 2018

    2 pagesAP03

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Fraser St John Fisher en tant que directeur le 20 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr Peter James Brotherton en tant qu'administrateur le 28 nov. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Peter Brotherton en tant que secrétaire le 28 nov. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Timothy James Coleman en tant que directeur le 06 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy James Coleman en tant que secrétaire le 06 nov. 2016

    1 pagesTM02

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2016

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JAGPAL, Harneet
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    250198230001
    BROTHERTON, Peter James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Administrateur
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritish116701310002
    BRACHER, Alan Richard
    53 Foley Road
    KT10 0LU Claygate
    Surrey
    Secrétaire
    53 Foley Road
    KT10 0LU Claygate
    Surrey
    British36451680001
    BROTHERTON, Peter
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    220552440001
    COLEMAN, Timothy James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    210014290001
    CROFT, Estelle Louise
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    Secrétaire
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    195008160001
    HARROLD, Alan Henry
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    British88772110001
    HAYES, Peter Andrew
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    164939920001
    HAYES, Peter Andrew
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    British66610550002
    MYHILL, Paul Harvey
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    Secrétaire
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    175306270001
    O'RORKE, Nicholas
    Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B-Office 10 Kirtlington Business Centre
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B-Office 10 Kirtlington Business Centre
    Oxfordshire
    149441960001
    VAN DEN HEUVEL, Christopher Edward Francis, Mr.
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    Secrétaire
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    British80721980001
    BALAAM, Martin Anthony
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritish82233550001
    BARBER, Dean Anthony
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Administrateur
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritish230739040001
    BROWN, Ian Christopher
    Fox Hollow
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    Fox Hollow
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    EnglandBritish75493580001
    BRUCE, Robert David Glenrinnes
    45 Gally Hill Road
    Church Crookham
    GU13 0QE Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    45 Gally Hill Road
    Church Crookham
    GU13 0QE Fleet
    Hampshire
    British66210170001
    BYAM SHAW, Justin David Elliott
    6 Westbourne Park Road
    W2 5PH London
    Administrateur
    6 Westbourne Park Road
    W2 5PH London
    British40017100001
    CARRINGTON, John Christopher
    1 Anchor Brewhouse
    50 Shad Thames
    SE1 2LY London
    Administrateur
    1 Anchor Brewhouse
    50 Shad Thames
    SE1 2LY London
    United KingdomBritish79087670001
    CHATFIELD, Paul
    21 Ludlow Avenue
    WR4 0EN Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    21 Ludlow Avenue
    WR4 0EN Worcester
    Worcestershire
    British71912610001
    COLEMAN, Timothy James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    Administrateur
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    United KingdomBritish163698620001
    COVE, Graham Lawrence
    2 White House Close
    SG14 3TW Watton At Stone
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 White House Close
    SG14 3TW Watton At Stone
    Hertfordshire
    EnglandBritish45340010002
    COX, David Howard
    Waverley
    Chenies Road Chorleywood
    WD3 5LU Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    Waverley
    Chenies Road Chorleywood
    WD3 5LU Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish100698330001
    CUSHING, Robert Sefton
    66 Columbia Place Fornham Street
    S2 4AR Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    66 Columbia Place Fornham Street
    S2 4AR Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish117325300001
    DAWSON, John Hugh
    Ashleigh
    Grenofen
    PL19 9EW Tavistock
    Devon
    Administrateur
    Ashleigh
    Grenofen
    PL19 9EW Tavistock
    Devon
    EnglandBritish59251210001
    DEANE, Keith
    2 Westminster Close
    GU51 4NR Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    2 Westminster Close
    GU51 4NR Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish85309310001
    DONNELLY, Mary Kathleen
    Prospect House
    1a Prospect Row
    CB1 1DU Cambridge
    Administrateur
    Prospect House
    1a Prospect Row
    CB1 1DU Cambridge
    EnglandBritish85309000001
    DOUGHTY, Royston George
    60 Cedars Road
    Hampton Wick
    KT1 4BE Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    60 Cedars Road
    Hampton Wick
    KT1 4BE Kingston Upon Thames
    Surrey
    British6194830001
    DOWNHAM, Robert Henry
    Spring Cottage
    The Common
    DT11 8QY Blandford Forum
    Dorset
    Administrateur
    Spring Cottage
    The Common
    DT11 8QY Blandford Forum
    Dorset
    British98701880001
    FISHER, Fraser St John
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Administrateur
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritish72704710002
    GRAY, Christopher Robert
    15 Vale Close
    Lower Bourne
    GU10 3HR Farnham
    Surrey
    Administrateur
    15 Vale Close
    Lower Bourne
    GU10 3HR Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish23552180001
    HALLETT, Peter John
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Administrateur
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish20621770002
    HARROLD, Alan Henry
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritish88772110001
    LANCH, Nigel Leslie
    Willow Cottage 19 Water Lane
    KT11 2PA Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Willow Cottage 19 Water Lane
    KT11 2PA Cobham
    Surrey
    British54508950001
    MCGOUGAN, Malcolm James Andrew
    33 Shrub End Road
    CO3 3UD Colchester
    Essex
    Administrateur
    33 Shrub End Road
    CO3 3UD Colchester
    Essex
    British44066820001
    MOONEY, Jeremy
    135 Victoria Road
    N22 7XH London
    Administrateur
    135 Victoria Road
    N22 7XH London
    British71912690001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Redcentric Holdings Limited
    Otley Road
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    England
    06 avr. 2016
    Otley Road
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 20 déc. 2013
    Livré le 08 janv. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Ground floor, building no. 3 (newton house), the cambridge business park, milton road, cambridge t/no CB340008. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Group debenture
    Créé le 21 juin 2012
    Livré le 29 juin 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over shares
    Créé le 24 févr. 2009
    Livré le 27 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge the charged securities, any related rights, dividends, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 01 oct. 2006
    Livré le 13 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 26 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed
    Créé le 24 juil. 2002
    Livré le 13 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £22,500.00 and all further moneys due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Deposit of £22,500 and all other moneys and interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Goodall Barnard Holdings Limited
    Transactions
    • 13 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed
    Créé le 24 juil. 2002
    Livré le 13 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £12,500.00 and all further moneys due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £12,500 deposit with all other moneys and interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Goodall Barnard Holdings Limited
    Transactions
    • 13 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed
    Créé le 24 juil. 2002
    Livré le 13 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £15,000.00 and all further moneys due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £15,000 deposit and all other moneys demanded and all interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Goodall Barnard Properties Limited
    Transactions
    • 13 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 09 mai 2001
    Livré le 15 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease granted on the same date as the deed
    Brèves mentions
    The deposit is defined in the deed as the sum or sums standing to the credit of the account including an initial deposit of £25,375,00 paid by the tenant under the deed, any renewal or replacement of these sums, all interest earned on the account and all entitlements, rights and benefits accruing directly or indirectly to the account.
    Personnes ayant droit
    • South Herts Office Campus Limited
    Transactions
    • 15 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 21 août 2000
    Livré le 24 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and lease of even date relating to the property known as third floor unit b south herts office campus borehamwood
    Brèves mentions
    A deposit of £33,876 and accruing interest. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Possfund Custodian Trustee Limited
    Transactions
    • 24 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 15 août 2000
    Livré le 25 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of the obligors to the chargee under each of the finance documents
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the equipment all benefits in respect of the insurances and all proceeds thereof for full details and definitions please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dresdner Bank Ag
    Transactions
    • 25 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 28 juin 2000
    Livré le 18 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Brèves mentions
    The tenant charges its interest in the deposit balance.
    Personnes ayant droit
    • Computer Associates UK Limited
    Transactions
    • 18 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit
    Créé le 08 mars 2000
    Livré le 28 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The sum of £61,117 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The sum. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Computer Associates UK Limited
    Transactions
    • 28 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit deed
    Créé le 16 juil. 1998
    Livré le 18 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The due compliance of the company's obligations with the chargee under the lease dated 16TH july 1998
    Brèves mentions
    The sum of £27,354.25 deposited at the royal bank of scotland PLC 67 lombard street london together with any interest accrued.
    Personnes ayant droit
    • Possfund Custodian Trustee Limited
    Transactions
    • 18 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 04 sept. 1997
    Livré le 10 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 03 oct. 1996
    Livré le 17 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 avr. 1996
    Livré le 25 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £482,925 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Three okeford switches.
    Personnes ayant droit
    • Planet Internet (UK) Limited
    Transactions
    • 25 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit deed
    Créé le 27 févr. 1996
    Livré le 28 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 27TH february 1996
    Brèves mentions
    Deposit of £18,175 maintained at the royal bank of scotland PLC 67 lombard street london tigether with all interest accruing. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Possfund Custodian Trustee Limited
    Transactions
    • 28 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0