ING (LONDON) (NO.11) LIMITED

ING (LONDON) (NO.11) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéING (LONDON) (NO.11) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03021508
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ING (LONDON) (NO.11) LIMITED ?

    • (6523) /

    Où se situe ING (LONDON) (NO.11) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    60 London Wall
    London
    EC2M 5TQ
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ING (LONDON) (NO.11) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ING BARINGS LIMITED15 févr. 199915 févr. 1999
    ING BARING SECURITIES LIMITED13 nov. 199513 nov. 1995
    BARING SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED23 juin 199523 juin 1995
    BARINGS SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED06 mars 199506 mars 1995
    841ST SHELF TRADING COMPANY LIMITED14 févr. 199514 févr. 1995

    Quels sont les derniers comptes de ING (LONDON) (NO.11) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour ING (LONDON) (NO.11) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 févr. 2010

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 mars 2010

    État du capital au 02 mars 2010

    • Capital: GBP 434,105,948
    SH01

    Cessation de la nomination de Stephen Richards en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2008

    11 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Divers

    Section 519
    2 pagesMISC

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    13 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    12 pagesAA

    legacy

    2 pages169

    legacy

    2 pages363a

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'actions propres sur capital

    RES08

    legacy

    4 pages173

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    12 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages169

    legacy

    4 pages173

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2004

    12 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed ing barings LIMITED\certificate issued on 13/04/05
    2 pagesCERTNM

    legacy

    2 pages363s

    legacy

    pages363(353)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'actions propres sur capital

    RES08

    Qui sont les dirigeants de ING (LONDON) (NO.11) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARSH, Adrian Neil
    Erchless House Fairoak Lane
    Oxshott
    KT22 0TP Leatherhead
    Surrey
    Secrétaire
    Erchless House Fairoak Lane
    Oxshott
    KT22 0TP Leatherhead
    Surrey
    British57820580001
    MARSH, Adrian Neil
    Erchless House Fairoak Lane
    Oxshott
    KT22 0TP Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Erchless House Fairoak Lane
    Oxshott
    KT22 0TP Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish57820580001
    BROEK, Onno Van Den
    5a Observatory Gardens
    Kensington
    W8 7HY London
    Secrétaire
    5a Observatory Gardens
    Kensington
    W8 7HY London
    Dutch43809450001
    ODGERS, Tara Penelope
    Flat 7 18 Redcliffe Square
    SW10 9JZ London
    Secrétaire
    Flat 7 18 Redcliffe Square
    SW10 9JZ London
    British63127920002
    PEERS, James Roger
    42 Flanchford Road
    W12 9ND London
    Secrétaire
    42 Flanchford Road
    W12 9ND London
    British5642610001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Secrétaire désigné
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    BARING, Andrew Michael Godfrey
    Ravenscourt House
    Ravenscourt Park
    W6 0TJ London
    Administrateur
    Ravenscourt House
    Ravenscourt Park
    W6 0TJ London
    British5523000001
    BENNETT, Peter Richard
    The Penthouse The Mansion
    Ottershaw Park
    KT16 0QG Chertsey
    Surrey
    Administrateur
    The Penthouse The Mansion
    Ottershaw Park
    KT16 0QG Chertsey
    Surrey
    EnglandBritish75171330001
    BENTON, Robert John
    Hatcham House
    High Street
    TN18 4PX Hawkhurst
    Kent
    Administrateur
    Hatcham House
    High Street
    TN18 4PX Hawkhurst
    Kent
    United KingdomBritish50543750003
    BRIANT, Julian Gerard Hugh
    Little Tylers 26 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    Administrateur
    Little Tylers 26 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    British58558290001
    BROEK, Onno Van Den
    5a Observatory Gardens
    Kensington
    W8 7HY London
    Administrateur
    5a Observatory Gardens
    Kensington
    W8 7HY London
    Dutch43809450001
    BURCH, Mark Lowrie
    Polbream House
    Saints Hill, Penshurst
    TN11 8EN Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    Polbream House
    Saints Hill, Penshurst
    TN11 8EN Tonbridge
    Kent
    United KingdomBritish83321590001
    CAMERON, Alastair Langdon Craig
    48 Lowther Road
    SW13 9NU London
    Administrateur
    48 Lowther Road
    SW13 9NU London
    British61541700001
    CLARKE GRAY, John
    805 Ramapo Way
    FOREIGN Westfild
    New Jersey 07090
    Usa
    Administrateur
    805 Ramapo Way
    FOREIGN Westfild
    New Jersey 07090
    Usa
    American113645800001
    CONNELLY, William
    9 Berkeley Gardens
    W8 4AP London
    Administrateur
    9 Berkeley Gardens
    W8 4AP London
    British45897080004
    COWAN, Nicholas Jeffrey
    Byams House
    Willesley
    GL8 8QU Tetbury
    Gloucestershire
    Administrateur
    Byams House
    Willesley
    GL8 8QU Tetbury
    Gloucestershire
    British61513170003
    COWAN, Nicholas Jeffrey
    1 The Belvedere
    Chelsea Harbour
    SW10 0XA London
    Administrateur
    1 The Belvedere
    Chelsea Harbour
    SW10 0XA London
    British61513170002
    DAMAS, Philippe Georges
    Flat 44e Queensgate
    South Kensington
    SW7 5HR London
    Administrateur
    Flat 44e Queensgate
    South Kensington
    SW7 5HR London
    Belgian74605530002
    DUFFY, David Joseph
    99 Barrowgate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    Administrateur
    99 Barrowgate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    Irish57821550001
    GERAGHTY, Peter Richard
    Home Green Heath House Road
    Worplesden Hill
    GU22 0QU Woking
    Surrey
    Administrateur
    Home Green Heath House Road
    Worplesden Hill
    GU22 0QU Woking
    Surrey
    American41665450002
    GOLD, Nicholas Roger
    14 Northumberland Place
    W2 5BS London
    Administrateur
    14 Northumberland Place
    W2 5BS London
    EnglandBritish9074820001
    GRIJNS, Leendert Cornelis
    20 Fox Run Lane
    Greenwich Ct 06831
    Usa
    Administrateur
    20 Fox Run Lane
    Greenwich Ct 06831
    Usa
    Dutch42483680001
    HORTON, David Andrew
    18 Vine Court Road
    TN13 3UY Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    18 Vine Court Road
    TN13 3UY Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish77332870001
    JOHNSON, Roy Douglas Trevor
    52 Baas Lane
    EN10 7EL Broxbourne
    Hertfordshire
    Administrateur
    52 Baas Lane
    EN10 7EL Broxbourne
    Hertfordshire
    British8333500001
    JULIUS, Russell
    65 Clifton Hill
    NW8 0JN London
    Administrateur
    65 Clifton Hill
    NW8 0JN London
    British66795040002
    LE MAY, Malcolm John
    Upham House
    SO32 1JH Upham
    Hampshire
    Administrateur
    Upham House
    SO32 1JH Upham
    Hampshire
    United KingdomBritish43422720003
    LINDENBERGH, Jan Hessel Marie
    Burg Den Texlaan 17
    211 Cb Aerdenhout
    FOREIGN Ps0257292
    Netherlands
    Administrateur
    Burg Den Texlaan 17
    211 Cb Aerdenhout
    FOREIGN Ps0257292
    Netherlands
    Dutch54024850001
    MALPAS, Richard
    Flat 8
    2-3 Lyall Street
    SW1X 8DW London
    Administrateur
    Flat 8
    2-3 Lyall Street
    SW1X 8DW London
    EnglandBritish79895540001
    MATHRANI, Arjun Kumar
    Flat 9d Thorney Court
    Palace Gate
    W8 London
    Administrateur
    Flat 9d Thorney Court
    Palace Gate
    W8 London
    American56651610002
    PALMER, Jeremy David Fletcher
    Knowle Hill House Knowl Hill
    Kingsclere
    RG20 4NY Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Knowle Hill House Knowl Hill
    Kingsclere
    RG20 4NY Newbury
    Berkshire
    British74889370002
    REYNOLDS, John Stewart
    30 Jocelyn Road
    TW9 2TH Richmond
    Surrey
    Administrateur
    30 Jocelyn Road
    TW9 2TH Richmond
    Surrey
    British53171720001
    RICHARDS, Stephen Graham
    47 Kyrle Road
    SW11 6BB London
    Administrateur
    47 Kyrle Road
    SW11 6BB London
    United KingdomBritish89834270001
    ROBINS, David Anthony
    Fairacre Camden Park Road
    BR7 5HF Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    Fairacre Camden Park Road
    BR7 5HF Chislehurst
    Kent
    British63126420001
    SHAKESHAFT, John Charles
    49 Woodwarde Road
    SE22 8UN London
    Administrateur
    49 Woodwarde Road
    SE22 8UN London
    British39532800001
    SPROUL, William Edward
    6 Lammas Lane
    KT10 8NY Esher
    Surrey
    Administrateur
    6 Lammas Lane
    KT10 8NY Esher
    Surrey
    EnglandBritish88445440001

    ING (LONDON) (NO.11) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security deed
    Créé le 27 févr. 2001
    Livré le 08 mars 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in connection with the facility agreement (as defined) and/or the security deed or monies due from any group company
    Brèves mentions
    All sums and payments received in respect of any transfer or debit and all rights,title and interest standing to the credit of the controlled accounts,as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank Na
    Transactions
    • 08 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Custody agreement
    Créé le 14 oct. 1996
    Livré le 30 oct. 1996
    En cours
    Montant garanti
    In favour of the chargee all charges relating to the administration and safekeeping of the accounts opened by the company with the chargee pursuant to the custody agreement (including without limitation any extension of credit separately agreed upon to facilitate securities settlement)
    Brèves mentions
    All the cash from time to time in the cash account described in clause 3, of the custody agreement, all the shares, stocks, bonds, notes, debentures, or other securities held from time to time for the account of ing baring securities limited by banque paribas - head office pursuant to the custody agreement.
    Personnes ayant droit
    • Banque Paribas
    Transactions
    • 30 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Custody agreement
    Créé le 14 oct. 1996
    Livré le 30 oct. 1996
    En cours
    Montant garanti
    In favour of the chargee all charges relating to the administration and safekeeping of the accounts opened by the company with the chargee pursuant to the custody agreement (including without limitation any extension of credit separately agreed upon to facilitate securities settlement)
    Brèves mentions
    All the cash from time to time in the cash account described in clause 3, of the custody agreement, all the shares, stocks, bonds, notes, debentures, or other securities held from time to time for the account of ing baring securities limited by banque paribas - madrid office pursuant to the custody agreement.
    Personnes ayant droit
    • Banque Paribas
    Transactions
    • 30 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Custody agreement
    Créé le 14 oct. 1996
    Livré le 30 oct. 1996
    En cours
    Montant garanti
    In favour of the chargee all charges relating to the administration and safekeeping of the accounts opened by the company with the chargee pursuant to the custody agreement (including without limitation any extension of credit separately agreed upon to facilitate securities settlement)
    Brèves mentions
    All the cash from time to time in the cash account described in clause 3, of the custody agreement, all the shares, stocks, bonds, notes, debentures, or other securities held from time to time for the account of ing baring securities limited by morgan guaranty trust company of new york pursuant to the custody agreement.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transactions
    • 30 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Collateral agreement
    Créé le 21 avr. 1995
    Livré le 26 avr. 1995
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All "collateral" including in particular cash and securities clearance accounts opened in connection with the euroclear system by the brussels office of the chargee on its books in the name of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transactions
    • 26 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    General loan and security agreement
    Créé le 22 mars 1995
    Livré le 28 mars 1995
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    And and all definitive and/or depository securities held in the account and any cash balances held in any demand deposit account maintained by the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of New York
    Transactions
    • 28 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    Securities clearing agreement
    Créé le 22 mars 1995
    Livré le 28 mars 1995
    En cours
    Montant garanti
    The repayment of the loans, the interest thereon and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the agreement
    Brèves mentions
    Any and all definitive and depository securities held in the account and any and all cash balances deposited in the account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of New York
    Transactions
    • 28 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    Charge in favour of the international stock exchange of the united kingdom and the republic of ireland limited
    Créé le 10 mars 1995
    Livré le 11 mars 1995
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All shares, stock and other securities of any description which are for the time being designated by the london stock exchange as talisman securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The International Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland Limited
    Transactions
    • 11 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0