PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED

PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03024878
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Devon Lodge
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MERCANTILE LEASING COMPANY (NO.162) LIMITED22 févr. 199522 févr. 1995

    Quels sont les derniers comptes de PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 févr. 2015

    État du capital au 23 févr. 2015

    • Capital: GBP 102
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de Beechfield House Winterton Way Lyme Green Business Park Macclesfield Cheshire SK11 0LP à Devon Lodge Iddesleigh Winkleigh Devon EX19 8BE le 09 févr. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 mars 2014

    État du capital au 04 mars 2014

    • Capital: GBP 102
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Miss Jane Elizabeth Ruston le 01 janv. 2013

    1 pagesCH03

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2012

    4 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * Suite 14 Beechfield House Winterton Way Lyme Green Business Pk, Macclesfield, Cheshire SK11 0LP* le 04 déc. 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2011

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Peter Beale en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Peter Anthony Martin Dillon en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2008

    5 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 mars 2007

    5 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages190

    Qui sont les dirigeants de PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RUSTON, Jane Elizabeth
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon Lodge
    Devon
    England
    Secrétaire
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon Lodge
    Devon
    England
    British70986180008
    DILLON, Peter Anthony Martin
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon Lodge
    Devon
    England
    Administrateur
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon Lodge
    Devon
    England
    United KingdomBritish129983290001
    LEATHER, Jonathan Terence
    57 The Crofts
    Hatch Warren
    RG22 4RE Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    57 The Crofts
    Hatch Warren
    RG22 4RE Basingstoke
    Hampshire
    British69140360001
    SCOTT, Elizabeth Mary
    8 Belvidere Road
    WS1 3AU Walsall
    Secrétaire
    8 Belvidere Road
    WS1 3AU Walsall
    British76715280003
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Secrétaire
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Secrétaire
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001
    EVER 1993 LIMITED
    International Headquarters
    Longbridge
    B31 2TB Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    International Headquarters
    Longbridge
    B31 2TB Birmingham
    West Midlands
    88822950001
    BEALE, Peter Robert
    Dunhampstead House
    Dunhampstead
    WR9 7JX Droitwich Spa
    West Midlands
    Administrateur
    Dunhampstead House
    Dunhampstead
    WR9 7JX Droitwich Spa
    West Midlands
    United KingdomBritish25365060002
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    British47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Administrateur
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritish2444200001
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Administrateur
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    British46728970001
    LEATHER, Jonathan Terence
    47 Firecrest Road
    Kempshott
    RG22 5UL Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    47 Firecrest Road
    Kempshott
    RG22 5UL Basingstoke
    Hampshire
    British69140360002
    MCCORMICK, Kevin
    7 Laidlaw Close
    Talbot Village Wallisdown
    BH12 5EW Poole
    Dorset
    Administrateur
    7 Laidlaw Close
    Talbot Village Wallisdown
    BH12 5EW Poole
    Dorset
    British14860030001
    MCMILLAN, Richard John
    17 Hawthorn Close
    Colden Common
    SO21 1UX Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    17 Hawthorn Close
    Colden Common
    SO21 1UX Winchester
    Hampshire
    British68601920001
    PATTERSON, Mark Allan
    6 Vespasian Gardens
    RG24 9SH Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    6 Vespasian Gardens
    RG24 9SH Basingstoke
    Hampshire
    British71785630001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    British49237910001
    ROWBERRY, Duncan John
    2 Morris Rise
    Chineham
    RG24 8LD Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    2 Morris Rise
    Chineham
    RG24 8LD Basingstoke
    Hampshire
    British49237880002
    RUSTON, Jane Elizabeth
    4 Mainwaring Road
    Over Peover
    WA16 8TR Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    4 Mainwaring Road
    Over Peover
    WA16 8TR Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish70986180008
    SHAW, Robert Michael
    11 Westminster Road
    Branksome Park
    BH13 6JQ Poole
    Dorset
    Administrateur
    11 Westminster Road
    Branksome Park
    BH13 6JQ Poole
    Dorset
    EnglandBritish6887610001
    VAUGHAN, Phil
    Lexington
    Wyche Lane
    CW6 9PD Bunbury
    Cheshire
    Administrateur
    Lexington
    Wyche Lane
    CW6 9PD Bunbury
    Cheshire
    British35020290001
    WATSON, Hazel Anne Marie
    6 Abbotsmead Place
    Caversham
    RG4 8BB Reading
    Reading
    Administrateur
    6 Abbotsmead Place
    Caversham
    RG4 8BB Reading
    Reading
    British71785600001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    British40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Administrateur
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    British58523120001
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001
    BAROMETERS LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    57357300002

    PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Aircraft mortgage
    Créé le 01 avr. 2003
    Livré le 15 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    With full title guarantee all its interest, present and future, in and to: the aircraft and all technical records, together the mortgaged property;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 15 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of payments due under the group relief deed and certain payments of corporation tax
    Créé le 01 avr. 2003
    Livré le 11 avr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The assigned barclays property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (Acting for Itself and as Agent for Members of the Barclays Group) Andthomson Travel International Ag and Tui Northern Europe Limited
    Transactions
    • 11 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Fee account charge
    Créé le 01 avr. 2003
    Livré le 11 avr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies liabilities and obligations due or to become due from the company (formerly known as mercantile leasing company (no.162) limited to the chargee (as security trustee for the secured parties) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title and interest in and to the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Assignment of insurances
    Créé le 01 avr. 2003
    Livré le 09 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The assigned property absolutely by way of security. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 09 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security assignment
    Créé le 01 avr. 2003
    Livré le 09 avr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its rights, title and interest, present and future, in and to, or arising under or in respect of the assigned documents and all moneys whatsoever payable to the owner thereunder, including all claims for damages and compensation in respect of any breach thereof.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 09 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Account charge
    Créé le 01 avr. 2003
    Livré le 09 avr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title and interest in and to the deposit and all and any rights and benefits accruing to or arising in connection therewith.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0