PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03024878 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED ?
| Adresse du siège social | Devon Lodge Iddesleigh EX19 8BE Winkleigh Devon |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2014 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 4 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Beechfield House Winterton Way Lyme Green Business Park Macclesfield Cheshire SK11 0LP à Devon Lodge Iddesleigh Winkleigh Devon EX19 8BE le 09 févr. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Miss Jane Elizabeth Ruston le 01 janv. 2013 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2012 | 4 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Suite 14 Beechfield House Winterton Way Lyme Green Business Pk, Macclesfield, Cheshire SK11 0LP* le 04 déc. 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2011 | 4 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Beale en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Peter Anthony Martin Dillon en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2010 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2008 | 5 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 31 mars 2007 | 5 pages | AA | ||||||||||
legacy | 2 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 190 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSTON, Jane Elizabeth | Secrétaire | Iddesleigh EX19 8BE Winkleigh Devon Lodge Devon England | British | 70986180008 | ||||||
| DILLON, Peter Anthony Martin | Administrateur | Iddesleigh EX19 8BE Winkleigh Devon Lodge Devon England | United Kingdom | British | 129983290001 | |||||
| LEATHER, Jonathan Terence | Secrétaire | 57 The Crofts Hatch Warren RG22 4RE Basingstoke Hampshire | British | 69140360001 | ||||||
| SCOTT, Elizabeth Mary | Secrétaire | 8 Belvidere Road WS1 3AU Walsall | British | 76715280003 | ||||||
| SHOOLBRED, Charles Frederick | Secrétaire | Timbers Dean Oak Lane RH2 8PZ Leigh Surrey | British | 540290002 | ||||||
| BARCOSEC LIMITED | Secrétaire | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | 49004930001 | |||||||
| EVER 1993 LIMITED | Secrétaire | International Headquarters Longbridge B31 2TB Birmingham West Midlands | 88822950001 | |||||||
| BEALE, Peter Robert | Administrateur | Dunhampstead House Dunhampstead WR9 7JX Droitwich Spa West Midlands | United Kingdom | British | 25365060002 | |||||
| BOOBYER, Christopher Leslie Richard | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 92233050001 | ||||||
| BOX, Sarah | Administrateur | Court Lodge Lower Road West Farleigh ME15 0PD Maidstone Kent | British | 47381630004 | ||||||
| CALLENDER, John Dalrymple | Administrateur | Fairway Heights GU15 1NJ Camberley 14 Surrey | United Kingdom | British | 2444200001 | |||||
| DOWDING, Eric Robert | Administrateur | 23 Waldorf Heights Blackwater Howley Hill GU17 9JH Camberley Surrey | British | 46728970001 | ||||||
| LEATHER, Jonathan Terence | Administrateur | 47 Firecrest Road Kempshott RG22 5UL Basingstoke Hampshire | British | 69140360002 | ||||||
| MCCORMICK, Kevin | Administrateur | 7 Laidlaw Close Talbot Village Wallisdown BH12 5EW Poole Dorset | British | 14860030001 | ||||||
| MCMILLAN, Richard John | Administrateur | 17 Hawthorn Close Colden Common SO21 1UX Winchester Hampshire | British | 68601920001 | ||||||
| PATTERSON, Mark Allan | Administrateur | 6 Vespasian Gardens RG24 9SH Basingstoke Hampshire | British | 71785630001 | ||||||
| ROWAN, Charles Paul | Administrateur | 32 Queens Park West Drive Queens Park BH8 9DD Bournemouth Dorset | British | 49237910001 | ||||||
| ROWBERRY, Duncan John | Administrateur | 2 Morris Rise Chineham RG24 8LD Basingstoke Hampshire | British | 49237880002 | ||||||
| RUSTON, Jane Elizabeth | Administrateur | 4 Mainwaring Road Over Peover WA16 8TR Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 70986180008 | |||||
| SHAW, Robert Michael | Administrateur | 11 Westminster Road Branksome Park BH13 6JQ Poole Dorset | England | British | 6887610001 | |||||
| VAUGHAN, Phil | Administrateur | Lexington Wyche Lane CW6 9PD Bunbury Cheshire | British | 35020290001 | ||||||
| WATSON, Hazel Anne Marie | Administrateur | 6 Abbotsmead Place Caversham RG4 8BB Reading Reading | British | 71785600001 | ||||||
| WEAL, Barry | Administrateur | Orchard Gate Mill Lane Bramley GU5 0HW Guildford Surrey | British | 40203100001 | ||||||
| WEAVING, John Martin | Administrateur | 57 Bridle Way Colehill BH21 2UP Wimborne Dorset | British | 58523120001 | ||||||
| BARCOSEC LIMITED | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | 49004930001 | |||||||
| BAROMETERS LIMITED | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | 57357300002 |
PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft mortgage | Créé le 01 avr. 2003 Livré le 15 mai 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee and any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions With full title guarantee all its interest, present and future, in and to: the aircraft and all technical records, together the mortgaged property;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignment of payments due under the group relief deed and certain payments of corporation tax | Créé le 01 avr. 2003 Livré le 11 avr. 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The assigned barclays property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fee account charge | Créé le 01 avr. 2003 Livré le 11 avr. 2003 | En cours | Montant garanti All monies liabilities and obligations due or to become due from the company (formerly known as mercantile leasing company (no.162) limited to the chargee (as security trustee for the secured parties) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All its right title and interest in and to the deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignment of insurances | Créé le 01 avr. 2003 Livré le 09 avr. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The assigned property absolutely by way of security. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security assignment | Créé le 01 avr. 2003 Livré le 09 avr. 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All its rights, title and interest, present and future, in and to, or arising under or in respect of the assigned documents and all moneys whatsoever payable to the owner thereunder, including all claims for damages and compensation in respect of any breach thereof. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Account charge | Créé le 01 avr. 2003 Livré le 09 avr. 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All its right title and interest in and to the deposit and all and any rights and benefits accruing to or arising in connection therewith. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0