THE BRICK BUSINESS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE BRICK BUSINESS LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03029861
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE BRICK BUSINESS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe THE BRICK BUSINESS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE BRICK BUSINESS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DENTON SANDOWN LIMITED01 mars 199501 mars 1995

    Quels sont les derniers comptes de THE BRICK BUSINESS LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2017
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2018
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE BRICK BUSINESS LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au17 déc. 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation31 déc. 2017
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au17 déc. 2016
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour THE BRICK BUSINESS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 oct. 2024

    8 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 oct. 2023

    8 pagesLIQ03

    Cessation de la nomination de Paul Stevenson en tant que directeur le 02 mars 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 oct. 2022

    7 pagesLIQ03

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:Secretary of state release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 oct. 2021

    8 pagesLIQ03

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    13 pagesLIQ10

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    15 pages600

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 oct. 2020

    7 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 oct. 2019

    7 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 oct. 2018

    7 pagesLIQ03

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 26 oct. 2017

    LRESSP

    Nomination de Mr Keith Stuart Barker en tant qu'administrateur le 01 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Harald Anton Schwarzmayr en tant que directeur le 01 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 janv. 2016

    État du capital au 12 janv. 2016

    • Capital: GBP 900,002
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Harald Anton Schwarzmayr le 01 févr. 2011

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 janv. 2015

    État du capital au 14 janv. 2015

    • Capital: GBP 900,002
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Harald Anton Schwarzmayr le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Michael Grace en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de THE BRICK BUSINESS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GRACE, Michael
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    Secrétaire
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    188990920001
    BARKER, Keith Stuart
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    Administrateur
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    EnglandBritishManaging Director110773520001
    ALLY, Bibi Rahima
    68 Ruskin Road
    SM5 3DH Carshalton
    Surrey
    Secrétaire
    68 Ruskin Road
    SM5 3DH Carshalton
    Surrey
    British38963210001
    FEW, Kaye Suzanne
    14 Bean Leach Avenue
    Offerton
    SK2 5JA Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    14 Bean Leach Avenue
    Offerton
    SK2 5JA Stockport
    Cheshire
    BritishAccountant119910110001
    RICHARDS, Wayne
    Spring Cottage
    Park Lane Boarshurst
    OL3 7DZ Greenfield
    Saddleworth
    Secrétaire
    Spring Cottage
    Park Lane Boarshurst
    OL3 7DZ Greenfield
    Saddleworth
    BritishFinancial Director27757990002
    ATTRILL, Christopher Richard
    9 The Chines
    Delamere Park
    CW8 2XA Cuddington
    Cheshire
    Administrateur
    9 The Chines
    Delamere Park
    CW8 2XA Cuddington
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director93024670001
    BODDY, Martyn
    Ladyswood 47 Woodside Lane
    Poynton
    SK12 1BB Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    Ladyswood 47 Woodside Lane
    Poynton
    SK12 1BB Stockport
    Cheshire
    BritishCorporate Financier108596990001
    BROWN, John Forster
    7 Hurst Avenue
    N6 5TX London
    Administrateur
    7 Hurst Avenue
    N6 5TX London
    United KingdomBritishCompany Director4183480002
    COLLETT, Brian
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    Administrateur
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    BritishCompany Director32267100002
    FORBES, Gerard James
    22 Frampton Close
    Middleton
    M24 1PF Manchester
    Administrateur
    22 Frampton Close
    Middleton
    M24 1PF Manchester
    BritishCompany Director42936480002
    FROST, Neil Ernest
    2 Eccles Close
    Whaley Bridge
    SK12 7RS Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    2 Eccles Close
    Whaley Bridge
    SK12 7RS Stockport
    Cheshire
    BritishCompany Director28520400002
    FURR, Patrick Charles
    Edenbridge Close
    Weston
    CW2 5QU Crewe
    8
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Edenbridge Close
    Weston
    CW2 5QU Crewe
    8
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishCommercial Director129981870001
    HANNIDES, George Michael
    7 Great North Rd
    Brookmans Park
    AL96AB Hatfield
    Hertfordshire
    Administrateur
    7 Great North Rd
    Brookmans Park
    AL96AB Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director127571820001
    JACKSON, John Andrew
    17 Crossfield Road
    Hale
    WA15 8DU Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    17 Crossfield Road
    Hale
    WA15 8DU Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector24857510001
    KIELY, Brian David
    17 Hawthorn Lane
    Ashton-On-Mersey
    M33 5WW Sale
    Cheshire
    Administrateur
    17 Hawthorn Lane
    Ashton-On-Mersey
    M33 5WW Sale
    Cheshire
    BritishAccountant99921060001
    KOEKOEK, Bert Jan
    Bernhardstraat 11
    4175 Ed Haaften
    The Netherlands
    Administrateur
    Bernhardstraat 11
    4175 Ed Haaften
    The Netherlands
    NetherlandsDutchC E O119912460001
    LANGMUIR, Hugh Macgillivray
    14 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    Administrateur
    14 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    BritishCompany Director42365820001
    MARGRAVE, Philip John
    9 Marquis Way
    Aldwick
    PO21 4AT Bognor Regis
    West Sussex
    Administrateur
    9 Marquis Way
    Aldwick
    PO21 4AT Bognor Regis
    West Sussex
    EnglandBritishCompany Director51493580001
    REDFERN, Stuart William
    49 Drummond Way
    SK10 4XJ Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    49 Drummond Way
    SK10 4XJ Macclesfield
    Cheshire
    BritishProduction Director76159410002
    RICHARDS, Wayne
    9 Platting Road
    Lydgate
    OL4 4DL Oldham
    Lancashire
    Administrateur
    9 Platting Road
    Lydgate
    OL4 4DL Oldham
    Lancashire
    BritishAccountant27757990001
    RICHARDS, Wayne
    9 Platting Road
    Lydgate
    OL4 4DL Oldham
    Lancashire
    Administrateur
    9 Platting Road
    Lydgate
    OL4 4DL Oldham
    Lancashire
    BritishCompany Secretary27757990001
    ROBERTS, Gareth Wynford Lewis
    7 Nene Lane
    NN12 6YN Towcester
    Northamptonshire
    Administrateur
    7 Nene Lane
    NN12 6YN Towcester
    Northamptonshire
    BritishBusiness Development Director81203280001
    SANDFORD, John Martin
    25 Newstead Close
    Poynton
    SK12 1ES Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    25 Newstead Close
    Poynton
    SK12 1ES Stockport
    Cheshire
    BritishCompany Director14927950001
    SCHEUCH, Heimo
    Avenue Des Courses 20
    FOREIGN Brussels
    1050
    Belgium
    Administrateur
    Avenue Des Courses 20
    FOREIGN Brussels
    1050
    Belgium
    AustriaAustrianChief Operating Officer100521050001
    SCHWARZMAYR, Harald Anton
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    Administrateur
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    United KingdomAustrianManaging Director103815020002
    STEVENSON, Paul
    10 Hill Top Grove
    West Ardsley
    WF3 1HP Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    10 Hill Top Grove
    West Ardsley
    WF3 1HP Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director113293590001
    VAN RIET, Willy Marie Jean
    Leeuwerikenlaan 14
    Dendermonde
    9200
    Belgium
    Administrateur
    Leeuwerikenlaan 14
    Dendermonde
    9200
    Belgium
    BelgianDirector100527520001
    WELHAM, John Harry
    Mayfield Runshaw Lane
    Euxton
    PR7 6HB Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    Mayfield Runshaw Lane
    Euxton
    PR7 6HB Chorley
    Lancashire
    BritishCompany Director27761560002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE BRICK BUSINESS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Brooks Drive
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3SA Cheadle
    Wienerberger House
    Cheshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Brooks Drive
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3SA Cheadle
    Wienerberger House
    Cheshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueUnlimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3028184
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    THE BRICK BUSINESS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 28 nov. 2003
    Livré le 05 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Property being all the mineral beds of brickshale within an area of land containing 67.28 hectares or thereabouts situate at todhills brickworks, todhills, county durham comprised in a lease dated 28 november between (1) the church commissioners for endgland and (2) the company; for details of further property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 oct. 2003
    Livré le 04 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money or liabilities due owing or incurred to any secured party by any charging company or any other obligor at present or in the future in any manner whether actual or contingent together with interest
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 mars 2002
    Livré le 06 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    Transactions
    • 06 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Amending deed (relating to a composite guarantee and debenture originally dated 20TH march 1995 "the guarantee and debenture")
    Créé le 07 nov. 1997
    Livré le 20 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the facility agreement, the finance documents (or any of them), the hedging agreements (or any of them) and the guarantee and debenture
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trust Companyas Security Trustee for Itself and the Other Finance Parties (As Defined)
    Transactions
    • 20 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Amending deed
    Créé le 22 sept. 1997
    Livré le 08 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the facility agreement, the finance documents, the hedging agreements and the guarantee & debenture or any of them
    Brèves mentions
    All book and other debts all assets property goodwill and undertaking from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trust Company
    Transactions
    • 08 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 20 mars 1995
    Livré le 23 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from brickbuilt limited and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the term loan and revolving credit agreement dated 20TH march 1995 pursuant to which the chargees agreed to make available a term loan of £28,000,000 and a revolving credit facility of up to £4,000,000 to the company (the "facility agreement"), the finance documents, the hedging agreements and this deed in any currency or currencies whether present or future
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trust Companyas Security Trustee for Itself and the Other Finance Parties (As Defined)
    Transactions
    • 23 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 04 mars 1995
    Livré le 06 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or brickbuilt limited to the chargee under the terms of the facility agreement dated 3RD march 1995 or any collateral instrument
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cinven Limited
    Transactions
    • 06 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    THE BRICK BUSINESS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 oct. 2017Commencement of winding up
    22 sept. 2017Declaration of solvency sworn on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Emma Cray
    Central Square, 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    practitioner
    Central Square, 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0