MVM HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMVM HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03033447
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MVM HOLDINGS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe MVM HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MVM HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OVAL (980) LIMITED15 mars 199515 mars 1995

    Quels sont les derniers comptes de MVM HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour MVM HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4NW à 15 Canada Square London E14 5GL le 03 juil. 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 10 juin 2019

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 15 mars 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 30 avr. 2018

    2 pagesAA

    Période comptable actuelle raccourcie du 30 avr. 2019 au 31 mars 2019

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Ian Michael Noble en tant que directeur le 06 août 2018

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen James Callaghan le 06 août 2018

    2 pagesCH01

    legacy

    5 pagesRP04CS01

    Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 15 mars 2016

    21 pagesRP04AR01

    Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 15 mars 2015

    21 pagesRP04AR01

    Déclaration de confirmation établie le 15 mars 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 30 avr. 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 mars 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01
    Annotations
    DateAnnotation
    16 avr. 2018Clarification A second filed CS01 (statement of capital change) was registered on 16/04/2018.

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2016

    5 pagesAA

    Nomination de Ian Michael Noble en tant qu'administrateur le 06 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Coll en tant que directeur le 06 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen James Callaghan en tant qu'administrateur le 10 oct. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David John Meaden en tant que directeur le 10 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 avr. 2016

    État du capital au 11 avr. 2016

    • Capital: GBP 2,524,850
    SH01
    Annotations
    DateAnnotation
    16 avr. 2018Clarification A second filed AR01 was registered on 16/04/2018.

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 mars 2015

    État du capital au 16 mars 2015

    • Capital: GBP 2,524,850
    SH01
    Annotations
    DateAnnotation
    16 avr. 2018Clarification A second filed AR01 was registered on 16/04/2018.

    Qui sont les dirigeants de MVM HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish201347710052
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Secrétaire
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Secrétaire
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    MACHIN, Brian Roy
    6 Redland Green Road
    Redland
    BS6 7HE Bristol
    Secrétaire
    6 Redland Green Road
    Redland
    BS6 7HE Bristol
    British8982230001
    NUNN, Carol Jayne
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British101872040001
    RICHARDSON, John David
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    Secrétaire
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    British128558470001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Secrétaire
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Secrétaire désigné
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican165900220001
    CLIFTON, Philip John
    The Dovecote
    Church Street
    LE15 8JR North Luffenham
    Rutland
    Administrateur
    The Dovecote
    Church Street
    LE15 8JR North Luffenham
    Rutland
    British60585520003
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish237260100001
    ECKFORD, Alan Tony
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    Administrateur
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    United KingdomBritish49014470001
    GREENLAND, Martyn Geoffrey
    11 York Road
    GL20 5HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    Administrateur
    11 York Road
    GL20 5HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    British45440250001
    HARLEY, Donald Wilson George
    22 Saint Marys Park
    SG8 7XB Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    22 Saint Marys Park
    SG8 7XB Royston
    Hertfordshire
    British80358920001
    HOLDSWORTH, Roderick Antony
    Neale
    Lewes Road, Scaynes Hill
    RH17 7NG Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Neale
    Lewes Road, Scaynes Hill
    RH17 7NG Haywards Heath
    West Sussex
    EnglandBritish98217960001
    MACHIN, Brian Roy
    Drylaw Cottage
    Cote Drive
    BS9 3UP Bristol
    Administrateur
    Drylaw Cottage
    Cote Drive
    BS9 3UP Bristol
    British8982230003
    MACHIN, Patricia Joan
    6 Redland Green Road
    BS6 7HE Bristol
    Avon
    Administrateur
    6 Redland Green Road
    BS6 7HE Bristol
    Avon
    British63856450001
    MARKHAM, Jill Anthea
    3 Ivywell Road
    BS9 1NX Bristol
    Avon
    Administrateur
    3 Ivywell Road
    BS9 1NX Bristol
    Avon
    British46788850002
    MARKHAM, Richard John
    Castle Cote 3 Ivywell Road
    Sneyd Park
    BS9 1NX Bristol
    Avon
    Administrateur
    Castle Cote 3 Ivywell Road
    Sneyd Park
    BS9 1NX Bristol
    Avon
    United KingdomBritish35544120002
    MARTIN, Joseph Michael
    8 Mill View School Lane
    Eaton Socon
    PE19 3HJ St Neots
    Cambridgeshire
    Administrateur
    8 Mill View School Lane
    Eaton Socon
    PE19 3HJ St Neots
    Cambridgeshire
    British1092550002
    MEADEN, David John
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish193740420001
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish199843940001
    PETTIFOR, Timothy John
    Treetops 47 Caxton End
    Eltisley
    PE19 4TJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Treetops 47 Caxton End
    Eltisley
    PE19 4TJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish40366940001
    RUDD, Jeremy George Winterton
    Manor Farm
    Lower Lemington
    GL56 9NP Moreton In Marsh
    Administrateur
    Manor Farm
    Lower Lemington
    GL56 9NP Moreton In Marsh
    United KingdomBritish74891640002
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66955690003
    TYDEMAN, David Rolfe
    Burton Grange
    BA12 6BR Burton
    Wiltshire
    Administrateur
    Burton Grange
    BA12 6BR Burton
    Wiltshire
    United KingdomBritish123730690001
    VENN, Jon
    North Hill Cottage East Dundry Lane
    Dundry
    BS41 8NJ Bristol
    Administrateur
    North Hill Cottage East Dundry Lane
    Dundry
    BS41 8NJ Bristol
    British15778460001
    VENN, Vicki Caroline
    North Hill Cottage
    East Dundry Lane
    BS18 8NT Bristol
    Administrateur
    North Hill Cottage
    East Dundry Lane
    BS18 8NT Bristol
    British23230700001
    OVAL NOMINEES LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Administrateur désigné
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002560001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Administrateur désigné
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MVM HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement00968498
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    MVM HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of accession
    Créé le 29 avr. 2008
    Livré le 12 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from that charging company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transactions
    • 12 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 11 mai 2007
    Livré le 23 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 30 sept. 1997
    Livré le 06 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MVM HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 juin 2019Commencement of winding up
    12 août 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0