MVM HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MVM HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03033447 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MVM HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MVM HOLDINGS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 avr. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour MVM HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 6 pages | LIQ13 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4NW à 15 Canada Square London E14 5GL le 03 juil. 2019 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 mars 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 30 avr. 2018 | 2 pages | AA | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 30 avr. 2019 au 31 mars 2019 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Michael Noble en tant que directeur le 06 août 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen James Callaghan le 06 août 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
legacy | 5 pages | RP04CS01 | ||||||||||
Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 15 mars 2016 | 21 pages | RP04AR01 | ||||||||||
Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 15 mars 2015 | 21 pages | RP04AR01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 mars 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 30 avr. 2017 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 mars 2017 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2016 | 5 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Ian Michael Noble en tant qu'administrateur le 06 déc. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Coll en tant que directeur le 06 déc. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stephen James Callaghan en tant qu'administrateur le 10 oct. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David John Meaden en tant que directeur le 10 oct. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de MVM HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom |
| 76579530001 | ||||||||||
| CALLAGHAN, Stephen James | Administrateur | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 201347710052 | |||||||||
| FOX, Jacqueline Elizabeth | Secrétaire | Little Dormers 3 Wicken Road CB11 3QD Newport Essex | British | 35460890004 | ||||||||||
| GILLEN, Seamus Joseph | Secrétaire | 20 Mountway EN6 1EP Potters Bar Hertfordshire | British | 66174560001 | ||||||||||
| MACHIN, Brian Roy | Secrétaire | 6 Redland Green Road Redland BS6 7HE Bristol | British | 8982230001 | ||||||||||
| NUNN, Carol Jayne | Secrétaire | Boundary Way HP2 7HU Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 101872040001 | ||||||||||
| RICHARDSON, John David | Secrétaire | High Street Burnham SL1 7JD Slough 27 Berks | British | 128558470001 | ||||||||||
| SCHENCK, Daniel William | Secrétaire | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | Usa | 181204960001 | ||||||||||
| SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George | Secrétaire | Red Tiles 62 Park Road GU22 7DB Woking Surrey | British | 143104990001 | ||||||||||
| TURNER, David Charles | Secrétaire | 13 Thorndales St Johns Avenue CM14 5DE Brentwood Essex | Other | 84007940001 | ||||||||||
| OVALSEC LIMITED | Secrétaire désigné | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 | |||||||||||
| AL-SALEH, Adel Bedry | Administrateur | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | United States | American | 165900220001 | |||||||||
| CLIFTON, Philip John | Administrateur | The Dovecote Church Street LE15 8JR North Luffenham Rutland | British | 60585520003 | ||||||||||
| COLL, Andrew | Administrateur | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 237260100001 | |||||||||
| ECKFORD, Alan Tony | Administrateur | 53 Temple Mill Island Bisham SL7 1SQ Marlow Berkshire | United Kingdom | British | 49014470001 | |||||||||
| GREENLAND, Martyn Geoffrey | Administrateur | 11 York Road GL20 5HX Tewkesbury Gloucestershire | British | 45440250001 | ||||||||||
| HARLEY, Donald Wilson George | Administrateur | 22 Saint Marys Park SG8 7XB Royston Hertfordshire | British | 80358920001 | ||||||||||
| HOLDSWORTH, Roderick Antony | Administrateur | Neale Lewes Road, Scaynes Hill RH17 7NG Haywards Heath West Sussex | England | British | 98217960001 | |||||||||
| MACHIN, Brian Roy | Administrateur | Drylaw Cottage Cote Drive BS9 3UP Bristol | British | 8982230003 | ||||||||||
| MACHIN, Patricia Joan | Administrateur | 6 Redland Green Road BS6 7HE Bristol Avon | British | 63856450001 | ||||||||||
| MARKHAM, Jill Anthea | Administrateur | 3 Ivywell Road BS9 1NX Bristol Avon | British | 46788850002 | ||||||||||
| MARKHAM, Richard John | Administrateur | Castle Cote 3 Ivywell Road Sneyd Park BS9 1NX Bristol Avon | United Kingdom | British | 35544120002 | |||||||||
| MARTIN, Joseph Michael | Administrateur | 8 Mill View School Lane Eaton Socon PE19 3HJ St Neots Cambridgeshire | British | 1092550002 | ||||||||||
| MEADEN, David John | Administrateur | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 193740420001 | |||||||||
| NOBLE, Ian Michael | Administrateur | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 199843940001 | |||||||||
| PETTIFOR, Timothy John | Administrateur | Treetops 47 Caxton End Eltisley PE19 4TJ Huntingdon Cambridgeshire | United Kingdom | British | 40366940001 | |||||||||
| RUDD, Jeremy George Winterton | Administrateur | Manor Farm Lower Lemington GL56 9NP Moreton In Marsh | United Kingdom | British | 74891640002 | |||||||||
| STIER, John Robert | Administrateur | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 78901530003 | |||||||||
| STONE, Christopher Michael Renwick | Administrateur | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 66955690003 | |||||||||
| TYDEMAN, David Rolfe | Administrateur | Burton Grange BA12 6BR Burton Wiltshire | United Kingdom | British | 123730690001 | |||||||||
| VENN, Jon | Administrateur | North Hill Cottage East Dundry Lane Dundry BS41 8NJ Bristol | British | 15778460001 | ||||||||||
| VENN, Vicki Caroline | Administrateur | North Hill Cottage East Dundry Lane BS18 8NT Bristol | British | 23230700001 | ||||||||||
| OVAL NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002560001 | |||||||||||
| OVALSEC LIMITED | Administrateur désigné | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MVM HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northgate Public Services (Uk) Limited | 06 avr. 2016 | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
MVM HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession | Créé le 29 avr. 2008 Livré le 12 mai 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from that charging company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security agreement | Créé le 11 mai 2007 Livré le 23 mai 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 30 sept. 1997 Livré le 06 oct. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
MVM HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0