MILESTONE CAPITAL SERVICES LIMITED

MILESTONE CAPITAL SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMILESTONE CAPITAL SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03034069
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MILESTONE CAPITAL SERVICES LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe MILESTONE CAPITAL SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    6th Floor 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MILESTONE CAPITAL SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MILESTONE CAPITAL PARTNERS LIMITED22 janv. 200722 janv. 2007
    EUROPEAN ACQUISITION CAPITAL LIMITED26 mai 199926 mai 1999
    EAC MANAGER LIMITED26 févr. 199626 févr. 1996
    DE FACTO 413 LIMITED16 mars 199516 mars 1995

    Quels sont les derniers comptes de MILESTONE CAPITAL SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour MILESTONE CAPITAL SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    14 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 avr. 2019

    13 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 04 avr. 2018

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    21 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 mai 2016

    État du capital au 12 mai 2016

    • Capital: GBP 1,605,000
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Baker Tilly Tax and Accounting Ltd 25 Farringdon Street London EC4A 4AB England à 6th Floor 25 Farringdon Street London EC4A 4AB le 11 mai 2016

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Clive William Robinson le 26 févr. 2016

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Erick Robert Maurice Rinner le 26 févr. 2016

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    15 pagesAA

    Cessation de la nomination de Paul William Dickson en tant que secrétaire le 01 juil. 2015

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de C/O Baker Tilly Tax and Audit Ltd 25 Farringdon Street London EC4A 4AB à C/O Baker Tilly Tax and Accounting Ltd 25 Farringdon Street London EC4A 4AB le 22 avr. 2015

    AD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 avr. 2015

    État du capital au 21 avr. 2015

    • Capital: GBP 1,605,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de MILESTONE CAPITAL SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RINNER, Erick Robert Maurice
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    6th Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    6th Floor
    United Kingdom
    United KingdomFrenchInvestment Banker73146550002
    ROBINSON, Clive William
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    6th Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    6th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishInvestment Banker13438180002
    DEAN, Julian Mark
    23 Marden Way
    GU31 4PW Petersfield
    Hampshire
    Secrétaire
    23 Marden Way
    GU31 4PW Petersfield
    Hampshire
    British47136600002
    DICKSON, Paul William
    c/o Baker Tilly Tax And Accounting Ltd
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    England
    Secrétaire
    c/o Baker Tilly Tax And Accounting Ltd
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    England
    BritishAccountant123619890002
    LAU, Cheong Koon
    40 Strongbow Road
    Eltham
    SE9 1DT London
    Secrétaire
    40 Strongbow Road
    Eltham
    SE9 1DT London
    MalaysianInvestment Banker16337610001
    ROBINSON, Clive William
    3 Beaumont Avenue
    TW9 2HE Richmond
    Surrey
    Secrétaire
    3 Beaumont Avenue
    TW9 2HE Richmond
    Surrey
    British13438180001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Secrétaire désigné
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001
    DEAN, Julian Mark
    23 Marden Way
    GU31 4PW Petersfield
    Hampshire
    Administrateur
    23 Marden Way
    GU31 4PW Petersfield
    Hampshire
    BritishAccountant47136600002
    DOWNES, Paul William Edwin
    Seven Acres
    Horsell Common
    GU21 4XY Woking
    Surrey
    Administrateur
    Seven Acres
    Horsell Common
    GU21 4XY Woking
    Surrey
    United KingdomBritishInvestment Banker18135910002
    HEATHCOTE, Jonathan Lister
    Pear Tree Farm
    Bradley Road Kirtling
    CB8 9JB Newmarket
    Suffolk
    Administrateur
    Pear Tree Farm
    Bradley Road Kirtling
    CB8 9JB Newmarket
    Suffolk
    United KingdomBritishInvestment Manager160333180001
    LAU, Cheong Koon
    40 Strongbow Road
    Eltham
    SE9 1DT London
    Administrateur
    40 Strongbow Road
    Eltham
    SE9 1DT London
    MalaysianInvestment Banker16337610001
    MASON, Robert Sturdee
    Blindwell House
    OX29 6PN North Leigh
    Oxfordshire
    Administrateur
    Blindwell House
    OX29 6PN North Leigh
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Director149738610001
    SACK, Adam David
    115 Broadhurst Gardens
    NW6 3BJ London
    Administrateur
    115 Broadhurst Gardens
    NW6 3BJ London
    BritishCompany Director32459700002
    WIEGMAN, Albert Edward Bernard
    17 Hills Avenue
    CB1 7UY Cambridge
    Administrateur
    17 Hills Avenue
    CB1 7UY Cambridge
    BritishInvestment Banker7466220002
    TRAVERS SMITH LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Administrateur désigné
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006090001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Administrateur désigné
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour MILESTONE CAPITAL SERVICES LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    04 mars 2017La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société.

    MILESTONE CAPITAL SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 26 févr. 2010
    Livré le 04 mars 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £61,064 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Rent deposit deed.
    Personnes ayant droit
    • Bbc Pension Trust Limited
    Transactions
    • 04 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 mars 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 04 avr. 2007
    Livré le 19 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge all its interest in the account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bbc Pension Trust Limited
    Transactions
    • 19 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 04 avr. 2007
    Livré le 18 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £51,950.00 plus £9,091.25 on account of vat due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    £51,950.00 plus £9,091.25 on account of vat.
    Personnes ayant droit
    • Bbc Pension Trust Limited
    Transactions
    • 18 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Third party debenture
    Créé le 10 déc. 2003
    Livré le 24 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money or liabilities due or to become due from the borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge over all investments and all corresponding distribution rights; the benefit of all consents and agreements and all rights and interests and claims under various agreements; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Singer & Friedlander Limited
    Transactions
    • 24 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Third party debenture
    Créé le 10 déc. 2003
    Livré le 24 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money or liabilities due or to become due from the borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge over all investments and all corresponding distribution rights; the benefit of all consents and agreements and all rights and interests and claims under various agreements; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Singer & Friedlander Limited
    Transactions
    • 24 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Third party debenture
    Créé le 10 déc. 2003
    Livré le 24 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money or liabilities due or to become due from the borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge over all investments and all corresponding distribution rights; the benefit of all consents and agreements and all rights and interests and claims under various agreements; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Singer & Friedlander Limited
    Transactions
    • 24 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 10 déc. 2003
    Livré le 24 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money or liabilities due or to become due from the borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge over all investments and all corresponding distribution rights; the benefit of all consents and agreements and all rights and interests and claims under various agreements; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Singer & Friedlander Limited
    Transactions
    • 24 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 mai 2003
    Livré le 22 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Singer & Friedlander Limited
    Transactions
    • 22 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over deposit
    Créé le 02 févr. 2001
    Livré le 13 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the guarantee (as defined) or under this charge
    Brèves mentions
    First fixed charge over the deposit (as defined) and all entitlements to interest and other rights/benefits thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fleet National Bank
    Transactions
    • 13 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MILESTONE CAPITAL SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 avr. 2018Commencement of winding up
    03 déc. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Matthew Robert Haw
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    practitioner
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Karen Ann Spears
    9th Floor, 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    practitioner
    9th Floor, 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0