RESTORE (WANSDYKE) LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRESTORE (WANSDYKE) LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03035562
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RESTORE (WANSDYKE) LTD ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe RESTORE (WANSDYKE) LTD ?

    Adresse du siège social
    Unit 5 Redhill Distribution Centre
    Salbrook Road
    RH1 5DY Redhill
    Surrey
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RESTORE (WANSDYKE) LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RESTORE LTD.20 mars 199520 mars 1995

    Quels sont les derniers comptes de RESTORE (WANSDYKE) LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour RESTORE (WANSDYKE) LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Mr Adam Thomas Councell en tant qu'administrateur le 18 juin 2012

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Harvey Jack Samson en tant que directeur le 18 juin 2012

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 avr. 2012

    État du capital au 17 avr. 2012

    • Capital: GBP 105,000
    SH01

    legacy

    11 pagesMG01

    Nomination de Mr Harvey Jack Samson en tant qu'administrateur le 26 sept. 2011

    3 pagesAP01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sarah Lesley Waudby le 18 août 2011

    1 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de Unit 2 Redhill Distribution Centre, Salbrook Road Redhill Surrey RH1 5DY le 18 août 2011

    1 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Approval of guarantee and debenture 20/06/2011
    RES13

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    11 pagesMG01

    legacy

    10 pagesMG01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    18 pagesAA

    Cessation de la nomination de Edmund Marshall en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Paul Smith en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    legacy

    5 pagesMG01

    Qui sont les dirigeants de RESTORE (WANSDYKE) LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WAUDBY, Sarah Lesley
    Redhill Distribution Centre
    Salbrook Road
    RH1 5DY Redhill
    Unit 5
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Redhill Distribution Centre
    Salbrook Road
    RH1 5DY Redhill
    Unit 5
    Surrey
    United Kingdom
    British148228620001
    CLARK, Neil Drummond
    Fengates Road
    RH1 6AH Redhill
    54
    Surrey
    Administrateur
    Fengates Road
    RH1 6AH Redhill
    54
    Surrey
    United KingdomBritishSales Director128233010001
    COUNCELL, Adam Thomas
    Grosvenor Street
    W1K 3JL London
    66
    Uk
    Administrateur
    Grosvenor Street
    W1K 3JL London
    66
    Uk
    EnglandBritishNone148675630002
    SKINNER, Charles Antony Lawrence
    13 Moorhouse Road
    W2 5DH London
    Administrateur
    13 Moorhouse Road
    W2 5DH London
    EnglandBritishDirector58948170002
    SMITH, Paul
    Redhill Distribution Centre
    Salbrook Road
    RH1 5DY Redhill
    The Databank Unit 5
    Surrey
    Administrateur
    Redhill Distribution Centre
    Salbrook Road
    RH1 5DY Redhill
    The Databank Unit 5
    Surrey
    UkBritishDirector160595050001
    BRAMHALL, Graham John
    56 Middleton Road
    Downside
    KT11 3NR Cobham
    Surrey
    Secrétaire
    56 Middleton Road
    Downside
    KT11 3NR Cobham
    Surrey
    BritishFinance Director6859960002
    CORBETT, David Crispin James
    7 Summer Rd
    KT98 9LX East Molesey
    Surrey
    Secrétaire
    7 Summer Rd
    KT98 9LX East Molesey
    Surrey
    BritishFinancial Controller113567280001
    FORD, Laurence Tony
    7 Lichfield Close
    NG9 6JZ Toton
    Nottingham
    Secrétaire
    7 Lichfield Close
    NG9 6JZ Toton
    Nottingham
    BritishFinance Director79123420001
    HUNT, Richard Pierson
    Windmill Cottage Crowborough Road
    Nutley
    TN22 3HY Uckfield
    East Sussex
    Secrétaire
    Windmill Cottage Crowborough Road
    Nutley
    TN22 3HY Uckfield
    East Sussex
    BritishDirector7445670001
    VINCENT, Michael
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    Secrétaire
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    BritishFinance Director99258270001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    GIBB, Robert
    Bay Tree Cottage 42 Friday Street
    Warnham
    RH12 3QX Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    Bay Tree Cottage 42 Friday Street
    Warnham
    RH12 3QX Horsham
    West Sussex
    BritishManagement Consultant45173190002
    HUNT, Richard Pierson
    Windmill Cottage Crowborough Road
    Nutley
    TN22 3HY Uckfield
    East Sussex
    Administrateur
    Windmill Cottage Crowborough Road
    Nutley
    TN22 3HY Uckfield
    East Sussex
    United KingdomBritishDirector7445670001
    MAHONEY, Kevin David
    6 Ferrymans Quay
    William Morris Way
    SW6 2UT London
    Administrateur
    6 Ferrymans Quay
    William Morris Way
    SW6 2UT London
    United KingdomBritishCompany Director63238350002
    MARSHALL, Edmund Walter
    Spinney Farm
    Dowsby
    PE10 0TL Bourne
    Administrateur
    Spinney Farm
    Dowsby
    PE10 0TL Bourne
    EnglandBritishDirector55708560003
    MINTON, John
    Little Hartsfield Sandy Lane
    RH3 7AA Betchworth
    Surrey
    Administrateur
    Little Hartsfield Sandy Lane
    RH3 7AA Betchworth
    Surrey
    BritishDirector7445680002
    SAMSON, Harvey Jack
    Salbrook Road
    RH1 5DY Redhill
    Unit 5 Redhill Distribution Centre
    Surrey
    Uk
    Administrateur
    Salbrook Road
    RH1 5DY Redhill
    Unit 5 Redhill Distribution Centre
    Surrey
    Uk
    United KingdomBritishNone3650740002
    VINCENT, Michael
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    Administrateur
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    EnglandBritishFinance Director99258270001

    RESTORE (WANSDYKE) LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee and fixed and floating charge
    Créé le 29 févr. 2012
    Livré le 13 mars 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 24 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee and fixed and floating charge
    Créé le 01 juil. 2011
    Livré le 08 juil. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 24 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 28 juin 2011
    Livré le 30 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 24 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 31 janv. 2011
    Livré le 11 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 11 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 29TH july 2009,
    Créé le 12 nov. 2010
    Livré le 13 nov. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 29 juil. 2009
    Livré le 05 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Omnibus guarantee & set-off agreement
    Créé le 29 juil. 2009
    Livré le 05 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 11 mai 2005
    Livré le 13 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and rgh and mavinwood PLC (the purchaser) to john minton, richard pierson hunt, neil clark and paul smith (the sellers) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • John Minton (As Trustee and Security Trustee for Each of the Sellers)
    Transactions
    • 13 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 mai 2005
    Livré le 17 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any of the chargors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC in Its Capacity as Security Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 17 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 15 janv. 2003
    Livré le 27 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 févr. 1999
    Livré le 03 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 03 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0