DILLONS UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDILLONS UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03040465
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DILLONS UK LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe DILLONS UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Windsor House
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de DILLONS UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 avr. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour DILLONS UK LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour DILLONS UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Achèvement de la liquidation

    1 pagesL64.07

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Ian Kenyon en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Trevor Moore en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Elaine Marriner en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Elaine Marriner en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Ian Peter Kenyon en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Trevor Philip Moore en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Simon Fox en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 avr. 2012

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 avr. 2012

    État du capital au 02 avr. 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * Shelley House 2-4 York Road Maidenhead Berkshire SL6 1SR* le 13 mars 2012

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2011

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 24 avr. 2010

    3 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Elaine Marriner le 21 avr. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Richard Fox le 21 avr. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Elaine Marriner le 21 avr. 2010

    1 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Gerald Johnson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    13 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Comptes pour une société dormante établis au 25 avr. 2009

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de DILLONS UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRIGHT, Neil Irvine
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    British180993450001
    CAMPBELL, Laurence James
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    Secrétaire
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    British27960300001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Secrétaire
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    British62634010001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Secrétaire
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    British76768320001
    MARRINER, Elaine
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British40470020001
    SMITH, George Marsden
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    Secrétaire
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    British15729150003
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British63502600001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    Secrétaire
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    BELL, Duncan Charles
    Longwood
    Queen Annes Road
    SL4 2BJ Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    Longwood
    Queen Annes Road
    SL4 2BJ Windsor
    Berkshire
    British9950440002
    CALDWELL, Findlay Martin
    Heronswood Ford Lane
    Langley
    CV37 0HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Heronswood Ford Lane
    Langley
    CV37 0HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    GbBritish50777030001
    FADIL, Susan Carol
    Shemer Ash Road
    Hawley
    DA2 7SB Dartford
    Kent
    Administrateur désigné
    Shemer Ash Road
    Hawley
    DA2 7SB Dartford
    Kent
    British900006600001
    FOX, Simon Richard
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish58101280002
    GILES, Alan James
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    Administrateur
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    EnglandBritish156046020001
    GUMMERS, Eric Michael
    9 Vincent Square Mansions
    Walcott Street
    SW1P 2NT London
    Administrateur désigné
    9 Vincent Square Mansions
    Walcott Street
    SW1P 2NT London
    British900006590001
    HARRIS, Maxine
    Falcon House
    Hellidon Road
    CV47 7RN Priors Marston
    Warwickshire
    Administrateur
    Falcon House
    Hellidon Road
    CV47 7RN Priors Marston
    Warwickshire
    British86121990001
    HOOD, John
    Briarwood
    15 Twatling Road Barnt Green
    B45 8HX Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    Briarwood
    15 Twatling Road Barnt Green
    B45 8HX Birmingham
    West Midlands
    British39644740001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Administrateur
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    UkBritish62634010001
    JOHNSON, Gerald Thomas
    Manor Farm House
    Oddington
    OX5 2RA Kidlington
    Oxfordshire
    Administrateur
    Manor Farm House
    Oddington
    OX5 2RA Kidlington
    Oxfordshire
    EnglandBritish145115810001
    KENYON, Ian Peter
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish107735600001
    LANDERS, Brian James
    Briarbank House
    12a Childs Hill Road
    KT23 3QG Bookham Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Briarbank House
    12a Childs Hill Road
    KT23 3QG Bookham Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritish90246320001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Administrateur
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    EnglandBritish76768320001
    MARRINER, Elaine
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish40470020001
    MCALLISTER, Stuart
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    British9406880001
    MCGLOIN, Brian Joseph Patrick
    72 Northumberland Road
    EN5 1EE Barnet
    Hertfordshire
    Administrateur
    72 Northumberland Road
    EN5 1EE Barnet
    Hertfordshire
    British51112090001
    MCLAUGHLIN, Brian Finbar
    Pangbourne Lodge
    Tidmarsh Road
    RG8 7AZ Pangbourne
    Berkshire
    Administrateur
    Pangbourne Lodge
    Tidmarsh Road
    RG8 7AZ Pangbourne
    Berkshire
    United KingdomBritish9950470002
    MOORE, Trevor Philip
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish113047410001
    ROGULSKA, Franca, Ms.
    Arcadia 5 Cornwall Close
    Warfield
    RG42 3UH Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Arcadia 5 Cornwall Close
    Warfield
    RG42 3UH Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritish113630630002
    SINYOR, Joe
    5 Cotman Close
    NW11 6QD London
    Administrateur
    5 Cotman Close
    NW11 6QD London
    British61172920002
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Administrateur
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish63502600001
    WARNOCK, Shaw William
    3rd Floor
    58 Kensington Gardens Square
    W2 4BA London
    Administrateur
    3rd Floor
    58 Kensington Gardens Square
    W2 4BA London
    EnglandBritish143882000001
    WOOD, Fiona Anne Murray
    27 Roehampton Lane
    SW15 5LS London
    Administrateur
    27 Roehampton Lane
    SW15 5LS London
    EnglandBritish47935020001
    WORRALL, Brian George
    Apple House
    11a Sedgewell Road
    RG4 9TA Sonning Common
    Berkshire
    Administrateur
    Apple House
    11a Sedgewell Road
    RG4 9TA Sonning Common
    Berkshire
    United KingdomBritish107708510001

    DILLONS UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 22 mai 1998
    Livré le 04 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the high yield documents (as defined) and this debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Chase Manhattan Bank,as Security Trustee
    Transactions
    • 04 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Amendment deed (to a debenture dated 28TH march 1998 as amended and restated on 14TH may 1998 the "amended and restated debenture")
    Créé le 22 mai 1998
    Livré le 03 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the security agent) (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets including all buildings fixtures book debts plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transactions
    • 03 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Amendment and restatement deed (to a debenture incorporating fixed and floating charges dated 28TH march 1998)
    Créé le 14 mai 1998
    Livré le 15 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security agent for itself and emi group finance PLC) under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including all buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transactions
    • 15 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 mars 1998
    Livré le 09 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents and this charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transactions
    • 09 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 mars 1998
    Livré le 09 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of swiss bank corporation as "security agent", which expression shall include any person for the time being appointed as security trustee or as an additional trustee for the purpose of, and in accordance with, the senior facility agreement, the company shall discharge each and every liability which the company may now or hereafter have to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the senior facility agreement (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made thereunder and pay to the security agent when due and payable every sum (of principal, intererst or otherwise) now or hereafter owing, due or incurred by the company to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities
    Brèves mentions
    By way of fixed charge (I) principal property owned by it at the date of this debenture other than (a) any heritable or leasehold property in scotland and all buildings trade and other fixtures fixed plant machinery installations and apparatus from time to time on any such property in scotland and (b) any principal property in northern ireland.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Swiss Bank Corporation as "Security Agent"Which Expression Shall Include Any Person for the Time Being Appointed as Security Trustee or as an Additional Trustee for the Purpose of, and in Accordance with, the Senior Facility Agreement
    Transactions
    • 09 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    DILLONS UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 juil. 2013Petition date
    02 sept. 2013Commencement of winding up
    30 avr. 2014Conclusion of winding up
    13 août 2014Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or St Albans
    1st Floor
    Trident House
    AL1 3HR 42-48 Victoria Street
    St Albans
    practitioner
    1st Floor
    Trident House
    AL1 3HR 42-48 Victoria Street
    St Albans

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0