GRIPPERRODS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GRIPPERRODS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03041925 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GRIPPERRODS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Pearl Assurance House 319 Ballards Lane N12 8LY London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GRIPPERRODS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2011 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour GRIPPERRODS LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour GRIPPERRODS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 8 pages | 4.71 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 août 2015 | 8 pages | 4.68 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 août 2014 | 8 pages | 4.68 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Pinnacle House First Floor 17-25 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3SE United Kingdom* le 30 août 2013 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration des objets de la société | 21 pages | CC04 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 23 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Hopster en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Elizabeth Honor Lewzey en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael John Hopster en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Elizabeth Honor Lewzey le 04 juil. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 7 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Nicolas Paul Wilkinson en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Thomas C. Reeve en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Elizabeth Honor Lewzey en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Flanagan en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * East Putney House 84 Upper Richmond Road London SW15 2ST* le 07 juil. 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Denise Burton en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Michael John Hopster en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GRIPPERRODS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Secrétaire | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | 165833030001 | |||||||
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Administrateur | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 59381700003 | |||||
| REEVE, Thomas C. | Administrateur | Wewatta Street 80202 Denver 1551 Colorado Usa | United States | American | 161822390001 | |||||
| WILKINSON, Nicolas Paul | Administrateur | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 48808690001 | |||||
| BURTON, Denise Patricia | Secrétaire | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570004 | ||||||
| HOPSTER, Michael John | Secrétaire | 40 Brooksbys Walk E9 6DF London Flat B United Kingdom | 157103010001 | |||||||
| LAU, Cheong Koon | Secrétaire | 40 Strongbow Road Eltham SE9 1DT London | Malaysian | 16337610001 | ||||||
| PAUL, Simon George | Secrétaire | Spinney Cottage Station Road CV13 0NP Market Bosworth Warwickshire | British | 154423590001 | ||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
| BURTON, Denise Patricia | Administrateur | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | 47432570004 | |||||
| DUNCAN, Ian Alexander | Administrateur | Durham House Durham Place SW3 4ET London | United Kingdom | British | 27300002 | |||||
| FARRELL, William Michael | Administrateur | 7 Craigvale Court DG1 4QH Dumfries | British | 62063670001 | ||||||
| FLANAGAN, Paul Edward | Administrateur | Flat 9 19 Holland Park W11 3TD London | United Kingdom | British | 69281780002 | |||||
| HAZARD, George Anthony | Administrateur | 46 Broad Oaks Road B91 1JB Solihull West Midlands | British | 6369950001 | ||||||
| HOPSTER, Michael John | Administrateur | Flat B 40 Brooksbys Walk E9 6DF London | United Kingdom | British | 77921850004 | |||||
| HOUGHTON, Paul David | Administrateur | 2 Mayfield Court Formby L37 7JL Liverpool Merseyside | British | 95097460001 | ||||||
| JACKSON, Pearse | Administrateur | 3 Woodside Parkgate DG1 3LY Dumfries | Irish | 61362400001 | ||||||
| LEES, Peter Bryce | Administrateur | 6 Jerviswood ML1 4AJ Motherwell Lanarkshire | British | 26615220001 | ||||||
| MARCHANT, Richard Norman | Administrateur | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | 26880001 | ||||||
| MOULDS, Peter John | Administrateur | 2 Millside Slitting Mill WS15 2FG Rugeley Staffordshire | British | 31029500002 | ||||||
| OWEN, David Evan Penrhyn | Administrateur | The Old Barn Church Lane S81 9EH Carlton In Lindrick Nottinghamshire | British | 73849580001 | ||||||
| PAUL, Simon George | Administrateur | Spinney Cottage Station Road CV13 0NP Market Bosworth Warwickshire | England | British | 154423590001 | |||||
| PERSSON, Jan Allan | Administrateur | 3 Wayside SW14 7LN London | Swedish | 6650000001 | ||||||
| PORTER, Norman Charles | Administrateur | Farnham House 2 Beedingwood Drive Forest Road Colgate RH12 4TE Horsham West Sussex | England | British | 445360034 | |||||
| ROBB, Kenneth | Administrateur | 2 Glentruim View KA2 0LL Kilmarnock Ayrshire | British | 61362350001 | ||||||
| SACK, Adam David | Administrateur | 115 Broadhurst Gardens NW6 3BJ London | British | 32459700002 | ||||||
| STANSFIELD, Neil Andrew | Administrateur | The Laurels, Poets Way Newnham NN11 3HQ Daventry Northamptonshire | British | 79347560001 | ||||||
| WIEGMAN, Albert Edward Bernard | Administrateur | 17 Hills Avenue CB1 7UY Cambridge | British | 7466220002 | ||||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
GRIPPERRODS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over credit balances | Créé le 24 avr. 1998 Livré le 07 mai 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The sum of £33,000 together with interest accrued now or to be held by national westmister bank PLC on an account numbered 94897077 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 13 janv. 1998 Livré le 21 janv. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under this mortgage debenture or in connection with a counter indemnity of even date | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over credit balances | Créé le 10 nov. 1997 Livré le 24 nov. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The sum of £41,300 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 94897077 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed charge on discounted debts and a floating charge on the receipts of other debts | Créé le 23 oct. 1997 Livré le 30 oct. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an invoice discounting agreement (as therein defined) or otherwise | |
Brèves mentions Fixed equitable charge (I) all debts the subject of an invoice discounting agreement between the company and the chargee that fail to vest in the chargee and all rights in favour of the company related to such debts and (ii) all other amounts owing and all rights relating to such amounts, floating charge such of the moneys received in respect of amounts referred to in (ii) above as shall stand released from the fixed equitable charge. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Chattels mortgage | Créé le 05 juin 1995 Livré le 17 juin 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company (formerly known as arleshaw limited) to the chargee under the terms of a credit sale agreement dated 12TH september 1991 and a novation agreement dated 5TH june 1995 | |
Brèves mentions The sponge rubber underlay production line situated at the company's premises at walkmill lane, cannock, staffordshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 05 juin 1995 Livré le 15 juin 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company (formerly known as arleshaw limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Factory warehouse and office premises forming part of the industrial estate at walkmill lane cannock staffordshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
GRIPPERRODS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0