PROSPECTS SERVICES

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPROSPECTS SERVICES
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 03042176
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PROSPECTS SERVICES ?

    • Services de soutien à l'éducation (85600) / Enseignement

    Où se situe PROSPECTS SERVICES ?

    Adresse du siège social
    Black Country House
    Rounds Green Road
    B69 2DG Oldbury
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PROSPECTS SERVICES ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PROSPECTS SERVICES LIMITED18 juil. 200118 juil. 2001
    PROSPECTS CAREERS SERVICES LIMITED19 déc. 199719 déc. 1997
    SOUTH LONDON CAREERS SERVICES LIMITED30 mars 199530 mars 1995

    Quels sont les derniers comptes de PROSPECTS SERVICES ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PROSPECTS SERVICES ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au19 mars 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation02 avr. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au19 mars 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour PROSPECTS SERVICES ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes annuels établis au 31 août 2023

    41 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Statuts

    28 pagesMA

    Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr James Edmund Robertson en tant qu'administrateur le 28 juil. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen Noel King en tant que directeur le 28 juil. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 août 2022

    39 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 030421760019, créée le 14 déc. 2022

    9 pagesMR01

    Nomination de Mr Scott Morley Miller en tant qu'administrateur le 29 sept. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jacqueline Maria Oughton en tant que directeur le 29 sept. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen Noel King en tant qu'administrateur le 10 mai 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Paul Michael Baldwin en tant que directeur le 10 mai 2022

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 août 2021

    39 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Peter David Holmes en tant que directeur le 03 févr. 2022

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 août 2020

    42 pagesAA

    Cessation de la nomination de Victoria Blakeman en tant que directeur le 12 avr. 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Stephen Noel King en tant que secrétaire le 26 janv. 2021

    1 pagesTM02

    Nomination de Carol Ann Mckinley en tant que secrétaire le 26 janv. 2021

    2 pagesAP03

    Changement d'adresse du siège social de Shaw Trust House 19 Elmfield Road Bromley Kent BR1 1LT England à Black Country House Rounds Green Road Oldbury B69 2DG le 20 nov. 2020

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 août 2019

    42 pagesAA

    Nomination de Mr Stephen Noel King en tant que secrétaire le 30 avr. 2020

    2 pagesAP03

    Déclaration de confirmation établie le 30 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de PROSPECTS SERVICES ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCKINLEY, Carol Ann
    Rounds Green Road
    B69 2DG Oldbury
    Black Country House
    England
    Secrétaire
    Rounds Green Road
    B69 2DG Oldbury
    Black Country House
    England
    279173790001
    MILLER, Scott Morley
    Rounds Green Road
    B69 2DG Oldbury
    Black Country House
    England
    Administrateur
    Rounds Green Road
    B69 2DG Oldbury
    Black Country House
    England
    United KingdomBritishChief Operating Officer296778320001
    ROBERTSON, James Edmund
    Rounds Green Road
    B69 2DG Oldbury
    Black Country House
    England
    Administrateur
    Rounds Green Road
    B69 2DG Oldbury
    Black Country House
    England
    United KingdomBritishChief Finance Officer292840800001
    BEERLING, Kevin
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    Secrétaire
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    BritishFinance Director64677850002
    BURNIGE, Martha Jane Ireland
    Prospects House
    19 Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Kent
    Secrétaire
    Prospects House
    19 Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Kent
    173426310001
    JOHNSTON, Duncan Alexander
    Oakwood 3 Marlowe Close
    BR7 6ND Chislehurst
    Kent
    Secrétaire
    Oakwood 3 Marlowe Close
    BR7 6ND Chislehurst
    Kent
    British49215870001
    KING, Stephen Noel
    Rounds Green Road
    B69 2DG Oldbury
    Black Country House
    England
    Secrétaire
    Rounds Green Road
    B69 2DG Oldbury
    Black Country House
    England
    269330420001
    SAWYERS, Paul Francis
    138 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    Secrétaire
    138 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    BritishFinance Director116342910001
    TREVORROW, Catherine Joanne
    19 Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Shaw Trust House
    Kent
    England
    Secrétaire
    19 Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Shaw Trust House
    Kent
    England
    180081790001
    WOODHOUSE, Mary Nana
    14 Heath Close
    SM7 3QU Banstead
    Surrey
    Secrétaire
    14 Heath Close
    SM7 3QU Banstead
    Surrey
    British109523150001
    CURZON CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Curzon House
    Southernhay West
    EX1 1AB Exeter
    Devon
    Secrétaire
    Curzon House
    Southernhay West
    EX1 1AB Exeter
    Devon
    65608250001
    ALLEN, Janet Marie
    31 Scarborough Street
    E1 8DR London
    Shaw Trust, Garrick Court
    England
    Administrateur
    31 Scarborough Street
    E1 8DR London
    Shaw Trust, Garrick Court
    England
    EnglandBritishDirector76073660001
    ANDERSON, David Maxwell
    42 Vardens Road
    SW11 1RH London
    Administrateur
    42 Vardens Road
    SW11 1RH London
    United KingdomBritishAssistant Director Of Educatio55030080001
    AUVRAY, Raymond Michel
    Prospects House
    19 Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Kent
    Administrateur
    Prospects House
    19 Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Kent
    United KingdomBritishDirector48457040004
    BALDWIN, Paul Michael
    Rounds Green Road
    B69 2DG Oldbury
    Black Country House
    England
    Administrateur
    Rounds Green Road
    B69 2DG Oldbury
    Black Country House
    England
    EnglandBritishCompany Director158255690001
    BAXTER, Andrew John
    63 Acorn Ave
    CM7 7LP Braintree
    Essex
    Uk
    Administrateur
    63 Acorn Ave
    CM7 7LP Braintree
    Essex
    Uk
    BritishLocal Govt. Officer64340510001
    BEERLING, Kevin
    Prospects House
    19 Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Kent
    Administrateur
    Prospects House
    19 Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Kent
    EnglandBritishFinance Director64677850002
    BELL, James Nicholas
    19 Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Shaw Trust House
    Kent
    England
    Administrateur
    19 Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Shaw Trust House
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector191834970001
    BLAKEMAN, Victoria
    Rounds Green Road
    B69 2DG Oldbury
    Black Country House
    England
    Administrateur
    Rounds Green Road
    B69 2DG Oldbury
    Black Country House
    England
    EnglandBritishDirector249958560001
    BLURTON, Christopher John
    3 Woodlands Park
    Merrow
    GU1 2TH Guildford
    Surrey
    England
    Administrateur
    3 Woodlands Park
    Merrow
    GU1 2TH Guildford
    Surrey
    England
    BritishLocal Government Officer42670520001
    CABRAS, Brenda Patricia
    19 Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Shaw Trust House
    Kent
    England
    Administrateur
    19 Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Shaw Trust House
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector56598020001
    CABRAS, Brenda Patricia
    2 Storr Gardens
    Hutton
    CM13 1HT Brentwood
    Essex
    Administrateur
    2 Storr Gardens
    Hutton
    CM13 1HT Brentwood
    Essex
    EnglandBritishDirector56598020001
    CALLER, Maxwell Marshall
    19 Penshurst Road
    HA8 9NT Edgware
    Middlesex
    Administrateur
    19 Penshurst Road
    HA8 9NT Edgware
    Middlesex
    UkBritishLocal Government Officer102954520001
    CAREY, Nicholas Oliver Charles
    19 Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Shaw Trust House
    Kent
    England
    Administrateur
    19 Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Shaw Trust House
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector186531380001
    CHURCH, Judith Ann
    49 Grasmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DH London
    Administrateur
    49 Grasmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DH London
    United KingdomBritishDirector77177680003
    CLINTON, Lorraine Elizabeth
    Prospects House
    19 Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Kent
    Administrateur
    Prospects House
    19 Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Kent
    EnglandBritishDirector52625780001
    DAVIS, Kenneth Joseph
    246 Maidstone Road
    ME4 6JN Chatham
    Kent
    Administrateur
    246 Maidstone Road
    ME4 6JN Chatham
    Kent
    BritishDirector Of Education50709720001
    DOWTHWAITE, Roger
    13 Maltings Close
    WV6 7WB Ackleton
    Shropshire
    Administrateur
    13 Maltings Close
    WV6 7WB Ackleton
    Shropshire
    BritishChief Executive59229230002
    EAGLES, Geoffrey Ronald William
    Pippins 83 Mid Street
    South Nutfield
    RH1 4JJ Redhill
    Surrey
    Administrateur
    Pippins 83 Mid Street
    South Nutfield
    RH1 4JJ Redhill
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director1124750007
    EVANS, Peter John
    Merryweather
    Mill Lane
    CM3 2QD Terling
    Essex
    Administrateur
    Merryweather
    Mill Lane
    CM3 2QD Terling
    Essex
    United KingdomBritishDirector110087310001
    FOREMAN, Francis Nigel
    98 Leathermarket Court
    Leathermarket Street
    SE1 3HT London
    Administrateur
    98 Leathermarket Court
    Leathermarket Street
    SE1 3HT London
    United KingdomBritishLecturer35184340002
    GASKIN, John Martin
    2 Station Oast
    Goudhurst Road
    TN12 8AE Horsmonden Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    2 Station Oast
    Goudhurst Road
    TN12 8AE Horsmonden Tonbridge
    Kent
    BritishDirector98642970001
    GILBERT, Christine Bridget, Dame
    Prospects House
    19 Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Kent
    Administrateur
    Prospects House
    19 Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Kent
    EnglandBritishConsultant225359570001
    GRANT, James
    6 Yarrow Close
    WV11 3UJ Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    6 Yarrow Close
    WV11 3UJ Wolverhampton
    West Midlands
    BritishExecutive Commercial Programs77805180001
    GRAY, John Arthur
    31 Forest View
    Chingford
    E4 7AU London
    Administrateur
    31 Forest View
    Chingford
    E4 7AU London
    EnglandBritishDirector7547700001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PROSPECTS SERVICES ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Prospects Services Midco Limited
    Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Shaw Trust House, 19
    Kent
    England
    06 avr. 2016
    Elmfield Road
    BR1 1LT Bromley
    Shaw Trust House, 19
    Kent
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement7596398
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    PROSPECTS SERVICES a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 14 déc. 2022
    Livré le 20 déc. 2022
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 déc. 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 28 févr. 2019
    Livré le 04 mars 2019
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 mars 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 02 juin 2017
    Livré le 09 juin 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The freehold property known as prospects house, 19 elmfield road, bromley, kent BR1 1LT registered under title number SGL86969.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale Bank and Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 09 juin 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 mars 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 02 juin 2017
    Livré le 09 juin 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The freehold property known as 233 broadway, bexleyheath, kent DA6 7EJ registered under title number K168782.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale Bank and Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 09 juin 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 mars 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 02 juin 2017
    Livré le 09 juin 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The leasehold property known as unit 1 st andrews court, andrews way, barrow in furness, cumbria LA14 registered under title number CU204548.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale Bank and Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 09 juin 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 mars 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 02 juin 2017
    Livré le 08 juin 2017
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale Bank and Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 08 juin 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 mars 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 29 juil. 2015
    Livré le 31 juil. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The property known as prospects house, 19 elmfield road, bromley BR1 1LT registered at the land registry with title number SGL86969. The property known as 233 broadway, bexleyheath, kent DA6 7EJ registered at the land registry with title number K168782.. Please see charge document for details of further property.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 31 juil. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 13 juil. 2011
    Livré le 30 juil. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £4000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The deposit.
    Personnes ayant droit
    • Curtis Gulliver Brown and Krishnaveni Brown
    Transactions
    • 30 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 07 juil. 2011
    Livré le 09 juil. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,509 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The deposit and any accrued interest see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anchorage Investments Inc.
    Transactions
    • 09 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 30 mars 2011
    Livré le 06 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the group (or any group member) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a prospects house 19 elmfield road bromley t/no. SGL86969 by way of fixed charge all of its rights, title, estate and other interests in and to:- the rental income and the benefit of all rights and claims to which is now or may in the future become entitled in relation to the charged property see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 06 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 30 mars 2011
    Livré le 06 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the group (or any group member) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H property k/a unit 1 andrews court phoenix road barrow in furness t/no. CU204548 by way of fixed charge all of its rights, title, estate and other interests in and to:- the rental income and the benefit of all rights and claims to which is now or may in the future become entitled in relation to the charged property see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 06 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 30 mars 2011
    Livré le 06 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the group (or any group member) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a 233 broadway bexleyheath kent t/no. K168782 by way of fixed charge all of its rights, title, estate and other interests in and to:- the rental income and the benefit of all rights and claims to which is now or may in the future become entitled in relation to the charged property see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 06 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 mars 2011
    Livré le 06 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the group (or any group member) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 06 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 28 oct. 2005
    Livré le 29 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 1, andrews court, furness business park, barrow-in-furness.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 13 juin 2005
    Livré le 17 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    233 broadway bexleyheath kent t/n K168782.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 25 mai 2005
    Livré le 09 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 82 high street stourbridge DY6 1ED t/n WM737293.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 31 déc. 2003
    Livré le 06 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a comelle house 19 elmfield road bromley BR1 1LT t/n SGL86969.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rental deposit deed
    Créé le 16 oct. 2001
    Livré le 18 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date
    Brèves mentions
    The rent deposit of £9,967.50 together with all accrued interest held in a deposit account with child & co.,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wimbledon & District Young Men's Christian Association
    Transactions
    • 18 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 avr. 1996
    Livré le 18 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0