PARKLANDS ONE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPARKLANDS ONE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03044974
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PARKLANDS ONE LIMITED ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale
    • Activités de soins résidentiels pour troubles d'apprentissage, santé mentale et abus de substances (87200) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe PARKLANDS ONE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Pinsent Masons Llp
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PARKLANDS ONE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FUTURE LIFE LIMITED11 avr. 199511 avr. 1995

    Quels sont les derniers comptes de PARKLANDS ONE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour PARKLANDS ONE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de Part Ground Floor & First Floor Two Parklands, Great Park Rubery, Rednal Birmingham B45 9PZ à C/O Pinsent Masons Llp 1 Park Row Leeds LS1 5AB le 20 déc. 2017

    1 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 21 juil. 2017

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Patricia Lesley Lee en tant que directeur le 31 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name07 juil. 2017

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration de confirmation établie le 11 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 avr. 2016

    État du capital au 27 avr. 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 juin 2015

    État du capital au 25 juin 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014

    8 pagesAA

    Nomination de Ms Patricia Lesley Lee en tant qu'administrateur le 22 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Albert Edward Smith en tant que directeur le 22 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 mai 2014

    État du capital au 08 mai 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Katharine Kandelaki en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Divers

    Auditors resignation sec 519
    2 pagesMISC

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2012 au 30 juin 2013

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2011

    5 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 28 Welbeck Street London W1G 8EW* le 06 sept. 2012

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de PARKLANDS ONE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MANSON, David Lindsay
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    C/O Pinsent Masons Llp
    England
    Administrateur
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    C/O Pinsent Masons Llp
    England
    United KingdomBritishDirector167628190001
    AMLANI, Pritesh
    Birling Road
    Ryarsh
    ME19 5LS West Malling
    Ryarsh Oast House
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Birling Road
    Ryarsh
    ME19 5LS West Malling
    Ryarsh Oast House
    Kent
    United Kingdom
    BritishBusiness Executive125206220002
    KANDELAKI, Katharine Amelia Christabel
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    160356790001
    MARSHALL, William Nikolas
    Yew Tree Cottage
    20 Pines Road
    BR1 2AA Bromley
    Kent
    Secrétaire
    Yew Tree Cottage
    20 Pines Road
    BR1 2AA Bromley
    Kent
    British71326730003
    MEE, Bernard Roy
    Northdown
    Church Lane
    ME14 4EF Bearsted
    Kent
    Secrétaire
    Northdown
    Church Lane
    ME14 4EF Bearsted
    Kent
    British103302460001
    TREON, Anoup
    Apt 1, Cambridge Gate
    Regents Park
    NW1 4JX London
    Secrétaire
    Apt 1, Cambridge Gate
    Regents Park
    NW1 4JX London
    BritishDirector152212470001
    WEAVER, Peter
    The Glebe Pilgrims Way
    Hollingbourne
    ME17 1UT Maidstone
    Kent
    Secrétaire
    The Glebe Pilgrims Way
    Hollingbourne
    ME17 1UT Maidstone
    Kent
    BritishConsultant1971180001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    CALLINGHAM, Deborah Denise
    14a Augusta Gardens
    CT20 2RR Folkestone
    Kent
    Administrateur
    14a Augusta Gardens
    CT20 2RR Folkestone
    Kent
    BritishCare Home Manager55350960001
    KING, Martin David
    17 Ellington Way
    KT18 5TA Epsom
    Surrey
    Administrateur
    17 Ellington Way
    KT18 5TA Epsom
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director141946770001
    LEE, Patricia Lesley
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    Administrateur
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United KingdomBritishChief Executive192233540001
    MARSHALL, William Nikolas
    Yew Tree Cottage
    20 Pines Road
    BR1 2AA Bromley
    Kent
    Administrateur
    Yew Tree Cottage
    20 Pines Road
    BR1 2AA Bromley
    Kent
    BritianBritishDirector71326730003
    MASTERS, David Edward
    Triggs Farm
    Goudhurst
    TN17 1DS Cranbrook
    Kent
    Administrateur
    Triggs Farm
    Goudhurst
    TN17 1DS Cranbrook
    Kent
    United KingdomBritishFarmer And Property Developer21316820001
    PERRY, David William
    Welbeck Street
    W1G 8EW London
    28
    Administrateur
    Welbeck Street
    W1G 8EW London
    28
    EnglandBritishDirector33988060002
    SMITH, Albert Edward
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector77631340001
    TREON, Anoup
    Apt 1, Cambridge Gate
    Regents Park
    NW1 4JX London
    Administrateur
    Apt 1, Cambridge Gate
    Regents Park
    NW1 4JX London
    United KingdomBritishDirector152212470001
    TREON, Jaynee Sunita
    Welbeck Street
    W1G 8EW London
    28
    Administrateur
    Welbeck Street
    W1G 8EW London
    28
    United KingdomBritishDirector42532090004
    WEAVER, Peter
    The Glebe Pilgrims Way
    Hollingbourne
    ME17 1UT Maidstone
    Kent
    Administrateur
    The Glebe Pilgrims Way
    Hollingbourne
    ME17 1UT Maidstone
    Kent
    BritishConsultant1971180001
    WILLIAMS, Alison
    Woodside Cottage Swan Lane
    Sellindge
    TN25 6HD Ashford
    Kent
    Administrateur
    Woodside Cottage Swan Lane
    Sellindge
    TN25 6HD Ashford
    Kent
    EnglandBritishRegistered60151300001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PARKLANDS ONE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Parklands
    Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    England
    06 avr. 2016
    Parklands
    Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05132584
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    PARKLANDS ONE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 25 juil. 2012
    Livré le 03 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 03 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 10 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 25 mars 2011
    Livré le 06 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them on any account whatsoever and to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge and all monies due or to become due from each other chargor and each other member of the group to the lenders or any of them on any account whatsoever and to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent
    Transactions
    • 06 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 04 avr. 2008
    Livré le 09 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transactions
    • 09 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2008
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 05 janv. 2005
    Livré le 22 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 juin 1996
    Livré le 19 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & the Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 19 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PARKLANDS ONE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 juil. 2017Commencement of winding up
    02 nov. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0