INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03045060 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood Lancashire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 avr. 2015 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Steve Quinlan en tant qu'administrateur le 26 août 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de James Lamar Herbert en tant qu'administrateur le 26 août 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Gareth Smith en tant que directeur le 26 août 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Gareth Smith en tant que directeur le 26 août 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Leslie Morris en tant que directeur le 26 août 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Colin Goodwille en tant que directeur le 26 août 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Maclaren Cassells en tant que directeur le 26 août 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Gareth Smith en tant que secrétaire le 26 août 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Stephen Jeffrey Irwin Holmes en tant qu'administrateur le 26 août 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2015 | 8 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2014 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Colin Goodwille le 23 oct. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr Ian Leslie Morris en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Gareth Smith en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2013 | 4 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Gareth Smith en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Sullivan en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2012 | 4 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERBERT, James Lamar | Administrateur | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire | United States | American | 200649010001 | |||||
| HOLMES, Stephen Jeffrey Irwin, Dr | Administrateur | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire | United Kingdom | British | 200627160001 | |||||
| QUINLAN, Steve | Administrateur | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire | Usa | American | 203115340001 | |||||
| BAKER, Edward Matthew Scott | Secrétaire | 2 Homelands Close Sale M33 4EB Manchester | British | 4668730002 | ||||||
| BROWN, Michael Stewart | Secrétaire | Flat 6 Derwent Park House New Road DE22 1DR Derby | British | 86327240001 | ||||||
| COTTON, Angela | Secrétaire | 3 Ravens Holme BL1 5TN Bolton Greater Mancheseter | British | 62018140001 | ||||||
| DUNBAR, Stephen John | Secrétaire | 43 Cotswold Drive Horwich BL6 7DE Bolton Lancashire | British | 46237640003 | ||||||
| JAMES, Richard David | Secrétaire | 19 Mill Close WA2 0ST Warrington Cheshire | British | 80458850001 | ||||||
| RAPSON, Bernard David | Secrétaire | Bank Cottage Old Forge Lane Preston Capes NN11 3TD Daventry Northamptonshire | British | 3213310001 | ||||||
| SMITH, Paul Gareth | Secrétaire | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | 184029570001 | |||||||
| SULLIVAN, Mark James | Secrétaire | 2 Grange Barn Malt Kiln Lane Bispham L40 3SH Ormskirk Lancashire | British | 101060960001 | ||||||
| A B & C SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire désigné | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006570001 | |||||||
| BONDSWELL, Andrew | Administrateur | 19 Brier Hill View HD2 1JQ Huddersfield West Yorkshire | British | 62729310001 | ||||||
| BOWHILL, Keith Nicholas | Administrateur | Woodside Sandy Lane Rushmoor GU10 2ET Farnham Surrey | British | 61679460002 | ||||||
| CASSELLS, John Maclaren, Dr | Administrateur | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | England | British | 63881080001 | |||||
| DAWE, Peter John | Administrateur | The Manor House 71 High Street Oakington CB4 5AG Cambridge | British | 48967260001 | ||||||
| EDGE, Christopher Thomas | Administrateur | Fife House 30a Fife Road East Sheen SW14 7EL London | England | British | 11465390002 | |||||
| EDWARDS, Stephen Peter | Administrateur | The Grange Lamberhurst Quarter TN3 8AN Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 147275950001 | |||||
| GOODWILLE, Colin | Administrateur | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | England | British | 3856830002 | |||||
| GOODWILLE, Fiona Ford | Administrateur | The Old Rectory Church Lane CB3 8QN Papworth Everard Cambridge | British | 20914960001 | ||||||
| GUNLACK, Robert Henry | Administrateur | Treviades Barton High Cross Constantine TR11 5RG Falmouth Cornwall | England | British | 27971040006 | |||||
| HILLARY, Alan | Administrateur | 1 Cameron Close GU6 8EB Cranleigh Surrey | United Kingdom | British | 13184060001 | |||||
| HOLMES, Andrew Peter Geoffrey | Administrateur | 51 Doneraile Street SW6 6EW London | England | British | 21151650001 | |||||
| MORRIS, Ian Leslie | Administrateur | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | United Kingdom | British | 138377860001 | |||||
| PRIMROSE, Sandy Blackadder, Doctor | Administrateur | Amersham Road HP13 6QS High Wycombe 21 Buckinghamshire | England | British | 17972160001 | |||||
| RAPSON, Bernard David | Administrateur | Bank Cottage Old Forge Lane Preston Capes NN11 3TD Daventry Northamptonshire | England | British | 3213310001 | |||||
| SMITH, Paul Gareth | Administrateur | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | England | British | 187422070001 | |||||
| SMITH, Peter James | Administrateur | 19 Coolidge Avenue LA1 5ER Lancaster | British | 37288990001 | ||||||
| STANLEY, Christopher John, Dr | Administrateur | Harradine House Church Street Woodhurst PE28 3BN Huntingdon Cambridgeshire | British | 45065760002 | ||||||
| STEWART, James Alexander | Administrateur | 9 Jameson Street W8 7SH London | British | 13771800001 | ||||||
| SYMS, Allan, Dr | Administrateur | Customs House Place Penarth Marina CF64 1TP Vale Of Glamorgan 12 Cariff | British | 128513480001 | ||||||
| THOMAS, Howard | Administrateur | Wooton Court St Neots Road St Neots Road PE19 4UU Abbotsley Cambridgeshire | United Kingdom | British | 18174450001 | |||||
| WALPOLE, Malcolm William | Administrateur | 28 Higher Mead RG24 8YL Old Basing Hampshire | British | 107822300001 | ||||||
| A B & C SECRETARIAL LIMITED | Administrateur | Dennis House Marsden Street M2 1JD Manchester | 38962110002 | |||||||
| INHOCO FORMATIONS LIMITED | Administrateur désigné | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006560001 |
INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 28 mars 2003 Livré le 12 avr. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 24 janv. 2002 Livré le 30 janv. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 30 nov. 1995 Livré le 02 déc. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or by the companies hereinafter defined ("the customer") and all monies agreed to be paid by the company in accordance with the provisions of any guarantee or guarantees given by the company to the yorkshire bank public limited company in respect of the indebtedness and liability of the customer or any company or companies which may constitute a subsidiary or subsidiaries of the charging company or of any holding company or any (as therein defined) of the charging company or any company or companies which may be otherwise associated with the charging company in business | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 19 mai 1995 Livré le 23 mai 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0