INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED

INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03045060
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED ?

    • Autres industries manufacturières n.d.a. (32990) / Industries manufacturières

    Où se situe INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP PLC06 avr. 199506 avr. 1995

    Quels sont les derniers comptes de INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Mr Steve Quinlan en tant qu'administrateur le 26 août 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 oct. 2015

    État du capital au 20 oct. 2015

    • Capital: GBP 1,939,100.9
    SH01

    Nomination de James Lamar Herbert en tant qu'administrateur le 26 août 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Paul Gareth Smith en tant que directeur le 26 août 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Gareth Smith en tant que directeur le 26 août 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Leslie Morris en tant que directeur le 26 août 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Colin Goodwille en tant que directeur le 26 août 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Maclaren Cassells en tant que directeur le 26 août 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Gareth Smith en tant que secrétaire le 26 août 2015

    1 pagesTM02

    Nomination de Stephen Jeffrey Irwin Holmes en tant qu'administrateur le 26 août 2015

    2 pagesAP01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2015

    8 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2014

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 oct. 2014

    État du capital au 23 oct. 2014

    • Capital: GBP 1,939,100.9
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Colin Goodwille le 23 oct. 2014

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Ian Leslie Morris en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul Gareth Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2013

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Paul Gareth Smith en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Mark Sullivan en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 oct. 2013

    État du capital au 02 oct. 2013

    • Capital: GBP 1,939,100.9
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2012

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HERBERT, James Lamar
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    United StatesAmerican200649010001
    HOLMES, Stephen Jeffrey Irwin, Dr
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    United KingdomBritish200627160001
    QUINLAN, Steve
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    UsaAmerican203115340001
    BAKER, Edward Matthew Scott
    2 Homelands Close
    Sale
    M33 4EB Manchester
    Secrétaire
    2 Homelands Close
    Sale
    M33 4EB Manchester
    British4668730002
    BROWN, Michael Stewart
    Flat 6 Derwent Park House
    New Road
    DE22 1DR Derby
    Secrétaire
    Flat 6 Derwent Park House
    New Road
    DE22 1DR Derby
    British86327240001
    COTTON, Angela
    3 Ravens Holme
    BL1 5TN Bolton
    Greater Mancheseter
    Secrétaire
    3 Ravens Holme
    BL1 5TN Bolton
    Greater Mancheseter
    British62018140001
    DUNBAR, Stephen John
    43 Cotswold Drive
    Horwich
    BL6 7DE Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    43 Cotswold Drive
    Horwich
    BL6 7DE Bolton
    Lancashire
    British46237640003
    JAMES, Richard David
    19 Mill Close
    WA2 0ST Warrington
    Cheshire
    Secrétaire
    19 Mill Close
    WA2 0ST Warrington
    Cheshire
    British80458850001
    RAPSON, Bernard David
    Bank Cottage Old Forge Lane
    Preston Capes
    NN11 3TD Daventry
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Bank Cottage Old Forge Lane
    Preston Capes
    NN11 3TD Daventry
    Northamptonshire
    British3213310001
    SMITH, Paul Gareth
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Secrétaire
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    184029570001
    SULLIVAN, Mark James
    2 Grange Barn
    Malt Kiln Lane Bispham
    L40 3SH Ormskirk
    Lancashire
    Secrétaire
    2 Grange Barn
    Malt Kiln Lane Bispham
    L40 3SH Ormskirk
    Lancashire
    British101060960001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire désigné
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    BONDSWELL, Andrew
    19 Brier Hill View
    HD2 1JQ Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    19 Brier Hill View
    HD2 1JQ Huddersfield
    West Yorkshire
    British62729310001
    BOWHILL, Keith Nicholas
    Woodside
    Sandy Lane Rushmoor
    GU10 2ET Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Woodside
    Sandy Lane Rushmoor
    GU10 2ET Farnham
    Surrey
    British61679460002
    CASSELLS, John Maclaren, Dr
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    EnglandBritish63881080001
    DAWE, Peter John
    The Manor House 71 High Street
    Oakington
    CB4 5AG Cambridge
    Administrateur
    The Manor House 71 High Street
    Oakington
    CB4 5AG Cambridge
    British48967260001
    EDGE, Christopher Thomas
    Fife House 30a Fife Road
    East Sheen
    SW14 7EL London
    Administrateur
    Fife House 30a Fife Road
    East Sheen
    SW14 7EL London
    EnglandBritish11465390002
    EDWARDS, Stephen Peter
    The Grange
    Lamberhurst Quarter
    TN3 8AN Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    The Grange
    Lamberhurst Quarter
    TN3 8AN Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish147275950001
    GOODWILLE, Colin
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    EnglandBritish3856830002
    GOODWILLE, Fiona Ford
    The Old Rectory Church Lane
    CB3 8QN Papworth Everard
    Cambridge
    Administrateur
    The Old Rectory Church Lane
    CB3 8QN Papworth Everard
    Cambridge
    British20914960001
    GUNLACK, Robert Henry
    Treviades Barton
    High Cross Constantine
    TR11 5RG Falmouth
    Cornwall
    Administrateur
    Treviades Barton
    High Cross Constantine
    TR11 5RG Falmouth
    Cornwall
    EnglandBritish27971040006
    HILLARY, Alan
    1 Cameron Close
    GU6 8EB Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    1 Cameron Close
    GU6 8EB Cranleigh
    Surrey
    United KingdomBritish13184060001
    HOLMES, Andrew Peter Geoffrey
    51 Doneraile Street
    SW6 6EW London
    Administrateur
    51 Doneraile Street
    SW6 6EW London
    EnglandBritish21151650001
    MORRIS, Ian Leslie
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish138377860001
    PRIMROSE, Sandy Blackadder, Doctor
    Amersham Road
    HP13 6QS High Wycombe
    21
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Amersham Road
    HP13 6QS High Wycombe
    21
    Buckinghamshire
    EnglandBritish17972160001
    RAPSON, Bernard David
    Bank Cottage Old Forge Lane
    Preston Capes
    NN11 3TD Daventry
    Northamptonshire
    Administrateur
    Bank Cottage Old Forge Lane
    Preston Capes
    NN11 3TD Daventry
    Northamptonshire
    EnglandBritish3213310001
    SMITH, Paul Gareth
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    EnglandBritish187422070001
    SMITH, Peter James
    19 Coolidge Avenue
    LA1 5ER Lancaster
    Administrateur
    19 Coolidge Avenue
    LA1 5ER Lancaster
    British37288990001
    STANLEY, Christopher John, Dr
    Harradine House Church Street
    Woodhurst
    PE28 3BN Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Harradine House Church Street
    Woodhurst
    PE28 3BN Huntingdon
    Cambridgeshire
    British45065760002
    STEWART, James Alexander
    9 Jameson Street
    W8 7SH London
    Administrateur
    9 Jameson Street
    W8 7SH London
    British13771800001
    SYMS, Allan, Dr
    Customs House Place
    Penarth Marina
    CF64 1TP Vale Of Glamorgan
    12
    Cariff
    Administrateur
    Customs House Place
    Penarth Marina
    CF64 1TP Vale Of Glamorgan
    12
    Cariff
    British128513480001
    THOMAS, Howard
    Wooton Court St Neots Road
    St Neots Road
    PE19 4UU Abbotsley
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Wooton Court St Neots Road
    St Neots Road
    PE19 4UU Abbotsley
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish18174450001
    WALPOLE, Malcolm William
    28 Higher Mead
    RG24 8YL Old Basing
    Hampshire
    Administrateur
    28 Higher Mead
    RG24 8YL Old Basing
    Hampshire
    British107822300001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    Dennis House
    Marsden Street
    M2 1JD Manchester
    Administrateur
    Dennis House
    Marsden Street
    M2 1JD Manchester
    38962110002
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Administrateur désigné
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    INTERNATIONAL DIAGNOSTICS GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 12 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 24 janv. 2002
    Livré le 30 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Quester Vct PLC (The 'Security Trustee')
    Transactions
    • 30 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 nov. 1995
    Livré le 02 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or by the companies hereinafter defined ("the customer") and all monies agreed to be paid by the company in accordance with the provisions of any guarantee or guarantees given by the company to the yorkshire bank public limited company in respect of the indebtedness and liability of the customer or any company or companies which may constitute a subsidiary or subsidiaries of the charging company or of any holding company or any (as therein defined) of the charging company or any company or companies which may be otherwise associated with the charging company in business
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 02 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 mai 1995
    Livré le 23 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0