HATHERLEY HOUSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED

HATHERLEY HOUSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHATHERLEY HOUSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03045202
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HATHERLEY HOUSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?

    • Gestion de la propriété résidentielle (98000) / Activités des ménages employeurs ; activités de production de biens et services non différenciées des ménages pour usage propre

    Où se situe HATHERLEY HOUSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Walmer House
    32 Bath Street
    GL50 1YA Cheltenham
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de HATHERLEY HOUSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le29 sept. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes29 juin 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 sept. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour HATHERLEY HOUSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au12 avr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation26 avr. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au12 avr. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour HATHERLEY HOUSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 sept. 2023

    2 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 29 sept. 2022

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 sept. 2021

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2022 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 sept. 2020

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 sept. 2019

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 sept. 2018

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de St Mary's House 68 Harborne Park Road Harborne Birmingham B17 0DH à Walmer House 32 Bath Street Cheltenham GL50 1YA le 05 avr. 2019

    1 pagesAD01

    Nomination de Cambray Property Management en tant que secrétaire le 01 avr. 2019

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Matthew William Arnold en tant que secrétaire le 01 avr. 2019

    1 pagesTM02

    Comptes de micro-entité établis au 29 sept. 2017

    2 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jake Nickell le 20 avr. 2018

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alan Robert Warburton le 20 avr. 2018

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Alan Robert Warburton en tant qu'administrateur le 01 avr. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Jake Nickell en tant qu'administrateur le 01 avr. 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2016

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 avr. 2016

    État du capital au 18 avr. 2016

    • Capital: GBP 8
    SH01

    Cessation de la nomination de James Simpson Brian Beaton en tant que directeur le 24 mars 2015

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de HATHERLEY HOUSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAMBRAY PROPERTY MANAGEMENT
    32 Bath Street
    GL50 1YA Cheltenham
    Walmer House
    England
    Secrétaire
    32 Bath Street
    GL50 1YA Cheltenham
    Walmer House
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement2836061
    153697630001
    BESWICK, Elizabeth
    Canelletto
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Canelletto
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishEngineer90318620001
    NICKELL, Jake
    Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Monet
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Monet
    Gloucestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSales245534040001
    WARBURTON, Alan Robert
    Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Rembrandt
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Rembrandt
    Gloucestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director233989290001
    ZIMMERMANN, Elizabeth
    Galileo Gardens
    GL51 0GA Cheltenham
    35
    Glos
    United Kingdom
    Administrateur
    Galileo Gardens
    GL51 0GA Cheltenham
    35
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomBritishReceptionist158813360001
    ARNOLD, Matthew William
    Harborne Park Road
    B17 0DH Birmingham
    68
    Secrétaire
    Harborne Park Road
    B17 0DH Birmingham
    68
    British154491180001
    ARNOLD, Matthew William
    7 Vine Terrace
    High Street Harborne
    B17 9PU Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    7 Vine Terrace
    High Street Harborne
    B17 9PU Birmingham
    West Midlands
    BritishChartered Surveyor98434730001
    PAINE, Martin
    Gardeners Cottage
    Brockhampton Park
    GL54 5SP Brockhampton
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Gardeners Cottage
    Brockhampton Park
    GL54 5SP Brockhampton
    Gloucestershire
    BritishProperty Manager79990500001
    SCOTT, Gordon James Peter
    7 Vine Terrace
    High Street Harborne
    B17 9PU Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    7 Vine Terrace
    High Street Harborne
    B17 9PU Birmingham
    West Midlands
    BritishChartered Surveyor39493010001
    STRICKLAND, John
    3 Bryn Cerrig
    Lixwm
    CH8 8PF Holywell
    Flintshire
    Secrétaire
    3 Bryn Cerrig
    Lixwm
    CH8 8PF Holywell
    Flintshire
    British99301530001
    COSEC MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    The Gardens
    Office Village
    PO16 8SS Fareham
    2
    Hampshire
    Secrétaire
    The Gardens
    Office Village
    PO16 8SS Fareham
    2
    Hampshire
    136446990002
    COUNTRYWIDE PROPERTY MANAGEMENT
    161 New Union Street
    CV1 2PL Coventry
    Warwickshire
    Secrétaire
    161 New Union Street
    CV1 2PL Coventry
    Warwickshire
    114268580001
    JOHNSON FRY SECRETARIES LTD
    Dorland House
    20 Regent Street
    SW1Y 4PZ London
    Secrétaire
    Dorland House
    20 Regent Street
    SW1Y 4PZ London
    33216460001
    BAKER, Stephen William
    Renoir Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Renoir Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Director58863680002
    BEATON, James Simpson Brian
    Monet Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Glos
    Administrateur
    Monet Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Glos
    BritishRetired125284080001
    CLARK, Angela Faith
    Holbein Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Holbein Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishSenior Sales Manager Housing D119210990001
    CLARKE, Robert Ian
    Allenfield Road
    CL53 0NA Cheltenham
    4
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Allenfield Road
    CL53 0NA Cheltenham
    4
    Gloucestershire
    United Kingdom
    BritainBritishIndependent Financial Advisor141347940001
    COOPER, Louise Helen
    Van Gogh Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Van Gogh Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishInsurance Manager81374360001
    KNIGHT, Joanna
    Vangough Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Vangough Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishClinical Research99379140001
    MURDOCH, Thomas, Doctor
    Flat 7 Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6PX Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Flat 7 Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6PX Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCivil Servant81641590001
    REES, Elizabeth
    Canaletto Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Canaletto Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishRetired56103360002
    RHIND, George
    21 St Georges Road
    GL50 3DT Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    21 St Georges Road
    GL50 3DT Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishProperty Manager107988180002
    ROBSON, Christopher Bryan
    21 Greenside Drive
    SG5 2LP Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    21 Greenside Drive
    SG5 2LP Hitchin
    Hertfordshire
    BritishBarrister56103470002
    RUSSELL, John
    14 The Withers
    Bishops Cleeve
    GL52 4WE Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    14 The Withers
    Bishops Cleeve
    GL52 4WE Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishProject Manager63896080001
    SAUNDERS, Timothy
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    Administrateur
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    EnglandBritishChartered Accountant47952140001
    STRICKLAND, John
    3 Bryn Cerrig
    Lixwm
    CH8 8PF Holywell
    Flintshire
    Administrateur
    3 Bryn Cerrig
    Lixwm
    CH8 8PF Holywell
    Flintshire
    BritishProperty Manager99301530001
    TANG, Michael
    Renoir Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Renoir Hatherley House
    Hatherley Road
    GL51 6EB Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishProject Manager79078890001
    VERNOIT, Arthur Sydney
    The Nogyns
    Yarkhill
    HR1 3ST Hereford
    Herefordshire
    Administrateur
    The Nogyns
    Yarkhill
    HR1 3ST Hereford
    Herefordshire
    BritishRetired56483580001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour HATHERLEY HOUSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    12 avr. 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0