AXSIA LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAXSIA LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03047122
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AXSIA LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe AXSIA LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AXSIA LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TGE GROUP LIMITED27 déc. 199527 déc. 1995
    222ND SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED11 avr. 199511 avr. 1995

    Quels sont les derniers comptes de AXSIA LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour AXSIA LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Divers

    Section 519
    2 pagesMISC

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 100 New Bridge Street London EC4V 6JA United Kingdom le 06 sept. 2011

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 25 août 2011

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    19 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 mai 2011

    État du capital au 06 mai 2011

    • Capital: GBP 7,178,000
    SH01

    legacy

    3 pagesMG02

    Modification des coordonnées du secrétaire Cheryl Lynn Roberts le 15 janv. 2011

    3 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Cheryl Lynn Roberts le 15 janv. 2011

    3 pagesCH01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    11 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Nomination de Abogado Mominees Limited en tant que secrétaire

    3 pagesAP04

    Nomination de Cheryl Lynn Roberts en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Nomination de Cheryl Lynn Roberts en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de George Mackie en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de George Mackie en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    19 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de Voyager, Apollo Rise Farnborough Hampshire GU14 0NP le 12 mars 2010

    1 pagesAD01

    Nomination de George Mackie en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de George Mackie en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Nomination de Grace B Holmes en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de AXSIA LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOLMES, Grace B
    West Loop South
    Suite 1700
    Houston
    1333
    Texas
    United States
    Secrétaire
    West Loop South
    Suite 1700
    Houston
    1333
    Texas
    United States
    British148234690001
    ROBERTS, Cheryl Lynn
    LS10 1SB Stourton
    Queen Street
    N Yorkshire
    Secrétaire
    LS10 1SB Stourton
    Queen Street
    N Yorkshire
    British155130300001
    ABOGADO MOMINEES LIMITED
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    Secrétaire
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1688036
    155131160001
    HOLMES, Grace Bellinger
    West Loop South
    Suite 1700
    Houston
    1333
    Texas
    United States
    Administrateur
    West Loop South
    Suite 1700
    Houston
    1333
    Texas
    United States
    UsaAmericanBusiness Executive175376460001
    ROBERTS, Cheryl Lynn
    LS10 1SD Leeds
    Queen Street
    West Yorkshire
    Administrateur
    LS10 1SD Leeds
    Queen Street
    West Yorkshire
    UkAmericanBusiness Executive155129070002
    CARTER, Daniel Roland
    1706 Lofty Maple Trail
    Kingswood
    Texas 77345
    Usa
    Secrétaire
    1706 Lofty Maple Trail
    Kingswood
    Texas 77345
    Usa
    Usa CitizenLawyer75589300001
    ELLIS, Katherine
    11210 Equity Drive
    77041
    77092 Houston
    Suite 100
    Texas
    Usa
    Secrétaire
    11210 Equity Drive
    77041
    77092 Houston
    Suite 100
    Texas
    Usa
    OtherAttorney108408540003
    GREGORY, Roger Leslie
    10 Albert Road
    Pittville
    GL52 2QX Cheltenham
    Secrétaire
    10 Albert Road
    Pittville
    GL52 2QX Cheltenham
    British49242490002
    HOPE, David
    Fairly
    Midford
    BA2 7BY Bath
    North East Somerset
    Secrétaire
    Fairly
    Midford
    BA2 7BY Bath
    North East Somerset
    UkFinance Director84781010001
    JACKSON, Martin Andrew
    6 Bergamot Close
    Manton
    SN8 4HT Marlborough
    Wiltshire
    Secrétaire
    6 Bergamot Close
    Manton
    SN8 4HT Marlborough
    Wiltshire
    British79619260001
    MACKIE, George
    Pinewood Gate
    HG2 0JF Harrogate
    1
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Pinewood Gate
    HG2 0JF Harrogate
    1
    North Yorkshire
    British148234720001
    SAMPSON, Lynne Jones
    6 Penner Close
    SW19 6QA London
    Secrétaire
    6 Penner Close
    SW19 6QA London
    BritishGroupfinancialcontroller70983510001
    WRIGLEY, Graham Lloyd
    4 Adie Road
    W6 0PW London
    Secrétaire
    4 Adie Road
    W6 0PW London
    BritishDirector42659840001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Secrétaire désigné
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    COPE, John Arthur
    Thornwick Lodge Station Road
    DE45 1GA Bakewell
    Derbyshire
    Administrateur
    Thornwick Lodge Station Road
    DE45 1GA Bakewell
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector8678230001
    HOPE, David
    Fairly
    Midford
    BA2 7BY Bath
    North East Somerset
    Administrateur
    Fairly
    Midford
    BA2 7BY Bath
    North East Somerset
    EnglandUkDirector84781010001
    MACKIE, George
    Pinewood Gate
    HG2 0JF Harrogate
    1
    North Yorkshire
    Administrateur
    Pinewood Gate
    HG2 0JF Harrogate
    1
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director41724840001
    MAYER, Joseph Michael
    6922 Buffkin
    Houston
    Texas
    Administrateur
    6922 Buffkin
    Houston
    Texas
    UsaChf Fin Officer75588540001
    MCBRIDE, John Kristian Lars
    61 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DN London
    Administrateur
    61 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DN London
    EnglandBritishDirector54651830001
    MICHALUK, Peter Gregory
    91 Brookfield Road
    Churchdown
    GL3 2PN Gloucester
    Gloucestershire
    Administrateur
    91 Brookfield Road
    Churchdown
    GL3 2PN Gloucester
    Gloucestershire
    BritishDirector67772880001
    TWIGGER, Terence
    The Walled Garden Holly Hill Lane
    Sarisbury Green
    SO31 7AH Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    The Walled Garden Holly Hill Lane
    Sarisbury Green
    SO31 7AH Southampton
    Hampshire
    EnglandBritishFinancial Director45754710002
    WRIGLEY, Graham Lloyd
    4 Adie Road
    W6 0PW London
    Administrateur
    4 Adie Road
    W6 0PW London
    BritishDirector42659840001
    LOVITING LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Administrateur désigné
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001760001
    SERJEANTS' INN NOMINEES LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Administrateur désigné
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001750001

    AXSIA LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement and guarantee
    Créé le 15 mars 2004
    Livré le 25 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any U.K. lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All security created under the security agreement being investments plant and machinery credit balances book debts insurances other contracts intellectual property and floating charge all assets not otherwise effectively mortgaged charged or assigned. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC (The UK Agent) as Agent and Trustee for the U.K. Lenders
    Transactions
    • 25 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 16 mars 2001
    Livré le 04 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the company to any UK lender under each loan document (all terms as defined)
    Brèves mentions
    The investments plant and machinery credit balances book debts insurances other contracts intellectual property miscellaneous by way of first floating charge all its assets not otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under this paragraph 1. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Chase Manhattan International Limited
    Transactions
    • 04 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 01 mai 1998
    Livré le 05 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined) and the debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed
    Créé le 19 sept. 1996
    Livré le 01 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to all or any of the financing documents (as defined in the credit agreement dated 21ST december 1995)
    Brèves mentions
    Assigns all the companies rights title and interest present and future in all and each of the acquisition documents (as therein defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Working capital collateral account charge
    Créé le 21 août 1996
    Livré le 05 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the secured parties (as defined therein) under or pursuant to any of the financing documents
    Brèves mentions
    All the company's right title benefit and interest in and to the charged account being the company's account 95600523 held with the bank and designated "natwest bank re: tge group limited" including, without limitation, the balances standing to the credit of the charged account.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of rent deposit
    Créé le 08 juil. 1996
    Livré le 12 juil. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a rent deposit deed of even date
    Brèves mentions
    The sum of £3,750 charge to the chargee as security for the due performance and observance of the covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Csa Limited
    Transactions
    • 12 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Keyman insurance assignment
    Créé le 21 déc. 1995
    Livré le 28 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from the company formerly known as 222ND shelf investment company limited to national westminster bank PLC in its capacity as facility agent,security trustee and overdraft bank and to the banks (as defined) under or pursuant to all or any of the financing documents (as defined) including this deed
    Brèves mentions
    By way of assignment the company's interest and benefit in and to the policies (as defined) and all moneys thereby assured which may become payable thereunder and the full benefit thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 21 déc. 1995
    Livré le 28 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from the company formerly known as 222ND shelf investment company limited to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined) including this deed
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    AXSIA LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    25 août 2011Commencement of winding up
    08 août 2012Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0