ALVIS BRIDGING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALVIS BRIDGING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03057366
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALVIS BRIDGING LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe ALVIS BRIDGING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Warwick House
    PO BOX 87
    GU14 6YU Farnborough Aerospace Centre
    Farnborough Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALVIS BRIDGING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALVIS ENTERPRISES LTD.31 mai 200031 mai 2000
    ALVIS UNIPOWER LIMITED25 mars 199625 mars 1996
    PREMIERE PROMOTIONS (UK) LIMITED11 mai 199511 mai 1995

    Quels sont les derniers comptes de ALVIS BRIDGING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour ALVIS BRIDGING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 mai 2013

    État du capital au 15 mai 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Résolutions

    Resolutions
    30 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Delete mem 14/04/2011
    RES13

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire David Stanley Parkes le 06 nov. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Stanley Parkes le 06 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ann Louise Holding le 03 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    4 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    4 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2004

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ALVIS BRIDGING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PARKES, David Stanley
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Secrétaire
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    British25179240002
    HOLDING, Ann-Louise
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Administrateur
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    EnglandBritish73464490003
    PARKES, David Stanley
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Administrateur
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    EnglandBritish25179240002
    EARDLEY, Barry Eric
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    Secrétaire
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    British36645710001
    EARDLEY, Barry Eric
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    Secrétaire
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    British36645710001
    GULLIS, Anthony Stanley
    75 High Road
    Leavesden
    WD2 7AL Watford
    Secrétaire
    75 High Road
    Leavesden
    WD2 7AL Watford
    British52564150001
    JARMAN, Patrick Edmund
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    Secrétaire
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    British66608960002
    RUTLAND SECRETARIES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Secrétaire désigné
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005290001
    BARNES, Howard Godfrey
    Lower Farm Lower Road
    Postcombe
    OX9 7DU Thame
    Oxfordshire
    Administrateur
    Lower Farm Lower Road
    Postcombe
    OX9 7DU Thame
    Oxfordshire
    EnglandBritish30700140001
    CLAYTON, Ian Duncan
    12 Wendover Close
    AL4 9JW St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    12 Wendover Close
    AL4 9JW St. Albans
    Hertfordshire
    British78974470001
    EARDLEY, Barry Eric
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    Administrateur
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    British36645710001
    GREENSLADE, Martin Frederick
    2 The Glade
    TN13 3HD Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    2 The Glade
    TN13 3HD Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish17633990002
    JARMAN, Patrick Edmund
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    Administrateur
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    British66608960002
    MITCHELL, Stuart Roger
    Little Trees Queens Hill Rise
    SL5 7DP Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Little Trees Queens Hill Rise
    SL5 7DP Ascot
    Berkshire
    New Zealand1447530001
    MITCHELL, Stuart Roger
    Little Trees Queens Hill Rise
    SL5 7DP Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Little Trees Queens Hill Rise
    SL5 7DP Ascot
    Berkshire
    New Zealand1447530001
    PEARSON, Anthony Ralph
    15 Oakfields Road
    SG3 6NS Knebworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    15 Oakfields Road
    SG3 6NS Knebworth
    Hertfordshire
    British8659000001
    PEARSON, Anthony Ralph
    15 Oakfields Road
    SG3 6NS Knebworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    15 Oakfields Road
    SG3 6NS Knebworth
    Hertfordshire
    British8659000001
    ROWE, Christopher Gordon
    Bluebell Grange
    Allscott
    TF6 5EB Telford
    Salop
    Administrateur
    Bluebell Grange
    Allscott
    TF6 5EB Telford
    Salop
    British113894430001
    RUTLAND DIRECTORS LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Administrateur désigné
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005280001

    ALVIS BRIDGING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    An omnibus guarantee and set-off agreement dated 17/12/03
    Créé le 10 févr. 2004
    Livré le 11 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any ofthem with the bank (including any accounts held in the banks name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 11 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 17 déc. 2003
    Livré le 19 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present and future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in any other currency.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of admission to a composite guarantee and debenture dated 2 november 1998
    Créé le 15 mai 2003
    Livré le 21 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 21 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of admission to a composite guarantee and debenture dated 2 november 1998
    Créé le 15 mai 2003
    Livré le 21 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Floating charge over all undertaking property assets and revenues.
    Personnes ayant droit
    • Alvis PLC
    Transactions
    • 21 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture in relation to a £20,000,000 multi-currency revolving credit facility
    Créé le 02 nov. 1998
    Livré le 18 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities whether present or future,actual or contingent (including further advances made after the date of the debenture by any beneficiary,as defined) which then were or at any time thereafter might be due,owing or incurred by the relevant company to any beneficiary under or in connection with the finance documents (as defined) and all other monies and liabilities whether present or future,actual or contingent which then were or at any time thereafter might be due,owing or incurred to any beneficiary by any other relevant company or by ah under or in connection with the finance documents (except any monies or liabilities due,owing or incurred by such other relevant company or by ah as guarantor for the relevant company)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC,as Trustee
    Transactions
    • 18 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture in relation to a swedish kroner 401,040,000 multi-currency term loan facility
    Créé le 02 nov. 1998
    Livré le 18 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities whether present or future,actual or contingent (including further advances made after the date of the debenture by any beneficiary,as defined) which then were or at any time thereafter might be due,owing or incurred by the relevant company to any beneficiary under or in connection with the finance documents (as defined) and all other monies and liabilities whether present or future,actual or contingent which then were or at any time thereafter might be due,owing or incurred to any beneficiary by any other relevant company or by ah under or in connection with the finance documents (except any monies or liabilities due,owing or incurred by such other relevant company or by ah as guarantor for the relevant company)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC,as Trustee
    Transactions
    • 18 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 02 nov. 1998
    Livré le 18 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and liabilities whether present or future,actual or contingent (including further advances made after the date of the debenture by the bank)which then were or at any time thereafter may be due owing or incurred by the relevant company to the bank on any current account or in any manner whatsoever without limitation (but excluding any sums owing or liabilities incurred by the relevant company under the syndicated finance documents,as defined) and all other moneys and liabilities whether present or future,actual or contingent which then were or at any time thereafter might be due owing or incurred by any other company or ah on any current account or in any manner whatsoever without limitation (but excluding (I) any sums owing or liabilities incurred by such other company or ah under the syndicated finance documents,as defined and (ii) any moneys or liabilities due owing or incurred by such other company or ah as guarantor for the relevant company)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 18 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture relating to a £20,000,000 multi-currency revolving credit facility
    Créé le 02 nov. 1998
    Livré le 18 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alvis PLC
    Transactions
    • 18 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture relating to a swedish kroner 401,040,000 multi-currency term loan facility
    Créé le 02 nov. 1998
    Livré le 18 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alvis PLC
    Transactions
    • 18 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 02 nov. 1998
    Livré le 18 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alvis PLC
    Transactions
    • 18 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 22 oct. 1997
    Livré le 07 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities present and future actual or contingent due or to become due from the company to lloyds bank PLC on any current accont or in any manner whatsoever (but excluding any sums owing or liabilities incurred by the company under the syndicated finance documents) and all monies and liabilities present and future actual or contingent due or to become due by any obligors (other than the company) or newco on any current account and in any manner whatsoever (but excluding (I) any sums owing or liabilities incurred by such other obliors or newco under the syndicated finance documents and (ii) any moneys or liabilities due owing or incurred by such obligors or newco as guarantor for the company).
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 22 oct. 1997
    Livré le 12 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Brèves mentions
    Floating charge all the company's undertaking property and assets presen t and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alvis PLC
    Transactions
    • 12 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 22 oct. 1997
    Livré le 07 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any obligor other than the company or newco to the chargees under the terms of the finance documents (as defined in the debenture) except any moneys or liabilities due owing or incurred by such obligor(s) or by newco as guarantor for the company
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC(The "Trustee")
    Transactions
    • 07 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 22 oct. 1997
    Livré le 07 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Brèves mentions
    Floating charge all the company's undertaking property assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alvis PLC
    Transactions
    • 07 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 22 oct. 1997
    Livré le 07 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    By way of floating charge, all its undertaking, property, assets and revenues both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Alvis PLC("Alvis")
    Transactions
    • 07 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0