MLS BUSINESS SERVICES LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMLS BUSINESS SERVICES LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03057737
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MLS BUSINESS SERVICES LTD ?

    • (9305) /

    Où se situe MLS BUSINESS SERVICES LTD ?

    Adresse du siège social
    100-102 St James Road
    NN5 5LF Northampton
    Northamptonshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MLS BUSINESS SERVICES LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MLS PROPERTIES LTD.17 mai 199517 mai 1995

    Quels sont les derniers comptes de MLS BUSINESS SERVICES LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour MLS BUSINESS SERVICES LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    13 pages4.72

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 janv. 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 juil. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 janv. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 juil. 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 janv. 2010

    5 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 07 janv. 2009

    LRESEX

    legacy

    1 pages287

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 août 2006

    18 pagesAA

    legacy

    5 pages395

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages403a

    Qui sont les dirigeants de MLS BUSINESS SERVICES LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MOYS, Peter John
    Little Harestone
    63 Harestone Valley Road
    CR3 6HP Caterham
    Surrey
    Secrétaire
    Little Harestone
    63 Harestone Valley Road
    CR3 6HP Caterham
    Surrey
    BritishGroup Finance Director118959200001
    MOYS, Peter John
    Little Harestone
    63 Harestone Valley Road
    CR3 6HP Caterham
    Surrey
    Administrateur
    Little Harestone
    63 Harestone Valley Road
    CR3 6HP Caterham
    Surrey
    United KingdomBritishGroup Finance Director118959200001
    WILLIAMS, Paul Barrington
    Blue Barn Farm
    St Georges Hill
    KT13 0NH Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Blue Barn Farm
    St Georges Hill
    KT13 0NH Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishDirector35529540005
    MLS BUSINESS SERVICES MANAGEMENT LTD
    Lyon House
    160-166 Borough High Street Borough
    SE1 1JR London
    Administrateur
    Lyon House
    160-166 Borough High Street Borough
    SE1 1JR London
    114986720001
    BAKER, Stephen Peter
    Little Heath
    Rose Hill
    TN22 5UH Isfield
    East Sussex
    Secrétaire
    Little Heath
    Rose Hill
    TN22 5UH Isfield
    East Sussex
    BritishOperations Director113510780001
    COLE, Jeremy Leslie
    37 Stirling Road
    SW9 9EF London
    Secrétaire
    37 Stirling Road
    SW9 9EF London
    BritishAccountant43093890002
    KING, Elizabeth Catherine
    Berries 35 Chalfont Road
    Seer Green
    HP9 2QP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Berries 35 Chalfont Road
    Seer Green
    HP9 2QP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary99986130002
    MAY, Eerald Michael Eisdell
    15 Hornbeam Road
    IG9 6JT Buckhurst Hill
    Essex
    Secrétaire
    15 Hornbeam Road
    IG9 6JT Buckhurst Hill
    Essex
    BritishFinancial Controller118098440001
    WILLIAMS, Martin John
    Chestnut Lodge
    Boxhill Road Box Hill
    KT20 7JS Tadworth
    Surrey
    Secrétaire
    Chestnut Lodge
    Boxhill Road Box Hill
    KT20 7JS Tadworth
    Surrey
    British95198340001
    WILLIAMS, Paul Barrington
    Blue Barn Farm
    St Georges Hill
    KT13 0NH Weybridge
    Surrey
    Secrétaire
    Blue Barn Farm
    St Georges Hill
    KT13 0NH Weybridge
    Surrey
    BritishCompany Secretary35529540005
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BAKER, Stephen Peter
    Little Heath
    Rose Hill
    TN22 5UH Isfield
    East Sussex
    Administrateur
    Little Heath
    Rose Hill
    TN22 5UH Isfield
    East Sussex
    BritishCompany Director113510780001
    COLE, Jeremy Leslie
    161 Park South
    Austin Road Battersea
    SW11 5JN London
    Administrateur
    161 Park South
    Austin Road Battersea
    SW11 5JN London
    BritishAccountant43093890001
    CROSS, Kimberley
    Hunters Lodge Hillbrow Road
    KT10 9UD Esher
    Surrey
    Administrateur
    Hunters Lodge Hillbrow Road
    KT10 9UD Esher
    Surrey
    BritishDirector19940740001
    PRICE, Rachel Elizabeth
    Granary Cottage
    Blue Barn Farm, Blue Barn Lane
    KT13 0NH Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Granary Cottage
    Blue Barn Farm, Blue Barn Lane
    KT13 0NH Weybridge
    Surrey
    BritishChartered Accountant71964680001

    MLS BUSINESS SERVICES LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 24 sept. 2007
    Livré le 27 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 27 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27TH january 2006
    Créé le 15 août 2006
    Livré le 17 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 17 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 27 janv. 2006
    Livré le 02 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 02 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 19 janv. 2006
    Livré le 21 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 21 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rebnt deposit deed
    Créé le 20 juil. 2001
    Livré le 27 juil. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the performance of the covenants on the part of the tenant contained in leases of various dates.
    Brèves mentions
    £141,000 or such other monies as shall constitute the rent deposit deed from time to time under the terms of the rent deposit deed in a designated account at the united bank of kuwait PLC 15 baker street,london W1 or such bank as from time to time in which the rent deposit is placed.
    Personnes ayant droit
    • Paragon Developments Limited
    Transactions
    • 27 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 12 avr. 2001
    Livré le 02 mai 2001
    En cours
    Montant garanti
    £262,097.50 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The sum of £262,097.50 held in any bank account under the terms of a rent deposit deed dated 12 april 2001 relating to the first and fourth floors fina house 1 ashley avenue epsom surrey.
    Personnes ayant droit
    • Totalfinaelf Downstream UK PLC
    Transactions
    • 02 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Deed
    Créé le 12 avr. 2001
    Livré le 14 avr. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease (as defined)
    Brèves mentions
    The sum of £200,200.
    Personnes ayant droit
    • Woburn Estate Company Limited and Bedford Estates Nominees Limited
    Transactions
    • 14 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 02 févr. 2001
    Livré le 08 févr. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and the lease of even date defined therein
    Brèves mentions
    All the company's right title benefit and interest in and to the deposit account in which the security (as defined in the deed) is placed and all related rights thereof under the terms of the deed.
    Personnes ayant droit
    • The London Mathematical Society
    Transactions
    • 08 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 04 sept. 2000
    Livré le 06 sept. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the deed dated 4 september 2000
    Brèves mentions
    The equitable interest of the debtor in the security deposit as defined in the rent deposit deed.
    Personnes ayant droit
    • Woburn Estate Company Limited and Bedford Estates Nominees Limited
    Transactions
    • 06 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 13 juil. 1999
    Livré le 14 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 13 juil. 1999
    Livré le 14 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Delta house 175-177 borough high street london (freehold). With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 13 juil. 1999
    Livré le 14 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Hyde park house manfred road london (freehold). With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 juin 1995
    Livré le 04 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Hyde park house, 5 manfred road, london.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MLS BUSINESS SERVICES LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 août 2012Dissolved on
    07 janv. 2009Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alan Roy Limb
    100-102 St James Road
    NN5 5LF Northampton
    Northamptonshire
    practitioner
    100-102 St James Road
    NN5 5LF Northampton
    Northamptonshire
    Peter John Windatt
    Bri Business Recovery
    100-102 St James Road
    Northampton
    Nn5 5lf
    practitioner
    Bri Business Recovery
    100-102 St James Road
    Northampton
    Nn5 5lf

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0