MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED

MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03059563
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED ?

    • (9220) /

    Où se situe MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    13 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 févr. 2017

    14 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 févr. 2016

    16 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 févr. 2015

    20 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 févr. 2014

    10 pages4.68

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    2.34B

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:replacement of liquidator ;- s m rayment replaces a h beckingham 15/11/2013
    14 pagesLIQ MISC OC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Cessation de la nomination de Emmanuelle Namiech en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    15 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 27 août 2012

    15 pages2.24B

    Cessation de la nomination de Alison Rayson en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Résultat de la réunion des créanciers

    4 pages2.23B

    Résultat de la réunion des créanciers

    4 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    92 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    14 pages2.16B

    Modification des coordonnées de l'administrateur Alison Dawn Rayson le 21 oct. 2011

    2 pagesCH01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Changement d'adresse du siège social de * 2Nd Floor Garfield House 86-88 Edgware Road London W2 2EA* le 05 mars 2012

    2 pagesAD01

    legacy

    8 pagesMG01

    Nomination de Mrs Emmanuelle Namiech en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    20 pagesAA

    Nomination de Mr Mark Andrew Webster en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Miss Deborah Margaret Brown en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BROWN, Deborah Margaret
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Secrétaire
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    162200060001
    WEBSTER, Mark Andrew
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritish165027120001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    FERMAN, David Leonard Paul
    4 Church Farm Close
    Hoo
    ME3 9AY Rochester
    Kent
    Secrétaire
    4 Church Farm Close
    Hoo
    ME3 9AY Rochester
    Kent
    British35553740001
    GIBBONS, Nigel
    Ockford Wood Farm
    New Way
    GU7 2QL Godalming
    Surrey
    Secrétaire
    Ockford Wood Farm
    New Way
    GU7 2QL Godalming
    Surrey
    British39895440002
    KIRBY, Robert Henry
    Shortlands Road
    KT2 6HD Kingston-Upon-Thames
    36
    Surrey
    Secrétaire
    Shortlands Road
    KT2 6HD Kingston-Upon-Thames
    36
    Surrey
    British131528280001
    ROBERTS, Jeremy Charles
    14 Perryn House
    Bromyard Avenue
    W3 7JD London
    Secrétaire
    14 Perryn House
    Bromyard Avenue
    W3 7JD London
    British86671080001
    TAYLOR, Richard George
    72 Hall Green Lane
    Hutton
    CM13 2QT Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    72 Hall Green Lane
    Hutton
    CM13 2QT Brentwood
    Essex
    British47989960001
    THOM, Alastair Stephen
    13 The Meadway
    IG9 5PG Buckhurst Hill
    Essex
    Secrétaire
    13 The Meadway
    IG9 5PG Buckhurst Hill
    Essex
    British9591260001
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Secrétaire désigné
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Secrétaire
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Administrateur
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Administrateur
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    GIBBONS, Nigel
    Ockford Wood Farm
    New Way
    GU7 2QL Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Ockford Wood Farm
    New Way
    GU7 2QL Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish39895440002
    HARMAN, Phillip Brent
    1 Cartwright Way
    Barnes
    SW13 8HD London
    Administrateur
    1 Cartwright Way
    Barnes
    SW13 8HD London
    New Zealander51102310001
    LIGHTING, Jane Elizabeth Stuart
    Flat 1 2 Holford Road
    Hampstead
    NW3 1AD London
    Administrateur
    Flat 1 2 Holford Road
    Hampstead
    NW3 1AD London
    United KingdomBritish49969850002
    LUIZ, Mark Walter
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    Administrateur
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    British37860010002
    NAMIECH, Emmanuelle
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    UkFrench165108170001
    OPIE, Lisa Moreen
    6 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish88563310001
    RAYSON, Alison Dawn
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritish139392710003
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    British79956240002
    STENHAM, Anthony William Paul
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    Administrateur
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    British8281170001
    WALL, Malcolm Robert
    The Close
    2 Longfield Drive East Sheen
    SW14 7AU London
    Administrateur
    The Close
    2 Longfield Drive East Sheen
    SW14 7AU London
    EnglandBritish178772080002
    WHEBLE, Anthony
    Oakway House
    5 Birchwood Road
    BR5 1NX Orpington
    Kent
    Administrateur
    Oakway House
    5 Birchwood Road
    BR5 1NX Orpington
    Kent
    British67960870002
    CHETTLEBURGH'S LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Administrateur désigné
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000850001
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Administrateur
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Administrateur
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 01 févr. 2012
    Livré le 03 févr. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Metrodome Group PLC
    Transactions
    • 03 févr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 24 janv. 2011
    Livré le 28 janv. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 28 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 19 févr. 2008
    Livré le 27 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite debenture
    Créé le 03 mars 2006
    Livré le 10 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 10 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 10 mai 2005
    Livré le 18 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any of the chargors to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 18 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 02 mars 2000
    Livré le 16 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the beneficiaries (as defined) (in this capacity the "security trustee") under or pursuant to the transaction documents (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All stocks shares and securities of any kind whatsoever whether marketable or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Toronto-Dominion Bank
    Transactions
    • 16 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 19 juin 1995
    Livré le 26 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 févr. 2012Administration started
    28 févr. 2013Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Andrew Howard Beckingham
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Shay Bannon
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    2
    DateType
    28 févr. 2013Commencement of winding up
    14 mai 2018Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Andrew Howard Beckingham
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    James Joseph Bannon
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Sarah Megan Rayment
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0