BRETTS (HOLDINGS) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BRETTS (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03064951 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BRETTS (HOLDINGS) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Parkwood Sutton Road ME15 9NE Maidstone England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BRETTS (HOLDINGS) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour BRETTS (HOLDINGS) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 oct. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 13 Craven Street London WC2N 5PB England à 23 Kings Hill Avenue Kings Hill West Malling ME19 4UA | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Notification de S G Court Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 nov. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Philip Joseph Brown en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 nov. 2016 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Patricia Mary Brown en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 nov. 2016 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Warren House Warren Road Kingston upon Thames Surrey KT2 7HY à Parkwood Sutton Road Maidstone ME15 9NE le 08 nov. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Victoria Kathleen Louise Good en tant que directeur le 07 nov. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Oliver Liam O'callaghan-Brown en tant que directeur le 07 nov. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Patricia Mary Brown en tant que directeur le 07 nov. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Patricia Mary Brown en tant que secrétaire le 07 nov. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Ms Alison Ware en tant que secrétaire le 07 nov. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr John Patrick Mcconville en tant qu'administrateur le 07 nov. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 oct. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip Joseph Brown en tant que directeur le 23 avr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 19 Craven Street London WC2N 5PB United Kingdom à 13 Craven Street London WC2N 5PB | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de BRETTS (HOLDINGS) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARE, Alison | Secrétaire | Sutton Road ME15 9NE Maidstone Parkwood England | 218048310001 | |||||||
| MCCONVILLE, John Patrick | Administrateur | 40 Hillydeal Road Otford TN14 5RU Sevenoaks The Old Pump House England | England | British | 214500770001 | |||||
| BROWN, Patricia Mary | Secrétaire | Warren Road KT2 7HY Kingston Upon Thames Warren House Surrey | British | 3829080005 | ||||||
| RODWELL, Elizabeth Jane | Secrétaire | Stonybank 87 The Street Crowmarsh Gifford OX10 8EF Wallingford Oxfordshire | British | 43519180002 | ||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire désigné | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
| BROWN, Patricia Mary | Administrateur | Warren Road KT2 7HY Kingston Upon Thames Warren House Surrey | England | British | 3829080005 | |||||
| BROWN, Philip Joseph, Dr | Administrateur | Warren Road KT2 7HY Kingston Upon Thames Warren House Surrey | England | British | 99033870001 | |||||
| GOOD, Victoria Kathleen Louise | Administrateur | Warren Road KT2 7HY Kingston Upon Thames Warren House Surrey | England | British | 188389200001 | |||||
| O'CALLAGHAN-BROWN, Oliver Liam | Administrateur | Warren Road KT2 7HY Kingston Upon Thames Warren House Surrey | England | British | 191308240001 | |||||
| RODWELL, Elizabeth Jane | Administrateur | Stonybank 87 The Street Crowmarsh Gifford OX10 8EF Wallingford Oxfordshire | United Kingdom | British | 43519180002 | |||||
| RODWELL, Paul Robert | Administrateur | 87 The Street Crowmarsh Gifford OX10 8EF Wallingford Oxfordshire | United Kingdom | British | 53895920001 | |||||
| LONDON LAW SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BRETTS (HOLDINGS) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S G Court Limited | 07 nov. 2016 | Sutton Road ME15 9NE Maidstone Parkwood England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mrs Patricia Mary Brown | 06 avr. 2016 | Sutton Road ME15 9NE Maidstone Parkwood England | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Dr Philip Joseph Brown | 06 avr. 2016 | Sutton Road ME15 9NE Maidstone Parkwood England | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
BRETTS (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Créé le 06 août 2008 Livré le 14 août 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All the interest in the account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 06 août 2008 Livré le 12 août 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 25C high street stanford in the vale faringdon, by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 30 sept. 2004 Livré le 02 oct. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 2-3 high street ashley heath ringwood. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 08 nov. 2000 Livré le 16 nov. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The f/h property k/a 11 & 12 millbrook square grove wantage oxfordshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 29 sept. 2000 Livré le 05 oct. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 10 juil. 1997 Livré le 31 juil. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0