BRETTS (HOLDINGS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRETTS (HOLDINGS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03064951
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRETTS (HOLDINGS) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe BRETTS (HOLDINGS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Parkwood
    Sutton Road
    ME15 9NE Maidstone
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BRETTS (HOLDINGS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour BRETTS (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 oct. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 13 Craven Street London WC2N 5PB England à 23 Kings Hill Avenue Kings Hill West Malling ME19 4UA

    1 pagesAD02

    Notification de S G Court Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 nov. 2016

    2 pagesPSC02

    Cessation de Philip Joseph Brown en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 nov. 2016

    1 pagesPSC07

    Cessation de Patricia Mary Brown en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 nov. 2016

    1 pagesPSC07

    Changement d'adresse du siège social de Warren House Warren Road Kingston upon Thames Surrey KT2 7HY à Parkwood Sutton Road Maidstone ME15 9NE le 08 nov. 2016

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Victoria Kathleen Louise Good en tant que directeur le 07 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Oliver Liam O'callaghan-Brown en tant que directeur le 07 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Patricia Mary Brown en tant que directeur le 07 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Patricia Mary Brown en tant que secrétaire le 07 nov. 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Ms Alison Ware en tant que secrétaire le 07 nov. 2016

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr John Patrick Mcconville en tant qu'administrateur le 07 nov. 2016

    2 pagesAP01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 20 oct. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Philip Joseph Brown en tant que directeur le 23 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 nov. 2015

    État du capital au 02 nov. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 oct. 2014

    État du capital au 24 oct. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 19 Craven Street London WC2N 5PB United Kingdom à 13 Craven Street London WC2N 5PB

    1 pagesAD02

    Qui sont les dirigeants de BRETTS (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WARE, Alison
    Sutton Road
    ME15 9NE Maidstone
    Parkwood
    England
    Secrétaire
    Sutton Road
    ME15 9NE Maidstone
    Parkwood
    England
    218048310001
    MCCONVILLE, John Patrick
    40 Hillydeal Road
    Otford
    TN14 5RU Sevenoaks
    The Old Pump House
    England
    Administrateur
    40 Hillydeal Road
    Otford
    TN14 5RU Sevenoaks
    The Old Pump House
    England
    EnglandBritish214500770001
    BROWN, Patricia Mary
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston Upon Thames
    Warren House
    Surrey
    Secrétaire
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston Upon Thames
    Warren House
    Surrey
    British3829080005
    RODWELL, Elizabeth Jane
    Stonybank 87 The Street
    Crowmarsh Gifford
    OX10 8EF Wallingford
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Stonybank 87 The Street
    Crowmarsh Gifford
    OX10 8EF Wallingford
    Oxfordshire
    British43519180002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BROWN, Patricia Mary
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston Upon Thames
    Warren House
    Surrey
    Administrateur
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston Upon Thames
    Warren House
    Surrey
    EnglandBritish3829080005
    BROWN, Philip Joseph, Dr
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston Upon Thames
    Warren House
    Surrey
    Administrateur
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston Upon Thames
    Warren House
    Surrey
    EnglandBritish99033870001
    GOOD, Victoria Kathleen Louise
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston Upon Thames
    Warren House
    Surrey
    Administrateur
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston Upon Thames
    Warren House
    Surrey
    EnglandBritish188389200001
    O'CALLAGHAN-BROWN, Oliver Liam
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston Upon Thames
    Warren House
    Surrey
    Administrateur
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston Upon Thames
    Warren House
    Surrey
    EnglandBritish191308240001
    RODWELL, Elizabeth Jane
    Stonybank 87 The Street
    Crowmarsh Gifford
    OX10 8EF Wallingford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Stonybank 87 The Street
    Crowmarsh Gifford
    OX10 8EF Wallingford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish43519180002
    RODWELL, Paul Robert
    87 The Street
    Crowmarsh Gifford
    OX10 8EF Wallingford
    Oxfordshire
    Administrateur
    87 The Street
    Crowmarsh Gifford
    OX10 8EF Wallingford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish53895920001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BRETTS (HOLDINGS) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Sutton Road
    ME15 9NE Maidstone
    Parkwood
    England
    07 nov. 2016
    Sutton Road
    ME15 9NE Maidstone
    Parkwood
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEnglish Law
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05246907
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Mrs Patricia Mary Brown
    Sutton Road
    ME15 9NE Maidstone
    Parkwood
    England
    06 avr. 2016
    Sutton Road
    ME15 9NE Maidstone
    Parkwood
    England
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Dr Philip Joseph Brown
    Sutton Road
    ME15 9NE Maidstone
    Parkwood
    England
    06 avr. 2016
    Sutton Road
    ME15 9NE Maidstone
    Parkwood
    England
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.

    BRETTS (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 06 août 2008
    Livré le 14 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the interest in the account.
    Personnes ayant droit
    • Michael Philip Wentworth and Paul John Wentworth
    Transactions
    • 14 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 06 août 2008
    Livré le 12 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    25C high street stanford in the vale faringdon, by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 30 sept. 2004
    Livré le 02 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2-3 high street ashley heath ringwood. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 08 nov. 2000
    Livré le 16 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 11 & 12 millbrook square grove wantage oxfordshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 29 sept. 2000
    Livré le 05 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 10 juil. 1997
    Livré le 31 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 31 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0