STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED

STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société 03065012
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Commerce House
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2023

    Quels sont les derniers dépôts pour STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mai 2023

    9 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2023 au 31 mai 2023

    1 pagesAA01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2022

    9 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Business Innovation Centre Studio 10 Sutherland Institute Lightwood Road Longton Stoke-on-Trent ST3 4HY United Kingdom à Commerce House Etruria Stoke-on-Trent ST1 5BE le 03 août 2022

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2021

    9 pagesAA

    Cessation de la nomination de Kevin Lee Taylor en tant que directeur le 02 sept. 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 02 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2020

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Jonathan Robert Andrew en tant que directeur le 18 févr. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Kevin Lee Taylor en tant qu'administrateur le 06 août 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 06 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2019

    8 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Rebekah Herschel Shenton le 18 août 2018

    2 pagesCH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2018

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Business Innovation Centre Staffordshire Technology Park Beaconside Stafford ST18 0AR à Business Innovation Centre Studio 10 Sutherland Institute Lightwood Road Longton Stoke-on-Trent ST3 4HY le 15 nov. 2017

    1 pagesAD01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2017

    10 pagesAA

    Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif

    2 pagesPSC08

    Qui sont les dirigeants de STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    K & S SECRETARIES LIMITED
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle
    The Brampton
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle
    The Brampton
    Staffordshire
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement02795473
    114754200001
    BRIGGS, Andrew
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Administrateur
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    United KingdomBritish163842990001
    FRANCIS, John Stuart
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Administrateur
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    United KingdomBritish40524300001
    HARPER, Rebekah Herschel
    Studio 10 Sutherland Institute
    Lightwood Road
    ST3 4HY Longton
    Business Innovation Centre
    Stoke-On-Trent
    United Kingdom
    Administrateur
    Studio 10 Sutherland Institute
    Lightwood Road
    ST3 4HY Longton
    Business Innovation Centre
    Stoke-On-Trent
    United Kingdom
    United KingdomBritish111618580004
    KELSALL, Eric
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Administrateur
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    United KingdomBritish99415580001
    KELSALL, Rachel Louise
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Administrateur
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    EnglandBritish190000760001
    MORRIS, Paul Jonathan
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Administrateur
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    United KingdomBritish151623600001
    PEARCE, Anthony Norman, Councellor
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Administrateur
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    United KingdomBritish65400220002
    RILEY, Geoffrey
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Administrateur
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    EnglandBritish133180130001
    BIRD, James Christopher Michael
    8 Allen Street
    ST4 7NP Stoke On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    8 Allen Street
    ST4 7NP Stoke On Trent
    Staffordshire
    British63447900002
    MILLER, Derek John
    6 Sidmouth Avenue
    ST5 0QN Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Secrétaire
    6 Sidmouth Avenue
    ST5 0QN Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British37920530001
    PRICE, Sebastian
    The Hawthorns Cherry Tree Lane
    Woore
    CW3 9SR Crewe
    Cheshire
    Secrétaire
    The Hawthorns Cherry Tree Lane
    Woore
    CW3 9SR Crewe
    Cheshire
    British68818870001
    QUIRK, Cindy Ann
    Ardencote
    New Street Lane
    TF9 3RN Market Drayton
    Salop
    Secrétaire
    Ardencote
    New Street Lane
    TF9 3RN Market Drayton
    Salop
    British46098140002
    K&S DIRECTORS LIMITED
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Secrétaire
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    97199250001
    ANDERSON, Sarah, Dr
    64 Heathend Road
    Alsager
    ST7 2SH Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    64 Heathend Road
    Alsager
    ST7 2SH Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish19798790001
    ANDREW, Jonathan Robert
    Studio 10 Sutherland Institute
    Lightwood Road
    ST3 4HY Longton
    Business Innovation Centre
    Stoke-On-Trent
    United Kingdom
    Administrateur
    Studio 10 Sutherland Institute
    Lightwood Road
    ST3 4HY Longton
    Business Innovation Centre
    Stoke-On-Trent
    United Kingdom
    United KingdomBritish64082380001
    ASTON, Ronald
    Fox House Tythe Barn
    Alton
    ST10 4AZ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Fox House Tythe Barn
    Alton
    ST10 4AZ Stoke On Trent
    Staffordshire
    British43668490001
    BIRD, James Christopher Michael
    8 Allen Street
    ST4 7NP Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    8 Allen Street
    ST4 7NP Stoke On Trent
    Staffordshire
    British63447900002
    BLAKE, David
    17 Canalside Close
    ST19 5TX Penkridge
    Staffordshire
    Administrateur
    17 Canalside Close
    ST19 5TX Penkridge
    Staffordshire
    British57941390002
    BODEN, Philip Keeling
    2 Jonathan Road
    ST4 8LP Stoke On Trent
    Administrateur
    2 Jonathan Road
    ST4 8LP Stoke On Trent
    British34859400001
    BOOTH, Sandra
    Margaret Street
    ST15 8EL Stone
    16 Reliant House
    Staffordshire
    Administrateur
    Margaret Street
    ST15 8EL Stone
    16 Reliant House
    Staffordshire
    UkBritish146050960001
    BURNS, Stephen James
    32 Raleigh Close
    Old Hall
    WA5 5QS Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    32 Raleigh Close
    Old Hall
    WA5 5QS Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish174030900001
    CLARK, Graham Roger
    5 Horsefair
    Eccleshall
    ST21 6AA Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    5 Horsefair
    Eccleshall
    ST21 6AA Stafford
    Staffordshire
    British57392030001
    COOPER, Alan John, Dr
    146 Stubby Lane
    Wednesfield
    WV11 3NF Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    146 Stubby Lane
    Wednesfield
    WV11 3NF Wolverhampton
    West Midlands
    British32145970001
    DAIN, John Stewart
    32 Captains Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8EZ Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    32 Captains Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8EZ Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish7028540001
    DRYER, John Richard
    College Road
    ST4 2DE Stoke-On-Trent
    Staffordshire University
    Staffordshire
    England
    Administrateur
    College Road
    ST4 2DE Stoke-On-Trent
    Staffordshire University
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish193362300001
    FELTBOWER, Geoffrey Howard
    28 Megacre
    Bignall End
    ST7 8PA Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    28 Megacre
    Bignall End
    ST7 8PA Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish57392150002
    GALLAGHER, Rosalind
    Milestone Cottage
    15 Nantwich Road, Woore
    CW3 9SB Crewe
    Cheshire
    Administrateur
    Milestone Cottage
    15 Nantwich Road, Woore
    CW3 9SB Crewe
    Cheshire
    British74980860001
    GRANT, John Victor
    60 Cannock Road
    ST17 0QQ Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    60 Cannock Road
    ST17 0QQ Stafford
    Staffordshire
    British65880600001
    HEERAN, Mark Michael
    Tixall Road
    Littleworth
    ST16 3UY Stafford
    91
    Staffordshire
    Administrateur
    Tixall Road
    Littleworth
    ST16 3UY Stafford
    91
    Staffordshire
    United KingdomBritish147619080001
    HENSON, Ronald Michael, Dr
    11 Weeping Cross
    ST17 0DF Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    11 Weeping Cross
    ST17 0DF Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritish10023600001
    JACKSON, Stuart Malcolm
    21 The Brambles
    Westbury Park Clayton
    ST5 4JJ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Administrateur
    21 The Brambles
    Westbury Park Clayton
    ST5 4JJ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    United KingdomBritish79731380001
    LYNCH, David Ross
    The Outlands Bishops Offley
    Eccleshall
    ST21 6HB Stafford
    Staffs
    Administrateur
    The Outlands Bishops Offley
    Eccleshall
    ST21 6HB Stafford
    Staffs
    United KingdomBritish111260170001
    MABEY, Mark, Dr
    2 Leadbeater Avenue
    Penghull
    ST4 5HE Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    2 Leadbeater Avenue
    Penghull
    ST4 5HE Stoke On Trent
    Staffordshire
    British115823450001
    MATHER, David
    35 Pack Horse Road
    Melbourne
    DE73 8EG Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    35 Pack Horse Road
    Melbourne
    DE73 8EG Derby
    Derbyshire
    British120208940001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    06 avr. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 26 sept. 2002
    Livré le 17 oct. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 17 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0