DEANWATER ESTATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDEANWATER ESTATES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03065400
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DEANWATER ESTATES LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe DEANWATER ESTATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DEANWATER ESTATES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GOOCH WEBSTER LIMITED01 mai 199801 mai 1998
    J TREVOR & WEBSTER LIMITED24 oct. 199524 oct. 1995
    CONTINENTAL SHELF 27 LIMITED07 juin 199507 juin 1995

    Quels sont les derniers comptes de DEANWATER ESTATES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour DEANWATER ESTATES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour DEANWATER ESTATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    20 pages4.72

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 09 avr. 2013

    31 pages2.24B

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 avr. 2014

    21 pages4.68

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 27 mars 2013

    31 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 27 sept. 2012

    30 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 27 sept. 2012

    30 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 27 sept. 2012

    27 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 27 sept. 2012

    28 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    legacy

    3 pagesMG04

    Cessation de la nomination de Mark Sample en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Mcfarlane en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    59 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B/2.15B

    8 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de * 9 Marylebone Lane London W1U 1HL* le 04 avr. 2012

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 mai 2011

    État du capital au 17 mai 2011

    • Capital: GBP 500,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    12 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Izett en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mark John Sample le 28 mai 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew James Mcfarlane le 28 mai 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de DEANWATER ESTATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GOLDSOBEL, Howard
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Secrétaire
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    British57132180002
    ASHBY, Anthony Clifford
    1 Thirlmere Gardens
    HA6 2RS Northwood
    Middlesex
    Secrétaire
    1 Thirlmere Gardens
    HA6 2RS Northwood
    Middlesex
    British51998620001
    HICKEY, Teritia Josine
    92 Churchbury Road
    Eltham
    SE9 5HZ London
    Secrétaire
    92 Churchbury Road
    Eltham
    SE9 5HZ London
    British76847670001
    KING, Andrew Peter
    26 Chivalry Road
    SW11 1HT London
    Secrétaire
    26 Chivalry Road
    SW11 1HT London
    British120550750001
    LEWIS, Thomas Frederick
    25 South View Drive
    E18 1NP London
    Secrétaire
    25 South View Drive
    E18 1NP London
    British119917290001
    MCGREAL, Anne
    Flat 3 63/71 Rye Hill Park
    SE15 3JR London
    Secrétaire
    Flat 3 63/71 Rye Hill Park
    SE15 3JR London
    British49118810001
    RUTTER, John Maddern
    Watermill Farm
    Hazel End
    CM24 8TP Stansted
    Essex
    Secrétaire
    Watermill Farm
    Hazel End
    CM24 8TP Stansted
    Essex
    British84226060001
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Secrétaire désigné
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001
    BELL, Michael Hugh
    72 Church Road
    GU51 4LY Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    72 Church Road
    GU51 4LY Fleet
    Hampshire
    British90062470002
    DOYLE, David Colin
    96 Northchurch Road
    N1 3NY London
    Administrateur
    96 Northchurch Road
    N1 3NY London
    Australian115366000001
    GRAHAM, Andrew Barry
    10 Mulberry Walk
    SW3 6DY London
    Administrateur
    10 Mulberry Walk
    SW3 6DY London
    United KingdomBritish1788740001
    IZETT, David Stewart
    9 Marylebone Lane
    London
    W1U 1HL
    Administrateur
    9 Marylebone Lane
    London
    W1U 1HL
    United KingdomBritish88030400001
    IZETT, David Stewart
    2 Vicarage Drive
    SW18 8RX London
    Administrateur
    2 Vicarage Drive
    SW18 8RX London
    United KingdomBritish88030400001
    KELLY, Alastair William
    6 Penrith Avenue
    G46 6LU Giffnock
    Administrateur
    6 Penrith Avenue
    G46 6LU Giffnock
    British79163740001
    KIDD, Timothy Guy
    52 Orbel Street
    SW11 3NZ London
    Administrateur
    52 Orbel Street
    SW11 3NZ London
    British9401710001
    LEWIS, Thomas Frederick
    25 South View Drive
    E18 1NP London
    Administrateur
    25 South View Drive
    E18 1NP London
    United KingdomBritish119917290001
    LIVINGSTON, James Fraser
    8 Clairmont Gardens
    Kelvingrove
    G3 7LW Glasgow
    Administrateur
    8 Clairmont Gardens
    Kelvingrove
    G3 7LW Glasgow
    British31010002
    MASON, Lesley Jane
    Russet House
    1 The Paddock
    GU7 1XD Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Russet House
    1 The Paddock
    GU7 1XD Godalming
    Surrey
    British69080370001
    MCFARLANE, Andrew James
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritish39119700005
    MCGREAL, Anne
    Flat 3 63/71 Rye Hill Park
    SE15 3JR London
    Administrateur
    Flat 3 63/71 Rye Hill Park
    SE15 3JR London
    British49118810001
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    17 Greenfield Drive
    Fortes Green
    N2 9AF London
    Administrateur
    17 Greenfield Drive
    Fortes Green
    N2 9AF London
    EnglandBritish46176700002
    PHILLIPS, John Denis
    66 Hayes Hill
    Hayes
    BR2 7HW Bromley
    Kent
    Administrateur
    66 Hayes Hill
    Hayes
    BR2 7HW Bromley
    Kent
    Other9401720001
    PHILLIPS, John Denis
    66 Hayes Hill
    Hayes
    BR2 7HW Bromley
    Kent
    Administrateur
    66 Hayes Hill
    Hayes
    BR2 7HW Bromley
    Kent
    Other9401720001
    REES, Nicholas Guest
    22 Birchitt Road
    Broadway
    S17 4QP Sheffield
    Administrateur
    22 Birchitt Road
    Broadway
    S17 4QP Sheffield
    EnglandBritish47111320001
    ROBERTS, Michael John
    89 Clapham Manor Street
    SW4 6DR London
    Administrateur
    89 Clapham Manor Street
    SW4 6DR London
    British58382400001
    RUTTER, John Maddern
    Watermill Farm
    Hazel End
    CM24 8TP Stansted
    Essex
    Administrateur
    Watermill Farm
    Hazel End
    CM24 8TP Stansted
    Essex
    EnglandBritish84226060001
    SAMPLE, Mark John
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritish38199850001
    STYLES, Gregory Sean
    2 The Croft
    Collingham
    LS22 5LG Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    2 The Croft
    Collingham
    LS22 5LG Wetherby
    West Yorkshire
    British79163440001
    TIDY, Thomas Peter
    24 Handel Mansions
    94 Wyatt Drive
    SW13 8AH London
    Administrateur
    24 Handel Mansions
    94 Wyatt Drive
    SW13 8AH London
    United KingdomBritish141619610001
    MD DIRECTORS LIMITED
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    Administrateur désigné
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    900005100001

    DEANWATER ESTATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 02 avr. 2009
    Livré le 09 avr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Assignment in security
    Créé le 03 mars 2003
    Livré le 19 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from fitzhardinge PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights titles benefits and interests of the company whatsoever present and future under or arising out of or evidenced by the secured property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assingment in security
    Créé le 03 mars 2003
    Livré le 19 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from fitzhardinge PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Rights title benefits and interests of the company whatsoever present and future under or arising out of or evidenced by the secured property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 03 mars 2003
    Livré le 19 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from fitzhardinge PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All securities and their proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 03 mars 2003
    Livré le 19 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or fitzhardinge PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All securities and their proceeds of sale. All dividends interest and other distributions (whether in cash or in specie and whether of a capital or income nature) declared, paid or made in respect of the securities at any time, all accretions rights benefits money or property accruing issued or offered in respect of the securities at any time whether by way of rights bonus capitalisation conversion exchange pre-emption rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 déc. 2001
    Livré le 27 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 11 december 2000 and
    Créé le 04 avr. 2000
    Livré le 20 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property known as unit 1 shawbridge street industrial estate, shawbridge street glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 20 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 11TH december 2000
    Créé le 04 avr. 2000
    Livré le 16 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Two rubislaw place aberdeen. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 16 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Subordination deed
    Créé le 07 mai 1999
    Livré le 20 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future sums liabilities and obligations of hackremco (no.1462) limited (as "borrower") to the bank arising under or in connection with the senior credit agreement and the other finance documents
    Brèves mentions
    If any amount of subordinated liabilities is discharged by payment repayment prepayment set-off or in any other manner in contravention of clauses 2.1.1 , 3.2 or 5.2 of the deed the company hall save for permitted payment hold the amount received on trust for the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Depfa Bank Ag
    Transactions
    • 20 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Subordination deed
    Créé le 07 mai 1999
    Livré le 19 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future sums liabilities and obligations due or to become due from hackremco (no.1462) limited (the "borrower") to the chargee (the "lender") arising under or in connection with the senior credit agreement (as defined) and the other finance documents (as defined) (the "senior liabilities")
    Brèves mentions
    If any amount of subordinated liabilities is discharged by payment repayment prepayment set-off or in any other manner in contravention of clauses 2.1.1. 3.2, or 5.2 of the subordination deed the company shall save for permitted payments hold the amount received on trust for the lender. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mable Commercial Funding Limited
    Transactions
    • 19 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of shares between,inter alia, the company, lehman brothers holdings PLC, stainton international limited and knights valley limited (the "obligors") and depfa ag, london branch (the "bank")
    Créé le 07 mai 1999
    Livré le 20 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the obligors or any other party to a finance document to the chargee under the terms of any of the finance documents
    Brèves mentions
    First fixed charge over the company's charged assets being all shares and derivative assets and undertakings and includes all rights benefits and sums now or in future accruing to the company in respect of the shares and derivative assets and undertakings and in respect of the company the charged assets are shares owned by the company in respect of the charge and all derivative assets undertakings rights benefits and sums accruing to the company in respect of the shares and derivative assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Depfa Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 20 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 juil. 1996
    Livré le 15 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cgf No 9 Limited
    Transactions
    • 15 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 avr. 1996
    Livré le 16 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 16 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 10 mai 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 16 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    DEANWATER ESTATES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 mars 2012Administration started
    09 avr. 2013Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Lee Antony Manning
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    2
    DateType
    11 sept. 2015Dissolved on
    09 avr. 2013Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    practitioner
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Lee Antony Manning
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0